Buscador CIF Logo

Actos BORME Division De Mantenimiento Tremon Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Division De Mantenimiento Tremon Sl

Actos BORME Division De Mantenimiento Tremon Sl - B96818190

Tenemos registrados 46 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Division De Mantenimiento Tremon Sl con CIF B96818190

馃敊 Perfil de Division De Mantenimiento Tremon Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Division De Mantenimiento Tremon Sl

03 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: LILLO LOPEZ ALFREDO. Datos registrales. T 11292, L 8570, F 94, S 8, H V 63293, I/A 50 (25.10.23).

Modificaci贸n de poderes. Apo.Man.Soli: PIN GIMENO JESUS. Datos registrales. T 11292, L 8570, F 94, S 8, H V 63293, I/A 51(25.10.23).

30 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ DEL ALAMO JOSE LUIS;NIETO MILLAN JOSE MANUEL;PIN GIMENO JESUS;RODRIGUEZFERNANDEZ MARTA;ROSADO CANTERO JUAN CANDIDO;VELERDA HERRERO MONICA;TODO COLMENARESFERNANDO;PIN GIMENO JESUS. Apoderado: MARTIN FRAILE LUIS. Apo.Sol.: FERNANDEZ LOPEZ VICTOR. Apo.Man.Soli:RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA. Datos registrales. T 11292, L 8570, F 94, S 8,H V 63293, I/A 49 (23.10.23).

30 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BALDELLOU GARCIA ANTONIO;BALDELLOU GARCIA ANTONIO. Apoderado: VISCHI FILIPPO.Apo.Man.Soli: GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER;DOS SANTOS PAIAS DIOGO MANUEL;BRAGADO SAINZ DE LA MAZACRISTINA. Datos registrales. T 11292, L 8570, F 91, S 8, H V 63293, I/A 42 (22.03.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DICKHOFF JEROEN CHRISTIAAN FRANCISCUS;ORTEGA CALVO RUBEN;RODRIGUEZ PINOJAVIER;SANCHEZ BLANCO LUIS JAVIER;VIDAECHEA MONTES AITOR. Datos registrales. T 11292, L 8570, F 92, S 8, H V 63293,I/A 43 (22.03.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTEGA CALVO RUBEN;GUISADO AREVALO GRETA. Datos registrales. T 11292, L 8570, F 92,S 8, H V 63293, I/A 44 (22.03.23).

Modificaci贸n de poderes. Apo.Man.Soli: SANCHIS FERRANDO SALVADOR. Datos registrales. T 11292, L 8570, F 92, S 8, H V63293, I/A 45 (22.03.23).

Modificaci贸n de poderes. Apo.Man.Soli: SANCHIS FERRANDO SALVADOR. Datos registrales. T 11292, L 8570, F 92, S 8, H V63293, I/A 46 (22.03.23).

01 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: NIETO MILLAN JOSE MANUEL;PIN GIMENO JESUS;LOPEZ BARCELO LUIS. Nombramientos.Apo.Man.Soli: NIETO MILLAN JOSE MANUEL;BAZ VALIENTE GEMMA;PASCUAL HORAS MARIA CRISTINA. Datos registrales. T7312, L 4614, F 154, S 8, H V 63293, I/A 41 (25.01.23).

03 de Enero de 2023
Nombramientos. Apoderado: CIUDAD ABADIA BEATRIZ. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 153, S 8, H V 63293, I/A 37(27.12.22).

Nombramientos. Apoderado: VISCHI FILIPPO;RODRIGUEZ JIMENEZ ANA MARIA. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 153, S 8,H V 63293, I/A 38 (27.12.22).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ JIMENEZ ANA MARIA. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 153, S 8, H V 63293, I/A 39(27.12.22).

Nombramientos. Apoderado: SANMARTIN MARCOS RUBEN;CARRASCO PEREZ EVA MARIA. Datos registrales. T 7312, L 4614,F 154, S 8, H V 63293, I/A 40 (27.12.22).

29 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: IZQUIERDO DELGADO DAVID ANTONIO. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 151, S 8, H V 63293,I/A 30 (21.12.22).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: NAVASCUES INDIA PEDRO JOSE. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 151, S 8, H V 63293, I/A 31(21.12.22).

Nombramientos. Apoderado: NIETO MILLAN ENRIQUE;MONTERO MU脩OZ JOSE JAVIER. Datos registrales. T 7312, L 4614, F152, S 8, H V 63293, I/A 32 (21.12.22).

Nombramientos. Apoderado: ARANDA GUTIERREZ JAVIER;RODRIGUEZ JIMENEZ ANA MARIA. Datos registrales. T 7312, L4614, F 152, S 8, H V 63293, I/A 33 (21.12.22).

Nombramientos. Apoderado: ARANDA GUTIERREZ JAVIER;RODRIGUEZ JIMENEZ ANA MARIA. Datos registrales. T 7312, L4614, F 152, S 8, H V 63293, I/A 34 (21.12.22).

Nombramientos. Apoderado: PASCUAL HORAS MARIA CRISTINA;QUESADA GONZALEZ JOSE MIGUEL;CIUDAD ABADIABEATRIZ. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 152, S 8, H V 63293, I/A 35 (21.12.22).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: LILLO GOMEZ ALFREDO;LILLO GOMEZ ALFREDO. Apoderado: CIUDAD ABADIA BEATRIZ.

30 de Marzo de 2022
Nombramientos. Consejero: NIETO MILLAN JOSE MANUEL;PASCUAL HORAS MARIA CRISTINA;SANCHIS FERRANDOSALVADOR.Presidente: NIETO MILLAN JOSE MANUEL. Secretario: PASCUAL HORAS MARIA CRISTINA. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 7312, L4614, F 151, S 8, H V 63293, I/A 28 (22.03.22).

Nombramientos. Apoderado: CIUDAD ABADIA BEATRIZ. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 151, S 8, H V 63293, I/A 29(22.03.22).

30 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: NAVASCUES INDIA PEDRO JOSE;SANCHIS FERRANDO SALVADOR. Datos registrales. T7312, L 4614, F 150, S 8, H V 63293, I/A 27 (23.06.21).

08 de Febrero de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ RICO SERGIO;SANCHEZ BLANCO LUIS JAVIER. Datos registrales. T 7312, L 4614, F150, S 8, H V 63293, I/A 24 ( 1.02.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BAZ VALIENTE GEMA. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 150, S 8, H V 63293, I/A 25 ( 1.02.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BAZ VALIENTE GEMA;DOS SANTOS PAIAS DIOGO MANUEL. Datos registrales. T 7312, L 4614,F 150, S 8, H V 63293, I/A 26 ( 1.02.21).

14 de Octubre de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CASAS CASTILLO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 149, S 8, H V 63293, I/A 23( 6.10.20).

20 de Agosto de 2020
Otros conceptos: Rectificaci贸n de la inscripci贸n 9陋 de la sociedad por la 22陋, en el sentido de haber identificado err贸neamente a unapoderado en el orden de sus apellidos, por parte de la sociedad, siendo el orden correcto de sus apellidos, don Davide PezzelaV谩zquez. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 149, S 8, H V 63293, I/A 22 (13.08.20).

12 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: QUESADA GONZALEZ JOSE MIGUEL;PASCUAL HORAS MARIA CRISTINA. Datos registrales. T

Nombramientos. Apoderado: QUESADA GONZALEZ JOSE MIGUEL;PASCUAL HORAS MARIA CRISTINA. Datos registrales. T7312, L 4614, F 148, S 8, H V 63293, I/A 20 ( 5.08.20).

Nombramientos. Apoderado: PASCUAL HORAS MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 148, S 8, H V 63293, I/A21 ( 5.08.20).

16 de Abril de 2020
Modificaci贸n de poderes. Apo.Man.Soli: NAVASCUES INDIA PEDRO JOSE. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 148, S 8, H V63293, I/A 17 ( 7.04.20).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: NAVASCUES INDIA PEDRO JOSE. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 148, S 8, H V 63293, I/A 16( 7.04.20).

Nombramientos. Apoderado: MATAIX ROMERO TADEO;MARTIN FRAILE LUIS. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 148, S 8, H V63293, I/A 18 ( 7.04.20).

21 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ANTUNES FRANCO CARLOS ALBERTO. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 148, S 8, H V 63293,I/A 14 (14.02.20).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS DIEZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 148, S 8, H V 63293, I/A 15(14.02.20).

10 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: TOLEDO MORCUENDE CAROLINA. Datos registrales. T 7312, L 4614, F 148, S 8, H V 63293, I/A 13( 3.02.20).

13 de Agosto de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NIETO MILLAN JOSE MANUEL;PIN GIMENO JESUS;GARCIA GARCIA FRANCISCOJAVIER;RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA;ROSADO CANTERO JUAN CANDIDO;VELERDA HERRERO MONICA;TODOCOLMENARES FERNANDO;GOMEZ DEL ALAMO JOSE LUIS. Datos registrales. T 6219, L 3524, F 139, S 8, H V 63293, I/A 10 (6.08.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: NIETO MILLAN JOSE MANUEL;MOLINA PULIDO ARANTZAZU;LOPEZ BARCELOLUIS;NAVASCUES INDIA PEDRO JOSE;FIGAL MA脩AS ALFREDO;SANCHIS FERRANDO SALVADOR;PIN GIMENOJESUS;BALDELLOU GARCIA ANTONIO;LILLO GOMEZ ALFREDO;JIMENEZ LOPEZ MANUEL;CASAS CASTILLO JOSEANTONIO;FERNANDEZ CAZALLAS JUAN CARLOS;LEGAZ GASCON JAVIER;GONZALEZ RUIZ CARLOS IGNACIO;CASTA脩OFALAGAN SERGIO;BRAGADO SAINZ DE LA MAZA CRISTINA. Datos registrales. T 6219, L 3524, F 140, S 8, H V 63293, I/A 11 (6.08.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: MINGO MELERO ICIAR;FANLO MATIA FRANCISCO JAVIER;BLANCO DURAN JORGE;FERNANDEZLOPEZ VICTOR. Datos registrales. T 6219, L 3524, F 140, S 8, H V 63293, I/A 12 ( 6.08.19).

09 de Agosto de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NIETO MILLAN JOSE MANUEL;MOLINA PULIDO ARANTZAZU;LOPEZ BARCELOLUIS;NAVASCUES INDIA PEDRO JOSE;FIGAL MA脩AS ALFREDO;SANCHIS FERRANDO SALVADOR;PIN GIMENOJESUS;BALDELLOU GARCIA ANTONIO;JIMENEZ LOPEZ MANUEL;SANCHEZ BLANCO LUIS JAVIER;RAMOS RUIZALFREDO;CUBEIRO GONZALEZ ALMUDENA;VARELA PEREZ MARIA JOSE;SANZ CARBONELL BEATRIZ MARIA;CASASCASTILLO JOSE ANTONIO;FERNANDEZ CAZALLAS JUAN CARLOS;GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER;LEGAZ GASCONJAVIER;MINGO MELERO ICIAR;BARCA FERNANDEZ LUIS;CAMEANS PAYNO MARTA;GONZALEZ RICO SERGIO;ANTUNESFRANCO CARLOS ALBERTO;TORIBIO GALAN MIGUEL;LILLO GOMEZ ALFREDO;SANTOS DIEZ MARIA JOSE;RODRIGUEZFERNANDEZ MARTA;ROSADO CANTERO JUAN CANDIDO;VELERDA HERRERO MONICA;TODO COLMENARESFERNANDO;GOMEZ DEL ALAMO JOSE LUIS;MAZCU脩AN CENALMOR DAVID;VAZQUEZ PEZZELLA DAVIDE. Datos registrales.T 6219, L 3524, F 137, S 8, H V 63293, I/A 9 ( 2.08.19).

11 de Julio de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PIN GIMENO JESUS;NIETO MILLAN JOSE MANUEL;LOPEZ BARCELO LUIS. Datos registrales.T 6219, L 3524, F 136, S 8, H V 63293, I/A 8 ( 4.07.19).

05 de Julio de 2019
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SCHINDLER SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PARDO SANCHIS ADRIANFRANCISCO;TALENS CANET LARA. Nombramientos. Adm. Mancom.: NAVASCUES INDIA PEDRO JOSE;SANCHIS FERRANDOSALVADOR. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administradoresmancomunados. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de domiciliosocial. C/ MARIANO BENLLIURE 43 BAJO (CARCAIXENT). P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.tremon.es. Datos registrales. T 6219, L 3524, F 132, S 8, H V 63293, I/A 7 (27.06.19).

31 de Enero de 2019
Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: ADBROWN RENTALS, S.L. Datos registrales. T 6219, L 3524, F 132, S8, H V 63293, I/A 6 (24.01.19).

13 de Junio de 2017
Cambio de objeto social. El montaje e instalaci贸n, as铆 como el mantenimiento, reparaci贸n y conservaci贸n de aparatos elevadores decualquier clase y tipo, la carpinter铆a met谩lica y soldaduras. Promoci贸n Inmobiliaria. Construcci贸n de edificios residenciales y proyectosde ingenier铆a civil. Instalaciones en obras de construcci. Datos registrales. T 6219, L 3524, F 132, S 8, H V 63293, I/A 5 ( 6.06.17).

08 de Febrero de 2011
Cambio de domicilio social. C/ MARIANO BENLLIURE 43 BAJO (CARCAIXENT). Datos registrales. T 6219, L 3524, F 132, S 8, HV 63293, I/A 4 (28.01.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n