Actos BORME de Division Industrial Artisteril Sa
15 de Febrero de 2021Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: GOMEZ ESTEBAN SERGIO;GOMEZ GAMAZO ANGEL. Datos registrales. T 26253 , F 11, S 8,H B 100727, I/A 12 ( 5.02.21).
31 de Enero de 2018Revocaciones. AUDIT.ART265: A1 & GAVIA AUVAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 26253 , F 10, S 8, H B 100727, I/A 11(23.01.18).
19 de Diciembre de 2017Cambio de domicilio social. CL PLASTIC Num.10 (BADALONA). Datos registrales. T 26253 , F 10, S 8, H B 100727, I/A 10(30.11.17).
24 de Octubre de 2017Nombramientos. AUDIT.ART265: A1 & GAVIA AUVAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 26253 , F 10, S 8, H B 100727, I/A 9(16.10.17).
10 de Noviembre de 2016Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: COSTA MORENO OSCAR. Datos registrales. T 26253 , F 10, S 8, H B 100727, I/A 8 (28.10.16).
21 de Diciembre de 2015Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: GOMEZ GAMAZO ANGEL;COSTA MORENO OSCAR;GOMEZ ESTEBAN SERGIO.Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9: ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T26253 , F 10, S 8, H B 100727, I/A 7 ( 9.12.15).
23 de Diciembre de 2010Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: COSTA RABASA ANTONIO;GOMEZ GAMAZO ANGEL. Nombramientos. ADM.UNICO: GOMEZGAMAZO ANGEL. Datos registrales. T 26253 , F 9, S 8, H B 100727, I/A 6 (13.12.10).