Actos BORME de Division Negocios Reunidos Sl
14 de Agosto de 2023Nombramientos. APODERAD.SOL: CALVACHE MARTINEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 31079 , F 152, S 8, H B185996, I/A 14 ( 4.08.23).
01 de Agosto de 2023Revocaciones. ADM.UNICO: BUXADERA GOMEZ ENRIC. Nombramientos. ADM.UNICO: MIQUEL ROCA JORDI. Datosregistrales. T 31079 , F 152, S 8, H B 185996, I/A 13 (24.07.23).
25 de Agosto de 2021Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: JULIA GELABERT JUAN;BUXADERA GOMEZ ENRIC. Nombramientos. ADM.UNICO:BUXADERA GOMEZ ENRIC. Datos registrales. T 31079 , F 152, S 8, H B 185996, I/A 12 (17.08.21).
23 de Marzo de 2021Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: PORTALES CAPDEVILA JORDI. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: BUXADERA GOMEZ ENRIC.Datos registrales. T 31079 , F 152, S 8, H B 185996, I/A 11 (12.03.21).
12 de Junio de 2019Revocaciones. ADM.UNICO: PORTALES CAPDEVILA JORDI. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: PORTALES CAPDEVILAJORDI;JULIA GELABERT JUAN. Datos registrales. T 31079 , F 151, S 8, H B 185996, I/A 10 ( 4.06.19).
12 de Abril de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5,06 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:102.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 105.000,00 Euros. Datos registrales. T 31079 , F 151, S 8, H B 185996, I/A 9 ( 5.04.18).
04 de Septiembre de 2017Revocaciones. ADM.UNICO: PORTALES CAPDEVILA JORGE. Nombramientos. ADM.UNICO: PORTALES CAPDEVILA JORDI.Datos registrales. T 31079 , F 151, S 8, H B 185996, I/A 8 (25.08.17).
19 de Octubre de 2011Nombramientos. APODERADO: VILA ILLA XAVIER. Datos registrales. T 31079 , F 149, S 8, H B 185996, I/A 7 ( 6.10.11).
22 de Septiembre de 2011Revocaciones. APODERADO: CRESPO PERALTA FELIPE. Datos registrales. T 31079 , F 149, S 8, H B 185996, I/A 6 ( 9.09.11).
06 de Mayo de 2010Nombramientos. APODERADO: ROBLES ARSEDA LUIS. Datos registrales. T 31079 , F 148, S 8, H B 185996, I/A 5 (27.04.10).
30 de Junio de 2009Nombramientos. ADM.UNICO: PORTALES CAPDEVILA JORGE. Datos registrales. T 31079 , F 147, S 8, H B 185996, I/A 4(17.06.09).