Actos BORME de Documentacion E Imagen Del Noroeste Sl
10 de Septiembre de 2020Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 2668, L 2668, F 210, S 8, H PO 29290, I/A 20 ( 3.09.20).
16 de Junio de 2020Cambio de domicilio social. PLAZA DA VEIGA DA EIRA 1 E-2 Bl.D 1潞 - OFICINA 6 (PONTEVEDRA). Datos registrales. T 2668, L2668, F 210, S 8, H PO 29290, I/A 19 ( 8.06.20).
26 de Febrero de 2020Otros conceptos: Se INCLUYE un nuevo ARTICULO 10 BIS a los Estatutos Sociales relativo a la prenda de participaciones. Datosregistrales. T 2668, L 2668, F 210, S 8, H PO 29290, I/A 18 (18.02.20).
23 de Enero de 2020Nombramientos. Auditor: AUDITORES DE FINANZAS Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 2668, L 2668, F 137, S 8, H PO29290, I/A 17 (16.01.20).
23 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTES COMERCIAL TECNICA DE OFICINAS SL;GONZALEZ GONZALEZ MANUEL;VAZQUEZTOME VICTOR JOSE. Presidente: MONTES COMERCIAL TECNICA DE OFICINAS SL. Vicepresid.: GONZALEZ GONZALEZMANUEL. Secretario: VAZQUEZ TOME VICTOR JOSE. Nombramientos. Adm. Unico: GALLEGA DE AUTOMACION SL. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 2668, L2668, F 137, S 8, H PO 29290, I/A 16 (13.04.18).
05 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Apoderado: VAZQUEZ TOME VICTOR JOSE. Datos registrales. T 2668, L 2668, F 137, S 8, H PO 29290, I/A15 (26.03.18).
26 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 2668, L 2668, F 137, S 8, H PO 29290,I/A 14 (17.01.18).
04 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apoderado: RIVAS PINTOS MARIA JESUS. Datos registrales. T 2668, L 2668, F 136, S 8, H PO 29290, I/A 13(24.11.17).
20 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: MONTES COSTAS JOAQUIN. Datos registrales. T 2668, L 2668, F 135, S 8, H PO 29290, I/A 12(12.06.17).
03 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: RIVAS BAO MANUEL. Datos registrales. T 2668, L 2668, F 135, S 8, H PO 29290, I/A 11 (25.10.16).
03 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: VAZQUEZ TOME VICTOR JOSE. Datos registrales. T 2668, L 2668, F 133, S 8, H PO 29290,I/A 10 (26.05.16).
29 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ ALONSO ADRIAN. Datos registrales. T 2668, L 2668, F 133, S 8, H PO 29290, I/A 9(22.04.16).
05 de Enero de 2015Nombramientos. Auditor: AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 2668, L 2668, F 133, S 8, H PO29290, I/A 8 (24.12.14).
04 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTES OTERO JOAQUIN EUGENIO. Presidente: MONTES OTERO JOAQUIN EUGENIO.Nombramientos. Consejero: MONTES COMERCIAL TECNICA DE OFICINAS SL. Presidente: MONTES COMERCIAL TECNICA DEOFICINAS SL. Datos registrales. T 2668, L 2668, F 133, S 8, H PO 29290, I/A 6 (20.03.14).
20 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apoderado: PENAS DE LA IGLESIA MARIA GLORIA. Datos registrales. T 2668, L 2668, F 132, S 8, H PO 29290,I/A 5 ( 7.11.12).