Buscador CIF Logo

Actos BORME Dolby Xxi Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Dolby Xxi Sl

Actos BORME Dolby Xxi Sl - B63873426

Tenemos registrados 27 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Dolby Xxi Sl con CIF B63873426

馃敊 Perfil de Dolby Xxi Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Dolby Xxi Sl

21 de Octubre de 2021
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: GAROTA PARTNERS S.L. Datos registrales. T 44287 , F 209, S 8, H B 307759, I/A34 (13.10.21).

23 de Abril de 2021
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.274.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.274.500,00 Euros. Otros conceptos:CAMBIO DE SOCIO UNICO;NUEVO SOCIO UNICO ADRIA CARULLA RUIZ. Datos registrales. T 44287 , F 208, S 8, H B 307759,I/A 33 (14.04.21).

29 de Enero de 2020
Nombramientos. CONS.DEL.SOL: ANDA MADALINA MAGUREAN. Datos registrales. T 44287 , F 207, S 8, H B 307759, I/A 30(21.01.20).

Nombramientos. APODERAD.SOL: CARULLA RUIZ ADRIA;CARULLA FONT LLUIS. Datos registrales. T 44287 , F 207, S 8, H B307759, I/A 31 (21.01.20).

Nombramientos. APOD.MANCOMU: CARULLA FONT LLUIS;CARULLA RUIZ ADRIA. Datos registrales. T 44287 , F 208, S 8, H B307759, I/A 32 (21.01.20).

16 de Enero de 2020
Revocaciones. ADM.UNICO: CARULLA RUIZ ADRIA. Nombramientos. CONSEJERO: CARULLA RUIZ ADRIA. SECRETARIO:CARULLA RUIZ ADRIA. CONSEJERO: CARULLA FONT LLUIS. PRESIDENTE: CARULLA FONT LLUIS. CONSEJERO: ANDAMADALINA MAGUREAN. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 14.- DURACION DEL CARGO. ARTICULO 15.- RETRIBUCIONDE LOS ADMINISTRADORES. Cambio de domicilio social. CL DE LLUIS MUNTADAS Num.8 (BARCELONA). Datos registrales.T 44287 , F 206, S 8, H B 307759, I/A 29 ( 3.01.20).

07 de Agosto de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.579.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.096.250,00 Euros. Datos registrales. T 44287, F 205, S 8, H B 307759, I/A 27 (30.07.19).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.452.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.549.000,00 Euros. Datos registrales. T 44287 , F 205, S8, H B 307759, I/A 28 (30.07.19).

Otros conceptos: RECTIFICADA LA INSCRIPCION 24 EN CUANTO A LA FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA. Datosregistrales. T 44287 , F 205, S 8, H B 307759, I/A 26 (30.07.19).

13 de Junio de 2019
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: CARULLA FONT MARIA;CARULLA FONT LLUIS;CARULLA FONT MARIA;GALVEZ GIMENEZMANUEL;GONZALEZ GRAU ALFONSO;CLOSAS MESTRE FERRAN. Datos registrales. T 44287 , F 204, S 8, H B 307759, I/A 25 (5.06.19).

22 de Febrero de 2019
Ampliaci贸n de capital. Capital: 167.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.675.750,00 Euros. Datos registrales. T 44287 , F 203, S 8,H B 307759, I/A 24 (13.02.19).

11 de Febrero de 2019
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: CARULLA RUIZ ADRIA. PRESIDENTE: RUIZ CORCOY NURIA. CONSEJERO: CARULLA FONTMARIA. SECRETARIO: CARULLA FONT MARIA. CONSEJERO: CARULLA RUIZ ADRIA. CONS. DELEG.: CARULLA RUIZ ADRIA.CONSEJERO: RUIZ CORCOY NURIA. Nombramientos. ADM.UNICO: CARULLA RUIZ ADRIA. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 2.592.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.508.000,00 Euros. Datos registrales. T 44287 , F 203, S 8, H B 307759, I/A 23(29.01.19).

30 de Octubre de 2018
Cambio de domicilio social. CL ESCOLES PIES Num.102 (BARCELONA). Datos registrales. T 44287 , F 202, S 8, H B 307759,I/A 22 (22.10.18).

16 de Abril de 2018
Revocaciones. CONSEJERO: RUIZ CORCOY NURIA. PRESIDENTE: RUIZ CORCOY NURIA. CONSEJERO: CARULLA FONTMARIA. SECRETARIO: CARULLA FONT MARIA. CONSEJERO: CARULLA RUIZ ADRIA. CONS. DELEG.: CARULLA RUIZ ADRIA.Nombramientos. PRESIDENTE: RUIZ CORCOY NURIA. CONSEJERO: CARULLA FONT MARIA. SECRETARIO: CARULLA FONTMARIA. CONSEJERO: CARULLA RUIZ ADRIA. CONS. DELEG.: CARULLA RUIZ ADRIA. CONSEJERO: RUIZ CORCOY NURIA.Datos registrales. T 44287 , F 202, S 8, H B 307759, I/A 21 ( 6.04.18).

22 de Enero de 2016
Cambio de domicilio social. RB DE CATALUNYA Num.135 P.4 PTA.1 (BARCELONA). Datos registrales. T 44287 , F 202, S 8, H B307759, I/A 20 (14.01.16).

20 de Noviembre de 2015
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CARULLA RUIZ ADRIA;CARULLA FONT LLUIS;CARULLA FONT MARIA. Datos registrales. T44287 , F 201, S 8, H B 307759, I/A 18 (13.11.15).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CARULLA FONT LLUIS;CARULLA FONT MARIA;GALVEZ GIMENEZ MANUEL;GONZALEZGRAU ALFONSO;CLOSAS MESTRE FERRAN. Datos registrales. T 44287 , F 201, S 8, H B 307759, I/A 19 (13.11.15).

05 de Mayo de 2014
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CARULLA RUIZ ADRIA;CARULLA FONT LLUIS;CARULLA FONT MARIA. Datos registrales. T37662 , F 29, S 8, H B 307759, I/A 17 (23.04.14).

17 de Mayo de 2013
Modificaciones estatutarias. ART.15:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 37662 , F 28, S 8, H B 307759, I/A 14 ( 9.05.13).

Nombramientos. CONS. DELEG.: CARULLA RUIZ ADRIA. Datos registrales. T 37662 , F 29, S 8, H B 307759, I/A 15 ( 9.05.13).

Nombramientos. CONSEJERO: RUIZ CORCOY NURIA. PRESIDENTE: RUIZ CORCOY NURIA. CONSEJERO: CARULLA FONTMARIA. SECRETARIO: CARULLA FONT MARIA. CONSEJERO: CARULLA RUIZ ADRIA. CONS. DELEG.: CARULLA RUIZ ADRIA.Datos registrales. T 37662 , F 29, S 8, H B 307759, I/A 16 ( 9.05.13).

12 de Enero de 2011
Revocaciones. APODERADO: CARULLA FONT LLUIS;CARULLA FONT MARIA;GARCIA BOSCH XAVIER. Nombramientos.APODERADO: CARULLA FONT LLUIS;CARULLA FONT MARIA;GALVEZ GIMENEZ MANUEL;GONZALEZ GRAUALFONSO;CLOSAS MESTRE FERRAN. Datos registrales. T 37662 , F 28, S 8, H B 307759, I/A 13 (29.12.10).

08 de Noviembre de 2010
Revocaciones. CONSEJERO: CARULLA FONT LLUIS. PRESIDENTE: CARULLA FONT LLUIS. Nombramientos. CONSEJERO:RUIZ CORCOY NURIA. PRESIDENTE: RUIZ CORCOY NURIA. Datos registrales. T 37662 , F 27, S 8, H B 307759, I/A 12(26.10.10).

20 de Agosto de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 8.096.875,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.100.000,00 Euros. Datos registrales. T 37662 , F 26, S8, H B 307759, I/A 11 ( 9.08.10).

12 de Febrero de 2009
Revocaciones. APODERADO: MUNTADAS PRIM LAFITA LUIS;GARCIA BOSCH XAVIER;CORONADO PUERTOFRANCISCO;MARTINEZ CANELA EVA. Nombramientos. APODERADO: CARULLA FONT LLUIS;CARULLA FONT MARIA;GARCIABOSCH XAVIER. Datos registrales. T 37662 , F 25, S 8, H B 307759, I/A 9 ( 2.02.09).

Nombramientos. APODERADO: CARULLA FONT LLUIS;GALVEZ GIMENEZ MANUEL;LAJUNTA RAFECAS MARIA TERESA.Datos registrales. T 37662 , F 26, S 8, H B 307759, I/A 10 ( 2.02.09).

02 de Febrero de 2009
Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL,609-615 P.10 (BARCELONA). Datos registrales. T 37662 , F 25, S 8, H B 307759, I/A8 (19.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n