Buscador CIF Logo

Actos BORME Domingo Del Palacio Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Domingo Del Palacio Sa

Actos BORME Domingo Del Palacio Sa - A28524726

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Domingo Del Palacio Sa con CIF A28524726

馃敊 Perfil de Domingo Del Palacio Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Domingo Del Palacio Sa

02 de Octubre de 2023
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 29660 , F 4,S 8, H M 85306, I/A 42M (25.09.23).

14 de Abril de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: TEJERO NOVOA LUANA;ZATO FAJARDO ESTEBAN. Datos registrales. T 29660 , F 7, S 8, H M85306, I/A 50 ( 5.04.23).

27 de Junio de 2022
Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ BUENO REMIGIO;GONZALEZ GARCIA ANGEL. Datos registrales. T 29660 , F 6, S 8, H M85306, I/A 49 (20.06.22).

30 de Septiembre de 2021
Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 44陋 la reelecci贸n como consejero de MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 29660 , F 4, S 8, H M 85306, I/A 44 (26.04.19).

30 de Marzo de 2021
Modificaciones estatutarias. 13. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. Otros conceptos: RECTIFICACION DELARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 29660 , F 6, S 8, H M 85306, I/A 48 (23.03.21).

10 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Consejero: TEJERO NOVOA LUANA;ZATO FAJARDO ESTEBAN. Modificaciones estatutarias. MODIFICACIONDEL ARTICULO 13潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 29660 , F 6, S 8, H M 85306, I/A 47 (30.10.20).

26 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Auditor: JHO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 29660 , F 5, S 8, H M 85306, I/A 46 (19.11.19).

09 de Octubre de 2019
Nombramientos. Con.Delegado: MARTIN MORENO FRANCISCO;DE PABLOS RODRIGUEZ JULIANA. Modificacionesestatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 13潞 EN SUS PUNTOS 2 Y 3, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales.T 29660 , F 5, S 8, H M 85306, I/A 45 ( 2.10.19).

07 de Mayo de 2019
Reelecciones. Consejero: TEJERO DE PABLOS JUAN CARLOS;DE PABLOS RODRIGUEZ JULIANA;MARTIN MORENOFRANCISCO;MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: TEJERO DE PABLOS JUAN CARLOS. Secretario: DE PABLOSRODRIGUEZ JULIANA. Datos registrales. T 29660 , F 4, S 8, H M 85306, I/A 44 (26.04.19).

23 de Noviembre de 2016
Ampliacion del objeto social. Fabricacion de jamones y paletas de cerdo de cualquier clase. Datos registrales. T 29660 , F 4, S 8,H M 85306, I/A 43 (15.11.16).

15 de Septiembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: TEJERO DE PABLOS JUAN CARLOS;DE PABLOS RODRIGUEZ JULIANA;MARTIN MORENOFRANCISCOPresidente: TEJERO DE PABLOS JUAN CARLOS. Secretario: DE PABLOS RODRIGUEZ JULIANA. Nombramientos.Consejero: TEJERO DE PABLOS JUAN CARLOS;DE PABLOS RODRIGUEZ JULIANA;MARTIN MORENO FRANCISCO;MARTINLOPEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: TEJERO DE PABLOS JUAN CARLOS. Secretario: DE PABLOS RODRIGUEZ JULIANA.Datos registrales. T 29660 , F 4, S 8, H M 85306, I/A 42 ( 8.09.16).

14 de Julio de 2016
Reelecciones. Auditor: JHO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 29660 , F 3, S 8, H M 85306, I/A 41 ( 6.07.16).

18 de Marzo de 2015
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GARCIA ANGEL. Datos registrales. T 29660 , F 2, S 8, H M 85306, I/A 40 (10.03.15).

17 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: TEJERO DE PABLOS JUAN CARLOS. Presidente: TEJERO DE PABLOS JUAN CARLOS. Consejero:DE PABLOS RODRIGUEZ JULIANA. Secretario: DE PABLOS RODRIGUEZ JULIANA. Consejero: MARTIN MORENO FRANCISCO.Nombramientos. Consejero: TEJERO DE PABLOS JUAN CARLOS;DE PABLOS RODRIGUEZ JULIANA;MARTIN MORENOFRANCISCOPresidente: TEJERO DE PABLOS JUAN CARLOS. Secretario: DE PABLOS RODRIGUEZ JULIANA. Apo.Sol.: TEJERODE PABLOS JUAN CARLOS;DE PABLOS RODRIGUEZ JULIANA. Datos registrales. T 29660 , F 1, S 8, H M 85306, I/A 39 (

15 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ BUENO REMIGIO. Nombramientos. Consejero: MARTIN MORENO FRANCISCO. Datosregistrales. T 29660 , F 1, S 8, H M 85306, I/A 38 ( 7.10.13).

29 de Agosto de 2013
Nombramientos. Auditor: JHO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 29660 , F 1, S 8, H M 85306, I/A 37 (14.08.13).

16 de Marzo de 2012
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MADRID SL. Datos registrales. T 29660 , F 1, S 8, H M 85306, I/A 36 ( 6.03.12).

05 de Marzo de 2012
Reelecciones. Auditor: DIGITO AUDITORES SA. Datos registrales. T 29660 , F 1, S 8, H M 85306, I/A 35 (23.02.12).

05 de Julio de 2010
Reelecciones. Auditor: AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 5209 , F 225, S 8, H M 85306,I/A 34 (23.06.10).

09 de Julio de 2009
Nombramientos. Apoderado: TEJERO DE PABLOS JUAN CARLOS;JIMENEZ BUENO REMIGIO. Datos registrales. T 5209 , F224, S 8, H M 85306, I/A 33 (29.06.09).

07 de Julio de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTIN MORENO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: TEJERO DE PABLOS JUANCARLOS. Presidente: TEJERO DE PABLOS JUAN CARLOS. Consejero: DE PABLOS RODRIGUEZ JULIANA. Secretario: DEPABLOS RODRIGUEZ JULIANA. Consejero: JIMENEZ BUENO REMIGIO. Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado:270.505,82 Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n. Otros conceptos: REDACCION DE UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDADPOR CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION. Ampliacion del objeto social. LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOSRESE脩ADOS EN EL OBJETO SOCIAL. Datos registrales. T 5209 , F 221, S 8, H M 85306, I/A 32 (25.06.09).

28 de Enero de 2009
Reelecciones. Auditor: AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 5209 , F 221, S 8, H M 85306,I/A 31 (19.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n