Buscador CIF Logo

Actos BORME Dosventill Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Dosventill Sa

Actos BORME Dosventill Sa - A79561411

Tenemos registrados 27 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Dosventill Sa con CIF A79561411

🔙 Perfil de Dosventill Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Dosventill Sa

03 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Datos registrales. T 39742 , F 216, S 8, H M 12185, I/A 44 (27.07.23).

26 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL. Datosregistrales. T 39742 , F 215, S 8, H M 12185, I/A 43 (19.05.23).

25 de Mayo de 2023
Reelecciones. Consejero: CANETONIN SL;ANGERAN SL;VALDEQUINILLA SL. Datos registrales. T 39742 , F 215, S 8, H M12185, I/A 42 (18.05.23).

14 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL. Datosregistrales. T 39742 , F 214, S 8, H M 12185, I/A 41 ( 6.10.21).

27 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Datos registrales. T 39742 , F 214, S 8, H M 12185, I/A 40 (20.11.20).

31 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Representan: RUEDA GONZALEZ PEDRO ANTONIO. Nombramientos. Representan: FERNANDEZ CALVOGERARDO. Datos registrales. T 39742 , F 214, S 8, H M 12185, I/A 39 (23.12.19).

19 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Consejero: CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINA CHRISTELLEEVA. Datos registrales. T 28884 , F 34, S 8, H M 12185, I/A 38 (12.11.19).

26 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL. Datosregistrales. T 28884 , F 34, S 8, H M 12185, I/A 37 (19.06.19).

07 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GUARDO GALDON MARIA LUISA. Nombramientos. VsecrNoConsj: SILVA RUIZ DEL OLMOBLANCA. Datos registrales. T 28884 , F 33, S 8, H M 12185, I/A 36 (31.01.19).

17 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL. Datosregistrales. T 28884 , F 33, S 8, H M 12185, I/A 35 ( 9.07.18).

21 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: ANGERAN SL;CANETONIN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Datos registrales. T 28884 , F 32, S 8, H M 12185, I/A 34 (11.08.17).

26 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: LOPEZ DEL HIERRO PEREZ MINGUEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan:VARELA TORRES NURIA MARTA. Datos registrales. T 28884 , F 32, S 8, H M 12185, I/A 33 (18.07.17).

03 de Enero de 2017
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Nombramientos. Representan: PETROSSI VALDESEDUARDO ALFREDO;LOPEZ DEL HIERRO PEREZ MINGUEZ FRANCISCO JAVIER;RUEDA GONZALEZ PEDRO ANTONIO.Consejero: CANETONIN SL;ANGERAN SL;VALDEQUINILLA SL. Vicepresid.: ANGERAN SL;CANETONIN SL. Reelecciones.Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Modificaciones estatutarias. Aprobado un nuevo texto de los estatutos sociales.Datos registrales. T 28884 , F 29, S 8, H M 12185, I/A 32 (23.12.16).

19 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA.Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Datosregistrales. T 28884 , F 29, S 8, H M 12185, I/A 31 ( 9.12.16).

08 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Datosregistrales. T 28884 , F 28, S 8, H M 12185, I/A 30 (30.06.15).

01 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES. Datosregistrales. T 28884 , F 28, S 8, H M 12185, I/A 29 (23.06.14).

22 de Octubre de 2013
Nombramientos. Auditor: ATA AUDITORES SL. Datos registrales. T 28884 , F 28, S 8, H M 12185, I/A 28 (15.10.13).

11 de Octubre de 2013
Nombramientos. Apoderado: CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINACHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 28884 , F 27, S 8, H M 12185, I/A 27 ( 4.10.13).

07 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANAFRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Reelecciones. Consejero: CALVO CAMINEROMERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 28884 , F 27, S 8, HM 12185, I/A 26 (27.09.13).

09 de Abril de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINACHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 28884 , F 26, S 8, H M 12185, I/A 25 (25.03.13).

09 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Datosregistrales. T 28884 , F 26, S 8, H M 12185, I/A 24 (28.06.12).

03 de Julio de 2012
Cambio de domicilio social. C/ GUZMAN EL BUENO 133 9& (MADRID). Datos registrales. T 28884 , F 26, S 8, H M 12185, I/A 23(15.06.12).

16 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES. Datosregistrales. T 28884 , F 26, S 8, H M 12185, I/A 22 ( 6.06.11).

31 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Secretario: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE.Revocaciones. Apoderado: HIERRO CIA NIEVES;DIAZ ALBISU JOSE LUIS;DIAZ ALBISU JOSE LUIS;HIERRO CIANIEVES;TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE. Nombramientos. Secretario: TRIGO SIERRA LUIS. Presidente: GERVAS HIERROANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. VsecrNoConsj: GUARDO GALDON MARIA LUISA. Datosregistrales. T 20946 , F 79, S 8, H M 12185, I/A 21 (20.08.10).

28 de Octubre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GERVAS DIEZ GERMAN. Presidente: GERVAS DIEZ GERMAN. SecreNoConsj: DIAZ ALBISU JOSELUIS. Vicesecret.: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE. Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES.SecreNoConsj: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE. Datos registrales. T 20946 , F 76, S 8, H M 12185, I/A 18 (16.10.09).

Nombramientos. Apoderado: CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINACHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 20946 , F 77, S 8, H M 12185, I/A 19 (16.10.09).

Nombramientos. Apoderado: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE;CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANAFRANCISCA;GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 20946 , F 77, S 8, H M 12185, I/A 20 (16.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información