Actos BORME de Dr Franz Schneider Sa
17 de Noviembre de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SMP AUTOMOTIVE TECHNOLOGY IBERICA SL. Datosregistrales. T 6688, L 3992, F 170, S 8, H V 22647, I/A 74 (10.11.23).
27 de Octubre de 2022Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 169, S8, H V 22647, I/A 73 (20.10.22).
13 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. Secretario: HERNANDEZ MARTI JUAN. Nombramientos. Secretario: LLORENS FERNANDEZ MARIAAMPARO. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 169, S 8, H V 22647, I/A 72 ( 6.07.22).
17 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: SHAH PARAG-ARVING. Nombramientos. Consejero: KNOLL STEFAN. Datos registrales. T 6688,L 3992, F 169, S 8, H V 22647, I/A 71 ( 9.05.22).
16 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: STADELMANN THOMAS LORENZ. Presidente: STADELMANN THOMAS LORENZ.Nombramientos. Consejero: STADELMANN THOMAS LORENZ. Presidente: STADELMANN THOMAS LORENZ. Datos registrales.T 6688, L 3992, F 169, S 8, H V 22647, I/A 70 ( 9.11.21).
03 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: REVERT ARNAU CARLOS;RAMOS HERNANDEZ ANTONIO DOMINGO. Nombramientos. Apo.Sol.:REVERT ARNAU CARLOS;SANCHEZ DIAZ CANO ALBERTO. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 168, S 8, H V 22647, I/A 69(24.02.21).
15 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: FRIEDRICH GUNTER MURMANN. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 168, S 8, H V 22647, I/A 68( 8.02.21).
16 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: KARL WIRTH WILHELM. Presidente: KARL WIRTH WILHELM. Nombramientos. Consejero:MORNHART MALTE. Presidente: STADELMANN THOMAS LORENZ. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 168, S 8, H V 22647, I/A67 ( 9.09.20).
20 de Febrero de 2020Reelecciones. Consejero: KARL WIRTH WILHELM. Presidente: KARL WIRTH WILHELM. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 168,S 8, H V 22647, I/A 65 (13.02.20).
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 168, S 8,H V 22647, I/A 66 (13.02.20).
11 de Febrero de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: WEINER ROLAND. Apoderado: REVERT ARNAU CARLOS;REVERT ARNAU CARLOS. Apo.Manc.:REVERT ARNAU CARLOS. Apo.Man.Soli: REVERT ARNAU CARLOS. Apo.Manc.: REVERT ARNAU CARLOS. Apoderado: REVERTARNAU CARLOS. Nombramientos. Apo.Sol.: REVERT ARNAU CARLOS;RAMOS HERNANDEZ ANTONIO DOMINGO. Datosregistrales. T 6688, L 3992, F 167, S 8, H V 22647, I/A 64 ( 4.02.20).
25 de Septiembre de 2018Reelecciones. Consejero: FRIEDRICH GUNTER MURMANN. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 167, S 8, H V 22647, I/A 63(18.09.18).
23 de Enero de 2017Nombramientos. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6688,L 3992, F 167, S 8, H V 22647, I/A 62 (16.01.17).
22 de Noviembre de 2016Nombramientos. Consejero: SHAH PARAG-ARVING. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 167, S 8, H V 22647, I/A 61 (15.11.16).
13 de Julio de 2016Reelecciones. Consejero: STADELMANN THOMAS LORENZ. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 166, S 8, H V 22647, I/A 60 (6.07.16).
04 de Marzo de 2015Reelecciones. Consejero: KARL WIRTH WILHELM. Presidente: KARL WIRTH WILHELM. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 166,S 8, H V 22647, I/A 58 (25.02.15).
Nombramientos. Apoderado: REVERT ARNAU CARLOS. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 166, S 8, H V 22647, I/A 59(25.02.15).
04 de Febrero de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.500.000,00 Euros. Desembolsado: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.620.200,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.620.200,00 Euros. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 166, S 8, H V 22647, I/A 57 (27.01.15).
12 de Febrero de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: STADELMANN THOMAS LORENZ;REVERT ARNAU CARLOS;WEINER ROLAND. Datosregistrales. T 6688, L 3992, F 165, S 8, H V 22647, I/A 56 ( 5.02.14).
29 de Octubre de 2013Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 165, S 8, H V 22647, I/A 55 (22.10.13).
05 de Agosto de 2013Fe de erratas: Por error se omiti贸 el apellido Murmann del administrador don Gunter Friedrich Murmann. Datos registrales. T 6688,L 3992, F 165, S 8, H V 22647, I/A 54 (24.07.13).
31 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: FRICKE KLAUS. Nombramientos. Consejero: FRIEDRICH GUNTER. Datos registrales. T 6688, L3992, F 165, S 8, H V 22647, I/A 54 (24.07.13).
21 de Mayo de 2013Revocaciones. Apoderado: MISA SANCHEZ ANTONIO;LOPEZ LLORENS JOSE ANTONIO;BRENDEL KARL. Datos registrales. T
29 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apoderado: BRENDEL KARL;BRENDEL KARL. Nombramientos. Apoderado: REVERT ARNAU CARLOS. Datosregistrales. T 6688, L 3992, F 164, S 8, H V 22647, I/A 52 (18.11.11).
13 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: WACHTER THOMAS. Nombramientos. Consejero: FRICKE KLAUS. Datos registrales. T 6688, L3992, F 164, S 8, H V 22647, I/A 51 ( 4.04.11).
04 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: HORST FREUNDORFER THOMAS. Con.Delegado: HORST FREUNDORFER THOMAS.Nombramientos. Consejero: STADELMANN THOMAS LORENZ. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 163, S 8, H V 22647, I/A 49(25.10.10).
Revocaciones. Apoderado: HORST FREUNDORFER THOMAS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: STADELMANN THOMASLORENZ. Modificaci贸n de poderes. Apoderado: REVERT ARNAU CARLOS;BRENDEL KARL. Datos registrales. T 6688, L 3992,F 164, S 8, H V 22647, I/A 50 (25.10.10).
01 de Julio de 2010Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 163, S 8, H V 22647, I/A 48 (22.06.10).
22 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: BEUTNAGEL JAN. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 163, S 8, H V 22647, I/A 47 (11.02.10).
05 de Enero de 2010Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: SCHNEIDER FRANZ ADAM;SCHMIDT SILVIA INGEBORG;MESERLE ANNETTE BARBARA.Consejero: SCHNEIDER FRANZ ADAM;SAENZ CASTRILLO JOSE LUIS;SCHMIDT SILVIA INGEBORG;MESERLE ANNETTEBARBARA. Presidente: SCHMIDT SILVIA INGEBORG. Vicepresid.: MESERLE ANNETTE BARBARA. Nombramientos. Consejero:KARL WIRTH WILHELM;WACHTER THOMAS;BEUTNAGEL JAN;HORST FREUNDORFER THOMAS. Presidente: KARL WIRTHWILHELM. Con.Delegado: HORST FREUNDORFER THOMAS. Modificaciones estatutarias. En relaci贸n al sistema de retribuci贸ndel 贸rgano de administraci贸n.. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 163, S 8, H V 22647, I/A 46 (23.12.09).
14 de Octubre de 2009Reelecciones. Auditor: RUSSELL BEDFORD ESPA脩A AUDITORES Y CONSULTORES SOC. Datos registrales. T 4350, L 1662, F183, S 8, H V 22647, I/A 45 ( 2.10.09).
13 de Agosto de 2009Reelecciones. Consejero: SCHMIDT SILVIA INGEBORG;MESERLE ANNETTE BARBARA. Presidente: SCHMIDT SILVIAINGEBORG. Vicepresid.: MESERLE ANNETTE BARBARA. Datos registrales. T 4350, L 1662, F 183, S 8, H V 22647, I/A 44 (4.08.09).
24 de Febrero de 2009Revocaciones. Apo.Manc.: ABAD MARTINEZ JOSE PEDRO. Datos registrales. T 4350, L 1662, F 183, S 8, H V 22647, I/A 43(13.02.09).