Buscador CIF Logo

Actos BORME Dr Franz Schneider Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Dr Franz Schneider Sa

Actos BORME Dr Franz Schneider Sa - A46089702

Tenemos registrados 33 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Dr Franz Schneider Sa con CIF A46089702

馃敊 Perfil de Dr Franz Schneider Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Dr Franz Schneider Sa

17 de Noviembre de 2023
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SMP AUTOMOTIVE TECHNOLOGY IBERICA SL. Datosregistrales. T 6688, L 3992, F 170, S 8, H V 22647, I/A 74 (10.11.23).

27 de Octubre de 2022
Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 169, S8, H V 22647, I/A 73 (20.10.22).

13 de Julio de 2022
Ceses/Dimisiones. Secretario: HERNANDEZ MARTI JUAN. Nombramientos. Secretario: LLORENS FERNANDEZ MARIAAMPARO. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 169, S 8, H V 22647, I/A 72 ( 6.07.22).

17 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: SHAH PARAG-ARVING. Nombramientos. Consejero: KNOLL STEFAN. Datos registrales. T 6688,L 3992, F 169, S 8, H V 22647, I/A 71 ( 9.05.22).

16 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: STADELMANN THOMAS LORENZ. Presidente: STADELMANN THOMAS LORENZ.Nombramientos. Consejero: STADELMANN THOMAS LORENZ. Presidente: STADELMANN THOMAS LORENZ. Datos registrales.T 6688, L 3992, F 169, S 8, H V 22647, I/A 70 ( 9.11.21).

03 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: REVERT ARNAU CARLOS;RAMOS HERNANDEZ ANTONIO DOMINGO. Nombramientos. Apo.Sol.:REVERT ARNAU CARLOS;SANCHEZ DIAZ CANO ALBERTO. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 168, S 8, H V 22647, I/A 69(24.02.21).

15 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: FRIEDRICH GUNTER MURMANN. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 168, S 8, H V 22647, I/A 68( 8.02.21).

16 de Septiembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: KARL WIRTH WILHELM. Presidente: KARL WIRTH WILHELM. Nombramientos. Consejero:MORNHART MALTE. Presidente: STADELMANN THOMAS LORENZ. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 168, S 8, H V 22647, I/A67 ( 9.09.20).

20 de Febrero de 2020
Reelecciones. Consejero: KARL WIRTH WILHELM. Presidente: KARL WIRTH WILHELM. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 168,S 8, H V 22647, I/A 65 (13.02.20).

Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 168, S 8,H V 22647, I/A 66 (13.02.20).

11 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: WEINER ROLAND. Apoderado: REVERT ARNAU CARLOS;REVERT ARNAU CARLOS. Apo.Manc.:REVERT ARNAU CARLOS. Apo.Man.Soli: REVERT ARNAU CARLOS. Apo.Manc.: REVERT ARNAU CARLOS. Apoderado: REVERTARNAU CARLOS. Nombramientos. Apo.Sol.: REVERT ARNAU CARLOS;RAMOS HERNANDEZ ANTONIO DOMINGO. Datosregistrales. T 6688, L 3992, F 167, S 8, H V 22647, I/A 64 ( 4.02.20).

25 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Consejero: FRIEDRICH GUNTER MURMANN. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 167, S 8, H V 22647, I/A 63(18.09.18).

23 de Enero de 2017
Nombramientos. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6688,L 3992, F 167, S 8, H V 22647, I/A 62 (16.01.17).

22 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Consejero: SHAH PARAG-ARVING. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 167, S 8, H V 22647, I/A 61 (15.11.16).

13 de Julio de 2016
Reelecciones. Consejero: STADELMANN THOMAS LORENZ. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 166, S 8, H V 22647, I/A 60 (6.07.16).

04 de Marzo de 2015
Reelecciones. Consejero: KARL WIRTH WILHELM. Presidente: KARL WIRTH WILHELM. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 166,S 8, H V 22647, I/A 58 (25.02.15).

Nombramientos. Apoderado: REVERT ARNAU CARLOS. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 166, S 8, H V 22647, I/A 59(25.02.15).

04 de Febrero de 2015
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.500.000,00 Euros. Desembolsado: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.620.200,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.620.200,00 Euros. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 166, S 8, H V 22647, I/A 57 (27.01.15).

12 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: STADELMANN THOMAS LORENZ;REVERT ARNAU CARLOS;WEINER ROLAND. Datosregistrales. T 6688, L 3992, F 165, S 8, H V 22647, I/A 56 ( 5.02.14).

29 de Octubre de 2013
Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 165, S 8, H V 22647, I/A 55 (22.10.13).

05 de Agosto de 2013
Fe de erratas: Por error se omiti贸 el apellido Murmann del administrador don Gunter Friedrich Murmann. Datos registrales. T 6688,L 3992, F 165, S 8, H V 22647, I/A 54 (24.07.13).

31 de Julio de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: FRICKE KLAUS. Nombramientos. Consejero: FRIEDRICH GUNTER. Datos registrales. T 6688, L3992, F 165, S 8, H V 22647, I/A 54 (24.07.13).

21 de Mayo de 2013
Revocaciones. Apoderado: MISA SANCHEZ ANTONIO;LOPEZ LLORENS JOSE ANTONIO;BRENDEL KARL. Datos registrales. T

29 de Noviembre de 2011
Revocaciones. Apoderado: BRENDEL KARL;BRENDEL KARL. Nombramientos. Apoderado: REVERT ARNAU CARLOS. Datosregistrales. T 6688, L 3992, F 164, S 8, H V 22647, I/A 52 (18.11.11).

13 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: WACHTER THOMAS. Nombramientos. Consejero: FRICKE KLAUS. Datos registrales. T 6688, L3992, F 164, S 8, H V 22647, I/A 51 ( 4.04.11).

04 de Noviembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: HORST FREUNDORFER THOMAS. Con.Delegado: HORST FREUNDORFER THOMAS.Nombramientos. Consejero: STADELMANN THOMAS LORENZ. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 163, S 8, H V 22647, I/A 49(25.10.10).

Revocaciones. Apoderado: HORST FREUNDORFER THOMAS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: STADELMANN THOMASLORENZ. Modificaci贸n de poderes. Apoderado: REVERT ARNAU CARLOS;BRENDEL KARL. Datos registrales. T 6688, L 3992,F 164, S 8, H V 22647, I/A 50 (25.10.10).

01 de Julio de 2010
Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 163, S 8, H V 22647, I/A 48 (22.06.10).

22 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: BEUTNAGEL JAN. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 163, S 8, H V 22647, I/A 47 (11.02.10).

05 de Enero de 2010
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: SCHNEIDER FRANZ ADAM;SCHMIDT SILVIA INGEBORG;MESERLE ANNETTE BARBARA.Consejero: SCHNEIDER FRANZ ADAM;SAENZ CASTRILLO JOSE LUIS;SCHMIDT SILVIA INGEBORG;MESERLE ANNETTEBARBARA. Presidente: SCHMIDT SILVIA INGEBORG. Vicepresid.: MESERLE ANNETTE BARBARA. Nombramientos. Consejero:KARL WIRTH WILHELM;WACHTER THOMAS;BEUTNAGEL JAN;HORST FREUNDORFER THOMAS. Presidente: KARL WIRTHWILHELM. Con.Delegado: HORST FREUNDORFER THOMAS. Modificaciones estatutarias. En relaci贸n al sistema de retribuci贸ndel 贸rgano de administraci贸n.. Datos registrales. T 6688, L 3992, F 163, S 8, H V 22647, I/A 46 (23.12.09).

14 de Octubre de 2009
Reelecciones. Auditor: RUSSELL BEDFORD ESPA脩A AUDITORES Y CONSULTORES SOC. Datos registrales. T 4350, L 1662, F183, S 8, H V 22647, I/A 45 ( 2.10.09).

13 de Agosto de 2009
Reelecciones. Consejero: SCHMIDT SILVIA INGEBORG;MESERLE ANNETTE BARBARA. Presidente: SCHMIDT SILVIAINGEBORG. Vicepresid.: MESERLE ANNETTE BARBARA. Datos registrales. T 4350, L 1662, F 183, S 8, H V 22647, I/A 44 (4.08.09).

24 de Febrero de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: ABAD MARTINEZ JOSE PEDRO. Datos registrales. T 4350, L 1662, F 183, S 8, H V 22647, I/A 43(13.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n