Actos BORME de Drake Food Service International Etve Sl
22 de Agosto de 2023Nombramientos. Apoderado: ASTETE HEIMPELL IGNACIO;HURTADO OFER DIEGO ALONSO. Datos registrales. T 45101 , F 5,S 8, H M 667874, I/A 44 (14.08.23).
06 de Junio de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: ORIA RIU BORJA;KOUYOUMDJIAN INGLIS RICHARD JOHN. Vicepresid.: KOUYOUMDJIAN INGLISRICHARD JOHN. Consejero: VIDAL-QUADRAS DE CARALT ALEJO MANUEL. Con.Delegado: KOUYOUMDJIAN INGLIS RICHARDJOHN. Nombramientos. Consejero: PORZIO HONORATO FELIPE;GONZALEZ CORSSEN EDMUNDO. Con.Delegado: GONZALEZCORSSEN EDMUNDO. Vicepresid.: GONZALEZ CORSSEN EDMUNDO. Apo.Manc.: FRAUCA AMORENA FERNANDO;FRAUCAAMORENA FERNANDO. Datos registrales. T 45101 , F 1, S 8, H M 667874, I/A 43 (30.05.23).
25 de Abril de 2023Revocaciones. Apoderado: BAS LOSTAO PABLO;BAS LOSTAO PABLO. Apo.Manc.: BAS LOSTAO PABLO. Datos registrales. T37469 , F 225, S 8, H M 667874, I/A 41 (18.04.23).
Revocaciones. Apoderado: ASTETE HEIMPELL IGNACIO;KOUYOUMDJIAN INGLIS RICHARD;SEBECKIS CHAIGNEAUROBERTO. Datos registrales. T 45101 , F 1, S 8, H M 667874, I/A 42 (18.04.23).
15 de Marzo de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRAUCA AMORENA FERNANDO. Datos registrales. T 37469 , F 222, S 8, H M 667874, I/A 39 (8.03.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOLANILLA CENDRERO JOSEFA. Datos registrales. T 37469 , F 224, S 8, H M 667874, I/A 40 (8.03.23).
10 de Marzo de 2023Nombramientos. Apoderado: LOPEZ SANCHEZ-IZQUIERDO GERMAN. Datos registrales. T 37469 , F 220, S 8, H M 667874, I/A38 ( 3.03.23).
22 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: SOLANILLA CENDRERO JOSEFA;SOLANILLA CENDRERO JOSEFA. Datos registrales. T 37469 , F216, S 8, H M 667874, I/A 35 (15.12.22).
Nombramientos. Apoderado: FRAUCA AMORENA FERNANDO;FRAUCA AMORENA FERNANDO;FRAUCA AMORENAFERNANDO. Datos registrales. T 37469 , F 218, S 8, H M 667874, I/A 36 (15.12.22).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ SANCHEZ-IZQUIERDO GERMAN. Datos registrales. T 37469 , F 219, S 8, H M 667874, I/A37 (15.12.22).
29 de Noviembre de 2022Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 37469 , F 215, S 8, H M667874, I/A 34 (22.11.22).
25 de Octubre de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: DELGADO MICHAEL ANGEL. Datos registrales. T 37469 , F 214, S 8, H M 667874, I/A 32 (18.10.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ SANCHEZ-IZQUIERDO GERMAN. Datos registrales. T 37469 , F 215, S 8, H M 667874, I/A33 (18.10.22).
29 de Septiembre de 2022Otros conceptos: QUEDAN LIMITADAS LAS FACULTADES CONFERIDAS A FAVOR DE DOÑA JOSEFA SOLANILLA CENDREROEN LA FACULTAD 1.4 DEL ACUERDO 2 DE LA INSCRIPCION 25ª DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 37469 , F 213, S 8, H M667874, I/A 31 (22.09.22).
26 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: EGUIGUREN CORREA ALBERTO;SANHUEZA CAMPOS JOSE MIGUEL. Apoderado: EGUIGURENCORREA ALBERTO;SANHUEZA CAMPOS JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 37469 , F 213, S 8, H M 667874, I/A 30 (19.09.22).
23 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ RUIZ JAVIER ALFREDO;GONZALEZ RUIZ JAVIER ALFREDO. Apo.Man.Soli: GONZALEZRUIZ JAVIER ALFREDO. Datos registrales. T 37469 , F 213, S 8, H M 667874, I/A 29 (16.09.22).
17 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ CORSSEN EDMUNDO. Datos registrales. T 37469 , F 212, S 8, H M 667874, I/A 27(10.06.22).
Nombramientos. Con.Delegado: KOUYOUMDJIAN INGLIS RICHARD JOHN. Datos registrales. T 37469 , F 213, S 8, H M 667874,I/A 28 (10.06.22).
16 de Junio de 2022Cambio de domicilio social. C/ ALCALA 61 4º (MADRID). Datos registrales. T 37469 , F 212, S 8, H M 667874, I/A 26 ( 9.06.22).
15 de Junio de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: RIOPEREZ GALLEGOS DAVID;SCHAAR ORIVE SAMARA;TERUEL LOPEZ IRENE;BARBANOJ SILLESBLANCA. Apo.Manc.: SILVA VIAL CATALINA. Apoderado: VIAL CATALINA SILVA;OLAVE MARTIN JUAN;OLAVE MARTIN JUAN.Nombramientos. Apoderado: ASTETE HEIMPELL IGNACIO ARTURO;GONZALEZ RUIZ JAVIER ALFREDO;KOUYOUMDJIANINGLIS RICHARD JOHN;ASTETE HEIMPELL IGNACIO ARTURO;GONZALEZ RUIZ JAVIER ALFREDO;KOUYOUMDJIAN INGLISRICHARD JOHN;GONZALEZ CORSSEN EDMUNDO;IBAÑEZ SCOTT NICOLAS CIRILO;KOUYOUMDJIAN INGLIS RICHARDJOHN;GONZALEZ CORSSEN EDMUNDO;ORIA RIU BORJA. Datos registrales. T 37469 , F 204, S 8, H M 667874, I/A 23 ( 8.06.22).
Nombramientos. Apoderado: ASTETE HEIMPELL IGNACIO;KOUYOUMDJIAN INGLIS RICHARD;SEBECKIS CHAIGNEAUROBERTO. Datos registrales. T 37469 , F 209, S 8, H M 667874, I/A 24 ( 8.06.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ RUIZ JAVIER ALFREDO;KOUYOUMDJIAN INGLIS RICHARD JOHN;SOLANILLACENDRERO JOSEFA. Apo.Manc.: SOLANILLA CENDRERO JOSEFA. Datos registrales. T 37469 , F 211, S 8, H M 667874, I/A 25 (8.06.22).
13 de Junio de 2022Nombramientos. Consejero: VIDAL-QUADRAS DE CARALT ALEJO MANUEL. Datos registrales. T 37469 , F 204, S 8, H M667874, I/A 22 ( 6.06.22).
23 de Marzo de 2022Ampliación de capital. Capital: 2.628.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.000.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Comoconsecuencia de la reducción del valor nominal de las participaciones sociales, se modifica el artículo 5 de los Estatutos sociales. .Datos registrales. T 37469 , F 203, S 8, H M 667874, I/A 21 (16.03.22).
16 de Marzo de 2022Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 8 5ª - IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 37469 , F 203, S 8,
10 de Junio de 2021Ampliación de capital. Capital: 4.480.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.372.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. 5. .Datos registrales. T 37469 , F 200, S 8, H M 667874, I/A 18 ( 3.06.21).
30 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: BAS LOSTAO PABLO. Datos registrales. T 37469 , F 199, S 8, H M 667874, I/A 17 (23.03.21).
28 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RIOPEREZ GALLEGOS DAVID. Nombramientos. SecreNoConsj: LACAMBRA RIERAERNESTO. VsecrNoConsj: RADOVANOVIC DRNDA BOJAN. Consejero: GELLONA AMUNATEGUI ROBERTO;BERTOGLIANAVARRO DANIELA. Datos registrales. T 37469 , F 194, S 8, H M 667874, I/A 15 (21.01.21).
Nombramientos. Apoderado: OLAVE MARTIN JUAN;OLAVE MARTIN JUAN;BAS LOSTAO PABLO;BAS LOSTAO PABLO. Datosregistrales. T 37469 , F 194, S 8, H M 667874, I/A 16 (21.01.21).