Buscador CIF Logo

Actos BORME Ds Smith Business Services Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ds Smith Business Services Sl

Actos BORME Ds Smith Business Services Sl - B87989380

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ds Smith Business Services Sl con CIF B87989380

馃敊 Perfil de Ds Smith Business Services Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ds Smith Business Services Sl

24 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: TOMAS CASSINGENA SUSANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL CASTILLO VILLANUEVAFERNANDO. Datos registrales. T 37165 , F 224, S 8, H M 663271, I/A 24 (17.05.23).

11 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;ALVAREZ TOQUERO MARIAESTELA Nombramientos. Apo.Manc.: DIEZ GONZALEZ BELEN. Datos registrales. T 37165 , F 223, S 8, H M 663271, I/A 23(31.03.23).

11 de Agosto de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: MORROS RODRIGUEZ IGNACIO. Apoderado: BENITO FERNANDEZ CARMEN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: TOMAS CASSINGENA SUSANA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RUIZ PABLO. Datos registrales. T 37165 , F 221, S 8, HM 663271, I/A 22 ( 4.08.22).

12 de Abril de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: ALTAMIRANO RETAMOSO LISSET;BETEGON BADAS LAURA. Apo.Manc.: ALVAREZ TOQUEROMARIA ESTELA;BLANCO ESCALONA PILAR;SIMION ALEXANDRA. Datos registrales. T 37165 , F 220, S 8, H M 663271, I/A 21 (5.04.22).

19 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ DAVID;JUAREZ MERINO MARIA JESUS;DEL BARRIO VAQUERO ALVARO.Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO LOPEZ ISMAEL. Datos registrales. T 37165 , F 220, S 8, H M 663271, I/A 20 (12.11.21).

28 de Julio de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ DAVID;MERINO LOPEZ VICTOR;CAMARERO CARRION CRISTINA;JUAREZMERINO MARIA JESUS;NIETO RAPOSO NESTOR;NU脩EZ MAGRO ANA MARIA;DEL BARRIO VAQUERO ALVARO. Datosregistrales. T 37165 , F 219, S 8, H M 663271, I/A 19 (21.07.21).

10 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: FREIXAS ACHAERANDIO LOURDES. Datos registrales. T 37165 , F 219, S 8, H M 663271, I/A 18 (3.06.21).

25 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: GARRIDO AGUIN ELENA;FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO. Datos registrales. T37165 , F 219, S 8, H M 663271, I/A 17 (18.05.21).

16 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apoderado: RIZZI PATRIZZIA. Apo.Sol.: RIZZI PATRIZZIA. Nombramientos. Apoderado: BENITO FERNANDEZCARMEN;ALVAREZ DOMINGUEZ RUT. Datos registrales. T 37165 , F 218, S 8, H M 663271, I/A 16 ( 9.03.21).

09 de Octubre de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: TEJEDOR DE ANDRES PEDRO LUCAS. Datos registrales. T 37165 , F 217, S 8, H M 663271, I/A 14( 2.10.20).

Nombramientos. Apoderado: VARELA RICO MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 37165 , F 217, S 8, H M 663271, I/A 15 (2.10.20).

06 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: FERREIRA MARQUES FERREIRA CARDOSO TIAGO;CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;FRAILEORDU脩A NIEVES;VARELA RICO MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 37165 , F 217, S 8, H M 663271, I/A 13 (29.09.20).

24 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARRIOS RABAZAS ALFONSO. Apo.Sol.: FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO;ORTU脩O SIERRA MARIA CONCEPCION;IBA脩EZ PARADA MARIA LUISA. Datos registrales. T 37165 , F 215, S 8, H M663271, I/A 12 (17.08.20).

16 de Julio de 2020
Revocaciones. Apoderado: PALACIOS ABRIL HECTOR. Datos registrales. T 37165 , F 215, S 8, H M 663271, I/A 11 ( 9.07.20).

14 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: PALACIO CABRERO JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Manc.: CALLEJA GUERRA JULIO JOSE.Apo.Sol.: GARRIDO AGUIN ELENA;RIZZI PATRIZZIA;MORROS RODRIGUEZ IGNACIO. Datos registrales. T 37165 , F 24, S 8, H M663271, I/A 10 ( 7.02.20).

23 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Representan: ARON JEREMY ANDREW. Nombramientos. Representan: MONFORT GUASCH IGNACIO.Datos registrales. T 37165 , F 24, S 8, H M 663271, I/A 9 (12.04.19).

03 de Abril de 2019
Revocaciones. Apoderado: PAR UMBERT JUAN PABLO;PAR UMBERT JUAN PABLO;PAR UMBERT JUAN PABLO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: TEJEDOR DE ANDRES PEDRO LUCAS. Datos registrales. T 37165 , F 23, S 8, H M 663271, I/A 8(27.03.19).

29 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apoderado: OULDARBIA OULDARBIA NOURA. Nombramientos. Apoderado: DE LA CAL BUZON BIBIANA;PARUMBERT JUAN PABLO. Datos registrales. T 37165 , F 22, S 8, H M 663271, I/A 7 (22.03.19).

04 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: FREIXAS ACHAERANDIO LOURDES;PAR UMBERT JUAN PABLO;OULDARBIA OULDARBIANOURA. Datos registrales. T 37165 , F 20, S 8, H M 663271, I/A 6 (23.11.18).

05 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: TAYLOR JASON MICHAEL. Nombramientos. Representan: ARON JEREMY ANDREW. Datosregistrales. T 37165 , F 19, S 8, H M 663271, I/A 5 (27.09.18).

24 de Julio de 2018
Revocaciones. Apoderado: ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO. Nombramientos. Apo.Manc.: MORROS RODRIGUEZIGNACIO. Datos registrales. T 37165 , F 19, S 8, H M 663271, I/A 4 (16.07.18).

20 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: CAZORLA PUJALTE JORGE;CAZORLA PUJALTE JORGE;FORCADELL BEL JOAN ALBERT;RIZZIPATRIZZIA;PALACIOS ABRIL HECTOR;PAR UMBERT JUAN PABLO;CAZORLA PUJALTE JORGE;PALACIO CABRERO JOSEMANUEL;ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO;CAZORLA PUJALTE JORGE;AYAS CARRETERO MARCO ANTONIO;DE LA CALBUZON BIBIANA. Datos registrales. T 37165 , F 17, S 8, H M 663271, I/A 3 ( 9.02.18).

16 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;DIAZ CRESPO ROSALIA;RODRIGUEZ TORRES IRIA;RUIZ PE脩ASUSANA SONIA;RABES RODRIGUEZ MARTA;PEREZ SERRANO ISABEL. Datos registrales. T 37165 , F 14, S 8, H M 663271, I/A2 ( 9.02.18).

15 de Febrero de 2018
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 21.12.17. Objeto social: Promoci贸n, creaci贸n, organizaci贸n, administraci贸n, representaci贸ny adquisici贸n de toda clase de empresas o entidades industriales y mercantiles, nacionales o extranjeras, cuya actividad consista en lafabricaci贸n, manipulaci贸n y comercializaci贸n de papel y todo tipo de mercader铆as y materiales etc. Domicilio: AVDA DEL SOL 13(TORREJON DE ARDOZ). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: DS SMITH PACKAGINGHOLDING SL. Nombramientos. Adm. Unico: DS SMITH PACKAGING HOLDING SL. Representan: TAYLOR JASON MICHAEL.Apo.Sol.: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;DIAZ CRESPO ROSALIA;RODRIGUEZ TORRES IRIA;PEREZ SERRANO ISABEL;RUIZPE脩A SUSANA SONIA. Datos registrales. T 37165 , F 11, S 8, H M 663271, I/A 1 ( 7.02.18).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n