Actos BORME de Ds Smith Business Services Sl
24 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: TOMAS CASSINGENA SUSANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL CASTILLO VILLANUEVAFERNANDO. Datos registrales. T 37165 , F 224, S 8, H M 663271, I/A 24 (17.05.23).
11 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;ALVAREZ TOQUERO MARIAESTELA Nombramientos. Apo.Manc.: DIEZ GONZALEZ BELEN. Datos registrales. T 37165 , F 223, S 8, H M 663271, I/A 23(31.03.23).
11 de Agosto de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: MORROS RODRIGUEZ IGNACIO. Apoderado: BENITO FERNANDEZ CARMEN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: TOMAS CASSINGENA SUSANA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RUIZ PABLO. Datos registrales. T 37165 , F 221, S 8, HM 663271, I/A 22 ( 4.08.22).
12 de Abril de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ALTAMIRANO RETAMOSO LISSET;BETEGON BADAS LAURA. Apo.Manc.: ALVAREZ TOQUEROMARIA ESTELA;BLANCO ESCALONA PILAR;SIMION ALEXANDRA. Datos registrales. T 37165 , F 220, S 8, H M 663271, I/A 21 (5.04.22).
19 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ DAVID;JUAREZ MERINO MARIA JESUS;DEL BARRIO VAQUERO ALVARO.Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO LOPEZ ISMAEL. Datos registrales. T 37165 , F 220, S 8, H M 663271, I/A 20 (12.11.21).
28 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ DAVID;MERINO LOPEZ VICTOR;CAMARERO CARRION CRISTINA;JUAREZMERINO MARIA JESUS;NIETO RAPOSO NESTOR;NU脩EZ MAGRO ANA MARIA;DEL BARRIO VAQUERO ALVARO. Datosregistrales. T 37165 , F 219, S 8, H M 663271, I/A 19 (21.07.21).
10 de Junio de 2021Revocaciones. Apoderado: FREIXAS ACHAERANDIO LOURDES. Datos registrales. T 37165 , F 219, S 8, H M 663271, I/A 18 (3.06.21).
25 de Mayo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: GARRIDO AGUIN ELENA;FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO. Datos registrales. T37165 , F 219, S 8, H M 663271, I/A 17 (18.05.21).
16 de Marzo de 2021Revocaciones. Apoderado: RIZZI PATRIZZIA. Apo.Sol.: RIZZI PATRIZZIA. Nombramientos. Apoderado: BENITO FERNANDEZCARMEN;ALVAREZ DOMINGUEZ RUT. Datos registrales. T 37165 , F 218, S 8, H M 663271, I/A 16 ( 9.03.21).
09 de Octubre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: TEJEDOR DE ANDRES PEDRO LUCAS. Datos registrales. T 37165 , F 217, S 8, H M 663271, I/A 14( 2.10.20).
Nombramientos. Apoderado: VARELA RICO MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 37165 , F 217, S 8, H M 663271, I/A 15 (2.10.20).
06 de Octubre de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: FERREIRA MARQUES FERREIRA CARDOSO TIAGO;CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;FRAILEORDU脩A NIEVES;VARELA RICO MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 37165 , F 217, S 8, H M 663271, I/A 13 (29.09.20).
24 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARRIOS RABAZAS ALFONSO. Apo.Sol.: FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO;ORTU脩O SIERRA MARIA CONCEPCION;IBA脩EZ PARADA MARIA LUISA. Datos registrales. T 37165 , F 215, S 8, H M663271, I/A 12 (17.08.20).
16 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: PALACIOS ABRIL HECTOR. Datos registrales. T 37165 , F 215, S 8, H M 663271, I/A 11 ( 9.07.20).
14 de Febrero de 2020Revocaciones. Apoderado: PALACIO CABRERO JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Manc.: CALLEJA GUERRA JULIO JOSE.Apo.Sol.: GARRIDO AGUIN ELENA;RIZZI PATRIZZIA;MORROS RODRIGUEZ IGNACIO. Datos registrales. T 37165 , F 24, S 8, H M663271, I/A 10 ( 7.02.20).
23 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: ARON JEREMY ANDREW. Nombramientos. Representan: MONFORT GUASCH IGNACIO.Datos registrales. T 37165 , F 24, S 8, H M 663271, I/A 9 (12.04.19).
03 de Abril de 2019Revocaciones. Apoderado: PAR UMBERT JUAN PABLO;PAR UMBERT JUAN PABLO;PAR UMBERT JUAN PABLO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: TEJEDOR DE ANDRES PEDRO LUCAS. Datos registrales. T 37165 , F 23, S 8, H M 663271, I/A 8(27.03.19).
29 de Marzo de 2019Revocaciones. Apoderado: OULDARBIA OULDARBIA NOURA. Nombramientos. Apoderado: DE LA CAL BUZON BIBIANA;PARUMBERT JUAN PABLO. Datos registrales. T 37165 , F 22, S 8, H M 663271, I/A 7 (22.03.19).
04 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: FREIXAS ACHAERANDIO LOURDES;PAR UMBERT JUAN PABLO;OULDARBIA OULDARBIANOURA. Datos registrales. T 37165 , F 20, S 8, H M 663271, I/A 6 (23.11.18).
05 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Representan: TAYLOR JASON MICHAEL. Nombramientos. Representan: ARON JEREMY ANDREW. Datosregistrales. T 37165 , F 19, S 8, H M 663271, I/A 5 (27.09.18).
24 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO. Nombramientos. Apo.Manc.: MORROS RODRIGUEZIGNACIO. Datos registrales. T 37165 , F 19, S 8, H M 663271, I/A 4 (16.07.18).
20 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: CAZORLA PUJALTE JORGE;CAZORLA PUJALTE JORGE;FORCADELL BEL JOAN ALBERT;RIZZIPATRIZZIA;PALACIOS ABRIL HECTOR;PAR UMBERT JUAN PABLO;CAZORLA PUJALTE JORGE;PALACIO CABRERO JOSEMANUEL;ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO;CAZORLA PUJALTE JORGE;AYAS CARRETERO MARCO ANTONIO;DE LA CALBUZON BIBIANA. Datos registrales. T 37165 , F 17, S 8, H M 663271, I/A 3 ( 9.02.18).
16 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;DIAZ CRESPO ROSALIA;RODRIGUEZ TORRES IRIA;RUIZ PE脩ASUSANA SONIA;RABES RODRIGUEZ MARTA;PEREZ SERRANO ISABEL. Datos registrales. T 37165 , F 14, S 8, H M 663271, I/A2 ( 9.02.18).
15 de Febrero de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 21.12.17. Objeto social: Promoci贸n, creaci贸n, organizaci贸n, administraci贸n, representaci贸ny adquisici贸n de toda clase de empresas o entidades industriales y mercantiles, nacionales o extranjeras, cuya actividad consista en lafabricaci贸n, manipulaci贸n y comercializaci贸n de papel y todo tipo de mercader铆as y materiales etc. Domicilio: AVDA DEL SOL 13(TORREJON DE ARDOZ). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: DS SMITH PACKAGINGHOLDING SL. Nombramientos. Adm. Unico: DS SMITH PACKAGING HOLDING SL. Representan: TAYLOR JASON MICHAEL.Apo.Sol.: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;DIAZ CRESPO ROSALIA;RODRIGUEZ TORRES IRIA;PEREZ SERRANO ISABEL;RUIZPE脩A SUSANA SONIA. Datos registrales. T 37165 , F 11, S 8, H M 663271, I/A 1 ( 7.02.18).