Buscador CIF Logo

Actos BORME Ds Smith Packaging Alcala Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ds Smith Packaging Alcala Sl

Actos BORME Ds Smith Packaging Alcala Sl - B80439367

Tenemos registrados 27 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ds Smith Packaging Alcala Sl con CIF B80439367

馃敊 Perfil de Ds Smith Packaging Alcala Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ds Smith Packaging Alcala Sl

15 de Octubre de 2021
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 40088 , F 145, S 8, H M 92446, I/A 43 ( 7.10.21).

28 de Julio de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: MORENO LOPEZ ISMAEL. Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ DAVID;MERINOLOPEZ VICTOR;CAMARERO CARRION CRISTINA;JUAREZ MERINO MARIA JESUS;NIETO RAPOSO NESTOR;NU脩EZ MAGROANA MARIA;DEL BARRIO VAQUERO ALVARO. Datos registrales. T 40088 , F 144, S 8, H M 92446, I/A 42 (21.07.21).

14 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: FREIXAS ACHAERANDIO LOURDES. Datos registrales. T 40088 , F 144, S 8, H M 92446, I/A 41 (

07 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apoderado: GARRIDO AGUIN ELENA. Apo.Sol.: FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO.Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO LOPEZ ISMAEL. Datos registrales. T 40088 , F 144, S 8, H M 92446, I/A 40 (29.04.21).

03 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apoderado: RIZZI PATRIZZIA;RIZZI PATRIZZIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BENITO FERNANDEZCARMEN;ALVAREZ DOMINGUEZ RUT. Datos registrales. T 40088 , F 143, S 8, H M 92446, I/A 39 (24.02.21).

13 de Octubre de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: CUESTA CASTRO LAURA. Datos registrales. T 40088 , F 143, S 8, H M 92446, I/A 38 ( 5.10.20).

24 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARRIOS RABAZAS ALFONSO. Apo.Sol.: FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO;ORTU脩O SIERRA MARIA CONCEPCION;IBA脩EZ PARADA MARIA LUISA. Datos registrales. T 40088 , F 141, S 8, H M92446, I/A 37 (17.08.20).

02 de Marzo de 2020
Revocaciones. Apoderado: PALACIOS ABRIL HECTOR. Datos registrales. T 40088 , F 140, S 8, H M 92446, I/A 34 (24.02.20).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: TEJEDOR DE ANDRES PEDRO LUCAS. Datos registrales. T 40088 , F 141, S 8, H M 92446, I/A 35(24.02.20).

Revocaciones. Apo.Manc.: VARELA RICO MARIA CRISTINA. Nombramientos. Apo.Manc.: VARELA RICO MARIA CRISTINA.Datos registrales. T 40088 , F 141, S 8, H M 92446, I/A 36 (24.02.20).

28 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;FRAILE ORDU脩A NIEVES;VARELA RICO MARIACRISTINA;FERREIRA MARQUES FERREIRA CARDOSO TIAGO. Datos registrales. T 40088 , F 140, S 8, H M 92446, I/A 33(21.02.20).

27 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: LARRIBA ARI脩O JOSE CARLOS;FREIXAS ACHAERANDIO LOURDES;GARRIDO AGUINELENA;RIZZI PATRIZZIA;MORROS RODRIGUEZ IGNACIO. Datos registrales. T 34295 , F 109, S 8, H M 92446, I/A 32 (20.02.20).

14 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: PALACIO CABRERO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 34295 , F 109, S 8, H M 92446, I/A 31 (7.02.20).

17 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER. Datos registrales. T 34295 , F 109, S 8, H M 92446, I/A 30 (

26 de Abril de 2019
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34295 , F 109, S 8, H M 92446, I/A 29 (19.04.19).

23 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Representan: ARON JEREMY ANDREW. Nombramientos. Representan: MONFORT GUASCH IGNACIO.Datos registrales. T 34295 , F 108, S 8, H M 92446, I/A 28 (12.04.19).

09 de Abril de 2019
Revocaciones. Apoderado: PAR UMBERT JUAN PABLO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TEJEDOR DE ANDRES PEDROLUCAS. Datos registrales. T 34295 , F 108, S 8, H M 92446, I/A 27 ( 2.04.19).

05 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: TAYLOR JASON MICHAEL. Nombramientos. Representan: ARON JEREMY ANDREW. Datosregistrales. T 34295 , F 107, S 8, H M 92446, I/A 26 (27.09.18).

11 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: GARCIA FAJARDO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 34295 , F 107, S 8, H M 92446, I/A 25(29.08.18).

07 de Agosto de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: CUESTA CASTRO LAURA. Datos registrales. T 34295 , F 107, S 8, H M 92446, I/A 24 (30.07.18).

24 de Julio de 2018
Revocaciones. Apoderado: ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO. Datos registrales. T 34295 , F 106, S 8, H M 92446, I/A 23(16.07.18).

19 de Abril de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTIN ESCOBAR JOSE MANUEL ANDRES. Datos registrales. T 34295 , F 106, S 8, H M 92446,I/A 22 (10.04.18).

20 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: CAZORLA PUJALTE JORGE;RIZZI PATRIZZIA;PALACIOS ABRIL HECTOR;PAR UMBERT JUANPABLO;CAZORLA PUJALTE JORGE;PALACIO CABRERO JOSE MANUEL;ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO;MORROSRODRIGUEZ IGNACIO;CAZORLA PUJALTE JORGE;GARCIA FAJARDO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 34295 , F 104, S8, H M 92446, I/A 21 ( 9.02.18).

02 de Enero de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER. Datos registrales. T 34295 , F 102, S 8, H M 92446, I/A 20(19.12.17).

23 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: LIENHARDT JEAN. Nombramientos. Representan: TAYLOR JASON MICHAEL. Datosregistrales. T 34295 , F 102, S 8, H M 92446, I/A 19 (15.06.17).

08 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: MARTIN ESCOBAR JOSE MANUEL ANDRES. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN ESCOBARJOSE MANUEL ANDRES;LOECHES HERNANDEZ RAMON;FORCADELL BEL JOAN ALBERT. Apo.Sol.: AYAS CARRETEROMARCO ANTONIO. Datos registrales. T 21427 , F 154, S 8, H M 92446, I/A 18 (29.02.16).

25 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;DIAZ CRESPO ROSALIA;RODRIGUEZ TORRES IRIA;PEREZSERRANO ISABEL;PEREZ MANSILLA DELGADO PATRICIA;RUIZ PE脩A SUSANA SONIA;RABES RODRIGUEZ MARTA. Datosregistrales. T 21427 , F 154, S 8, H M 92446, I/A 17 (17.02.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n