Actos BORME de Ds Smith Recycling Spain Sa
09 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALLEJA GUERRA JULIO JOSE. Apo.Manc.: CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;CALLEJA GUERRAJULIO JOSE. Apoderado: SANJUAN MORETA ALVARO MARIA;LAZARO ESTEBAN MARIA YOLANDA. Apo.Sol.: SANJUANMORETA ALVARO MARIA. Nombramientos. Apoderado: DIEZ GONZALEZ BELEN. Datos registrales. T 1557 , F 210, S 8, H VA23678, I/A 74 ( 2.10.23).
03 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANZ CARTON JUAN JOSE;FERNANDEZ CALZADA RAFAEL;SALCEDO REQUEJOINES;SERRANO RODRIGUEZ MIKEL;DA SILVA MOURA LUIS CARLOS. Datos registrales. T 1557 , F 150, S 8, H VA 23678, I/A 73(24.04.23).
23 de Febrero de 2023Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1557 , F 150, S 8, H VA 23678, I/A 72 (16.02.23).
22 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: INNERARITY GRAU JAVIER. Nombramientos. Apo.Sol.: PASCUAL ARANDA DAVID. Datosregistrales. T 1557 , F 144, S 8, H VA 23678, I/A 68 (15.11.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALTAMIRANO RETAMOSO LISSET;BETEGON BADAS LAURA. Datos registrales. T 1557 , F 145, S 8,H VA 23678, I/A 69 (15.11.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: PASCUAL SANZ ANA MARIA. Datos registrales. T 1557 , F 145, S 8, H VA 23678, I/A 70 (15.11.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RUIZ PABLO. Datos registrales. T 1557 , F 150, S 8, H VA 23678, I/A 71 (15.11.22).
29 de Junio de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: MENENDEZ PRADO JOSE ANTONIO. Apoderado: MENENDEZ PRADO JOSE ANTONIO;MENENDEZPRADO JOSE ANTONIO. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ PLEGUEZUELOS ALFONSO OSCAR. Apo.Sol.: FERNANDEZPLEGUEZUELOS ALFONSO OSCAR. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ DAVID. Datos registrales. T 1557 , F 144, S 8, H VA23678, I/A 67 (22.06.22).
06 de Junio de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: ALVAREZ TOQUERO MARIA ESTELA;BLANCO EXCALONA MARIA DEL PILAR;SIMIONALEXANDRA. Datos registrales. T 1557 , F 42, S 8, H VA 23678, I/A 66 (30.05.22).
04 de Enero de 2022Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: DS SMITH PORTUGAL SGPS SA. Reelecciones. Adm. Unico: DSSMITH SPAIN S.A. Datos registrales. T 1557 , F 41, S 8, H VA 23678, I/A 63 (28.12.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTUÑO SIERRA MARIA CONCEPCION. Datos registrales. T 1557 , F 42, S 8, H VA 23678, I/A 64(28.12.21).
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ DAVID;MERINO LOPEZ VICTOR;CAMARERO CARRION CRISTINA;NIETORAPOSO NESTOR;NUÑEZ MAGRO ANA MARIA;ALVAREZ DOMINGUEZ RUT. Datos registrales. T 1557 , F 42, S 8, H VA 23678,I/A 65 (28.12.21).
10 de Mayo de 2021Otros conceptos: Don Michael Harrison pasa a ser nueva persona física representante del administrador único. Datos registrales. T1557 , F 41, S 8, H VA 23678, I/A 62 (30.04.21).
21 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: BARRIOS RABAZAS ALFONSO;FRAILE ORDUÑA NIEVES;VARELA RICO MARIA CRISTINA.Apo.Sol.: FERNANDEZ PLEGUEZUELOS ALFONSO OSCAR. Datos registrales. T 1557 , F 41, S 8, H VA 23678, I/A 61 (14.08.20).
20 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: FRAILE ORDUÑA NIEVES;VARELA RICO MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 1557 , F 40, S 8, HVA 23678, I/A 59 (13.02.20).
Revocaciones. Apo.Manc.: CALVO OLIVARES ESTHER. Apoderado: CALVO OLIVARES ESTHER. Apo.Manc.: TEJEDOR DEANDRES PEDRO LUCAS. Datos registrales. T 1557 , F 40, S 8, H VA 23678, I/A 60 (13.02.20).