Buscador CIF Logo

Actos BORME Ds Smith Tct Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ds Smith Tct Sa

Actos BORME Ds Smith Tct Sa - A81827016

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ds Smith Tct Sa con CIF A81827016

馃敊 Perfil de Ds Smith Tct Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ds Smith Tct Sa

16 de Junio de 2021
Otros conceptos: Inscrita la fusi贸n por absorci贸n en la entidad "DS SMITH PACKAGIN CARTOGAL SA". Disoluci贸n. Fusion.Extinci贸n. Datos registrales. T 26131 , F 205, S 8, H M 198178, I/A 33 ( 9.06.21).

14 de Mayo de 2021
Otros conceptos: CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LOPRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM. Datos registrales. T 26131 , F 205, S 8, H M 198178, I/A 32/M ( 7.05.21).

16 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: RIZZI PATRIZZIA. Nombramientos. Apoderado: BENITO FERNANDEZ CARMEN;ALVAREZDOMINGUEZ RUT. Datos registrales. T 26131 , F 135, S 8, H M 198178, I/A 32 ( 9.03.21).

16 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: TEJEDOR DE ANDRES PEDRO LUCAS. Datos registrales. T 26131 , F 135, S 8, H M 198178, I/A 31( 9.11.20).

19 de Agosto de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: PALACIO CABRERO JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Manc.: CALLEJA GUERRA JULIO JOSE.Datos registrales. T 26131 , F 134, S 8, H M 198178, I/A 30 (12.08.20).

23 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Representan: ARON JEREMY ANDREW. Nombramientos. Representan: MONFORT GUASCH IGNACIO.Datos registrales. T 26131 , F 134, S 8, H M 198178, I/A 29 (12.04.19).

22 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: PAR UMBERT JUAN PABLO. Apo.Sol.: PAR UMBERT JUAN PABLO. Nombramientos. Apo.Man.Soli:

Revocaciones. Apo.Manc.: OULDARBIA OULDARBIA NOURA. Datos registrales. T 26131 , F 134, S 8, H M 198178, I/A 28(11.04.19).

13 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FREIXAS ACHAERANDIO LOURDES. Apo.Manc.: RIZZI PATRIZZIA;PALACIOS ABRILHECTOR;PAR UMBERT JUAN PABLO;PALACIO CABRERO JOSE MANUEL;MORROS RODRIGUEZ IGNACIO;OULDARBIAOULDARBIA NOURA. Apo.Sol.: PAR UMBERT JUAN PABLO. Datos registrales. T 26131 , F 131, S 8, H M 198178, I/A 26 (6.02.19).

05 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: TAYLOR JASON MICHAEL. Nombramientos. Representan: ARON JEREMY ANDREW. Datosregistrales. T 26131 , F 130, S 8, H M 198178, I/A 25 (27.09.18).

28 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: MORUECO OREJON BLANCA. Datos registrales. T 26131 , F 130, S 8, H M 198178, I/A 24 (20.12.17).

23 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: LIENHARDT JEAN. Nombramientos. Representan: TAYLOR JASON MICHAEL. Datosregistrales. T 26131 , F 130, S 8, H M 198178, I/A 23 (15.06.17).

05 de Abril de 2016
Revocaciones. Apoderado: ALONSO ALONSO LUIS;ALVAREZ DE TOLEDO MORENES CARLOS;LANTERO ROZPIDEJORGE;CALVO ANGUIS GLORIA;VILA GARRIDO DAVID;COFRADES ACEBES OLGA;LIENHARDT JEAN;ARON JEREMYANDREW;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER;SANCHEZ DAFOS JOSE ANTONIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: OLMOSFRANCINO DANIEL;CANTERO ALONSO DAVID. Apo.Manc.: MORUECO OREJON BLANCA;RODRIGUEZ LATORRE ALICIA.Apo.Sol.: AYAS CARRETERO MARCO ANTONIO. Datos registrales. T 26131 , F 98, S 8, H M 198178, I/A 22 (28.03.16).

29 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apoderado: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;DIAZ CRESPO ROSALIA;RODRIGUEZ TORRES IRIA;PEREZSERRANO ISABEL;PEREZ-MASILLA DELGADO PATRICIA;RUIZ PE脩A SUSANA SONIA;RABES RODRIGUEZ MARTA. Datosregistrales. T 26131 , F 98, S 8, H M 198178, I/A 21 (22.02.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n