Actos BORME de Dstilo Sa
09 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MURADAS JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 1195, L 1195, F 48, S 8, H PO 6452, I/A12 ( 3.10.18).
27 de Abril de 2018Reelecciones. Consejero: GONZALEZ MARTINEZ JUAN PEDRO;MURADAS ANTON OLGA;GONZALEZ MARTINEZ ALFREDO.Presidente: GONZALEZ MARTINEZ JUAN PEDRO. Secretario: MURADAS ANTON OLGA. Datos registrales. T 1195, L 1195, F 48,S 8, H PO 6452, I/A 11 (18.04.18).
20 de Noviembre de 2013Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: GONZALEZ MARTINEZ JUAN PEDRO;MURADAS ANTONOLGA;GONZALEZ MARTINEZ ALFREDO. Presidente: GONZALEZ MARTINEZ JUAN PEDRO. Secretario: MURADAS ANTON OLGA.Nombramientos. Consejero: GONZALEZ MARTINEZ JUAN PEDRO. Presidente: GONZALEZ MARTINEZ JUAN PEDRO. Consejero:MURADAS ANTON OLGA. Secretario: MURADAS ANTON OLGA. Consejero: GONZALEZ MARTINEZ ALFREDO. Modificacionesestatutarias. Artículo 12º.- El Consejo de Administración estará integrado por un número de tres socios, como minimo, y de nuevecomo máximo. Los Consejeros ejercerán sus cargos durante el periodo de CINCO AÑOS, y podrán ser reelegidos por la Junta Generalpor periodos de igual duración máxima.. Datos registrales. T 1195, L 1195, F 47, S 8, H PO 6452, I/A 10 (12.11.13).
30 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ MARTINEZ JUAN PEDRO;GONZALEZ MARTINEZ ALFREDO. Datos registrales. T 1195, L1195, F 3, S 8, H PO 6452, I/A 9 (17.06.10).
26 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: GONZALEZ MARTINEZ JUAN PEDRO;GONZALEZ MARTINEZ ALFREDO. Nombramientos.Apoderado: GONZALEZ MURADAS JUAN CARLOS. Datos registrales. T 1195, L 1195, F 2, S 8, H PO 6452, I/A 8 (15.06.09).