Actos BORME de Dugopa Sa
18 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: ALMAGRO AUDITORES SL. Datos registrales. T 30043 , F 223, S 8, H M 115452, I/A 86 (10.10.22).
27 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: ALBERTOS SALVADOR PEDRO CARLOS;CORBAL DURAN MANUEL ESTANISLAO;ARAMBURUGARCIA DE LA MATA CARLOS-LUIS;IZQUIERDO SENOVILLA JOSE MARIA;GARAGORRI GARCIA MANUEL;GARAGORRIGARCIA MANUEL;IZQUIERDO SENOVILLA JOSE MARIA. Datos registrales. T 30043 , F 222, S 8, H M 115452, I/A 84 (20.07.20).
Nombramientos. Apoderado: GARAGORRI GARCIA MANUEL;IZQUIERDO SENOVILLA JOSE MARIA;CORBAL DURAN MANUELESTANISLAO;ARAMBURU GARCIA DE LA MATA CARLOS. Datos registrales. T 30043 , F 223, S 8, H M 115452, I/A 85 (20.07.20).
23 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Consj. Supl.: IZQUIERDO SENOVILLA JOSE MARIA;GOMEZ AMAT FERNANDEZ ANGELES;ARAMBURUGARCIA DE LA MATA CARLOS. Consejero: CORBAL DURAN MANUEL;ALBERTOS SALVADOR PEDRO CARLOS;FERNANDEZESTEVEZ JUAN FRANCISCO. Secretario: ALBERTOS SALVADOR PEDRO CARLOS. Consejero: GONZALEZ DE LIS ANA MARIA.Presidente: CORBAL DURAN MANUEL. Consejero: ARAMBURU GARCIA DE LA MATA CARLOS. Nombramientos. Consejero:GONZALEZ DE LIS ANA MARIA;ARAMBURU GARCIA DE LA MATA CARLOS;GOMEZ-AMAT FERNANDEZ JULIO;MU脩OZ DURANNICOLAS;CORBAL DURAN MANUEL ESTANISLAO. Secretario: ARAMBURU GARCIA DE LA MATA CARLOS. Presidente: CORBALDURAN MANUEL ESTANISLAO. Datos registrales. T 30043 , F 220, S 8, H M 115452, I/A 81 (16.07.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CORBAL DURAN MANUEL ESTANISLAO;ARAMBURU GARCIA DE LA MATA CARLOS. Datosregistrales. T 30043 , F 220, S 8, H M 115452, I/A 82 (16.07.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: IZQUIERDO SENOVILLA JOSE MARIA. Apo.Manc.: GARAGORRI GARCIA MANUEL;CORBALDURAN MANUEL ESTANISLAO;ARAMBURU GARCIA DE LA MATA CARLOS. Datos registrales. T 30043 , F 222, S 8, H M115452, I/A 83 (16.07.20).
20 de Agosto de 2019Reelecciones. Auditor: ALMAGRO AUDITORES SL. Datos registrales. T 30043 , F 219, S 8, H M 115452, I/A 80 (12.08.19).
17 de Octubre de 2018Otros conceptos: Rectificada la inscripci贸n en cuanto a la revocaci贸n de los poderes otorgados a favor de Pedro Carlos AlbertosSalvador, Manuel Estanislao Corbal Duran, Carlos-Luis Aramburu Garc铆a de la Mata, Jos茅 Mar铆a Izquierdo Senovilla y ManuelGaragorri Garc铆a que motivaron las inscripciones 76, 77 y 78. Datos registrales. T 30043 , F 219, S 8, H M 115452, I/A 79M (8.10.18).
Otros conceptos: Rectificada la inscripci贸n en cuanto a la revocaci贸n de los apoderados Don Pedro Carlos Albertos Salvador, DonManuel Estanislao Corbal Duran y Don Carlos-Luis Aramburu Garc铆a de la Mata. Datos registrales. T 30043 , F 217, S 8, H M115452, I/A 76M ( 8.10.18).
Otros conceptos: Rectificada la inscripci贸n en cuanto a la revocaci贸n del apoderado Don Jos茅 Mar铆a Izquierdo Senovilla y DonManuel Garagorri Garc铆a. Datos registrales. T 30043 , F 218, S 8, H M 115452, I/A 77M ( 8.10.18).
Otros conceptos: Rectificada la inscripci贸n en cuanto a la revocaci贸n del apoderado Don Manuel Garagorri Garc铆a y Don Jose Mar铆aIzquierdo Senovilla. Datos registrales. T 30043 , F 218, S 8, H M 115452, I/A 78M ( 8.10.18).
20 de Agosto de 2018Revocaciones. Apoderado: IZQUIERDO JAEN JOSE MARIA;LOPEZ BARRIAL ALBERTO;ESCAMILLA NOTARIOANTONIO;FERNANDEZ NOTARIO FERNANDO;SERRA LOPEZ BERNARDO;CASENAVE LUCE脩O JUAN JOSE;MORAL NOTARIOCLARENCIO;IZQUIERDO SENOVILLA JOSE MARIA. Apo.Man.Soli: ARAMBURU GARCIA DE LA MATA CARLOS-LUIS;SERRALOPEZ BERNARDO;IZQUIERDO SENOVILLA JOSE MARIA. Apoderado: DA COSTA COELHO ANTONIO JORGE;CANUDASCOSTA CLARA MARIA;GOMEZ AMAT FERNANDEZ ANGELES;ALBERTOS SALVADOR PEDRO CARLOS;CORBAL DURANMANUEL. Apo.Man.Soli: GARAGORRI GARCIA MANUEL. Apoderado: ALBERTOS SALVADOR PEDRO CARLOS;CORBAL DURANMANUEL ESTANISLAO;ARAMBURU GARCIA DE LA MATA CARLOS-LUIS;IZQUIERDO SENOVILLA JOSE MARIA;GARAGORRIGARCIA MANUEL;GARAGORRI GARCIA MANUEL;IZQUIERDO SENOVILLA JOSE MARIA. Datos registrales. T 30043 , F 219, S 8,H M 115452, I/A 79 (10.08.18).
13 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: ALBERTOS SALVADOR PEDRO CARLOS;CORBAL DURAN MANUEL ESTANISLAO;ARAMBURUGARCIA DE LA MATA CARLOS-LUIS. Datos registrales. T 30043 , F 216, S 8, H M 115452, I/A 76 ( 6.08.18).
Nombramientos. Apoderado: IZQUIERDO SENOVILLA JOSE MARIA;GARAGORRI GARCIA MANUEL. Datos registrales. T 30043, F 218, S 8, H M 115452, I/A 77 ( 6.08.18).
Nombramientos. Apoderado: GARAGORRI GARCIA MANUEL;IZQUIERDO SENOVILLA JOSE MARIA. Datos registrales. T 30043, F 218, S 8, H M 115452, I/A 78 ( 6.08.18).
07 de Agosto de 2018Cambio de domicilio social. C/ ALCALA 18 3潞 (MADRID). Datos registrales. T 30043 , F 216, S 8, H M 115452, I/A 75 (31.07.18).
04 de Octubre de 2016Reelecciones. Auditor: ALMAGRO AUDITORES SL. Consejero: CORBAL DURAN MANUEL;ALBERTOS SALVADOR PEDROCARLOS;FERNANDEZ ESTEVEZ JUAN FRANCISCO. Secretario: ALBERTOS SALVADOR PEDRO CARLOS. Consejero:GONZALEZ DE LIS ANA MARIA. Presidente: CORBAL DURAN MANUEL. Consejero: ARAMBURU GARCIA DE LA MATA CARLOS.Datos registrales. T 30043 , F 216, S 8, H M 115452, I/A 74 (26.09.16).
24 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ AMAT JULIO. Presidente: GOMEZ AMAT JULIO. Vicepresid.: CORBAL DURAN MANUEL.Nombramientos. Consj. Supl.: ARAMBURU GARCIA DE LA MATA CARLOS. Presidente: CORBAL DURAN MANUEL. Consejero:ARAMBURU GARCIA DE LA MATA CARLOS. Otros conceptos: Revocado el poder conferido a Don Julio Gomez Amat, en escrituraautorizada ante el Notario de Madrid, Don Luis De la Fuente O'Connor, n煤mero 1990 de protocolo, el dia 25 de julio de 2006, quecaus贸 la inscripci贸n 54& de la hoja social. Datos registrales. T 30043 , F 215, S 8, H M 115452, I/A 73 (17.04.15).
14 de Octubre de 2013Reelecciones. Auditor: ALMAGRO AUDITORES SL. Datos registrales. T 30043 , F 215, S 8, H M 115452, I/A 72 ( 4.10.13).
14 de Marzo de 2013Reelecciones. ConsejSuplen: IZQUIERDO SENOVILLA JOSE MARIA. Consejero: CORBAL DURAN MANUEL. Vicepresid.: CORBALDURAN MANUEL. Consejero: GOMEZ AMAT JULIO;ALBERTOS SALVADOR PEDRO CARLOS;FERNANDEZ ESTEVEZ JUANFRANCISCOPresidente: GOMEZ AMAT JULIO. Secretario: ALBERTOS SALVADOR PEDRO CARLOS. ConsejSuplen: GOMEZ AMATFERNANDEZ ANGELES. Consejero: GONZALEZ DE LIS ANA MARIA. Datos registrales. T 30043 , F 214, S 8, H M 115452, I/A 71 (6.03.13).
16 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARAGORRI GARCIA MANUEL. Datos registrales. T 30043 , F 214, S 8, H M 115452, I/A 70 (6.11.12).
02 de Octubre de 2012Modificaciones estatutarias. 9. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales. T 30043 , F 214, S 8, H M 115452, I/A 69(21.09.12).
10 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: ALBERTOS SALVADOR PEDRO CARLOS;CORBAL DURAN MANUEL. Nombramientos. Apoderado:ALBERTOS SALVADOR PEDRO CARLOS;CORBAL DURAN MANUEL. Datos registrales. T 14629 , F 171, S 8, H M 115452, I/A 68(27.06.12).
26 de Agosto de 2011Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 16 Y 18 DE LOS ESTATUTOS.. Datos registrales. T 14629 , F171, S 8, H M 115452, I/A 67 (12.08.11).
29 de Octubre de 2010Reelecciones. Auditor: QUINTANA MARTIN Y ASOCIADOS AUDITORES SL;QUINTANA MARTIN Y ASOCIADOS AUDITORESSL;QUINTANA MARTIN Y ASOCIADOS AUDITORES SL. Datos registrales. T 14629 , F 171, S 8, H M 115452, I/A 65 (20.10.10).
Nombramientos. Auditor: ALMAGRO AUDITORES SL. Datos registrales. T 14629 , F 171, S 8, H M 115452, I/A 66 (20.10.10).
04 de Agosto de 2010Nombramientos. Apoderado: DA COSTA COELHO ANTONIO JORGE;CANUDAS COSTA CLARA MARIA. Datos registrales. T14629 , F 170, S 8, H M 115452, I/A 63 (26.07.10).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ AMAT FERNANDEZ ANGELES. Datos registrales. T 14629 , F 170, S 8, H M 115452, I/A 64(26.07.10).