Actos BORME de Duques De Bergara Sl
27 de Mayo de 2021Nombramientos. AUDIT.CUENT.: QS AUDIT CONSULTOR SLP. Datos registrales. T 46367 , F 26, S 8, H B 57680, I/A 51(19.05.21).
23 de Febrero de 2021Revocaciones. APODERADO: VALLET GOMEZ MANUEL. Datos registrales. T 46367 , F 25, S 8, H B 57680, I/A 50 (15.02.21).
24 de Agosto de 2020Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: PROMOTORA KASDE S.A. Datos registrales. T46367 , F 25, S 8, H B 57680, I/A 49 (14.08.20).
10 de Agosto de 2020Nombramientos. APODERAD.SOL: VALLET GARRIGA MANUEL. Datos registrales. T 46367 , F 24, S 8, H B 57680, I/A 48(31.07.20).
06 de Marzo de 2019Revocaciones. CONSEJERO: ESPEJO SANZ FELIPA. Datos registrales. T 46367 , F 24, S 8, H B 57680, I/A 47 (26.02.19).
25 de Enero de 2019Nombramientos. APODERAD.SOL: NAVAS MARQUES FELIX. Datos registrales. T 46367 , F 23, S 8, H B 57680, I/A 46(18.01.19).
15 de Junio de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.474,03 Euros. Resultante Suscrito: 2.511.321,79 Euros. Datos registrales. T 39736 , F 34, S 8, HB 57680, I/A 45 ( 7.06.18).
06 de Junio de 2018Nombramientos. AUDIT.CUENT.: QS AUDIT CONSULTOR SLP. Datos registrales. T 39736 , F 34, S 8, H B 57680, I/A 44(30.05.18).
07 de Junio de 2016Nombramientos. APODERAD.SOL: NAVAS MARQUES FELIX;VALENZUELA MORALES MANUEL. Datos registrales. T 39736 , F33, S 8, H B 57680, I/A 43 (30.05.16).
27 de Agosto de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: QUADRAS Y SERRA AUDITORES SL. Datos registrales. T 39736 , F 32, S 8, H B 57680, I/A 42(19.08.15).
19 de Noviembre de 2014Otros conceptos: LA SOCIEDAD HOLANDESA "GRASMERE BV",DOMICILIADA EN GRAVENHAGUE(PAISESBAJOS)ALEXANDERSTRAAT,23,QUEDA ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD "DUQUES DE BERGARA SL". Datos registrales. T39614 , F 10, S 8, H B 57680, I/A 41 (11.11.14).
31 de Marzo de 2014Revocaciones. CONSEJERO: VALLET GOMEZ GUILLERMO. PRESIDENTE: VALLET GOMEZ GUILLERMO. Nombramientos.CONSEJERO: ISGUIDOS SL. PRESIDENTE: ISGUIDOS SL. REPR.143 RRM: VALLET GOMEZ GUILLERMO. Datos registrales. T39614 , F 9, S 8, H B 57680, I/A 40 (20.03.14).
27 de Septiembre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 62.458,44 Euros. Resultante Suscrito: 2.507.847,76 Euros. Datos registrales. T 39614 , F9, S 8, H B 57680, I/A 39 (19.09.13).
12 de Febrero de 2013Modificaciones estatutarias. ART.19:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 39614 , F 9, S 8, H B 57680, I/A 38 ( 4.02.13).
25 de Mayo de 2012Nombramientos. AUDIT.CUENT.: QUADRAS Y SERRA AUDITORES SL. Datos registrales. T 39614 , F 8, S 8, H B 57680, I/A 37(15.05.12).
28 de Diciembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 62.458,44 Euros. Resultante Suscrito: 2.570.306,20 Euros. Datos registrales. T 39614 , F 8, S 8, HB 57680, I/A 36 (19.12.11).
03 de Mayo de 2010Revocaciones. ADM.UNICO: VALLET GOMEZ GUILLERMO. Nombramientos. CONSEJERO: MIR MERCADER GEMMA;AMANDAVALENZUELA;ESPEJO SANZ FELIPA;VALLET GOMEZ GUILLERMO. PRESIDENTE: VALLET GOMEZ GUILLERMO. SECR.NOCONS: MILLET SOLER MARIA ISABEL. Datos registrales. T 39614 , F 7, S 8, H B 57680, I/A 35 (20.04.10).
19 de Enero de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 43.696,26 Euros. Resultante Suscrito: 2.507.847,76 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: DOS MIL QUINIENTAS VEINTITRES SL. HOCATSA SL. Datos registrales. T 39614 , F 1, S 8, H B 57680, I/A 34 (8.01.10).
13 de Agosto de 2009Nombramientos. AUDIT.CUENT.: QUADRAS Y SERRA AUDITORES SL. Datos registrales. T 39614 , F 1, S 8, H B 57680, I/A 33 (3.08.09).
10 de Febrero de 2009Revocaciones. APODERADO: CANAL PUSO JOSEP. Datos registrales. T 39614 , F 1, S 8, H B 57680, I/A 32 (27.01.09).