Actos BORME de Dytras Sociedad Anonima
25 de Marzo de 2019Fe de erratas: En la inscripci贸n 89陋 se ha competado la parte dispositiva de cese de administrador concursal. Datos registrales. T4916 , F 66, S 8, H SE 4544, I/A 89 ( 4.03.19).
13 de Marzo de 2019Revocaciones. Apoderado: CASSILLAS OVANDO ALVARO JOSE;CASSILLAS OVANDO ALVARO JOSE;CRUZ DIAZ FRANCISCOJAVIER;CASSILLAS OVANDO ALVARO JOSE;FLORES GARCIA MANUEL;FLORES GARCIA MANUEL;FLORES GARCIAMANUEL;FLORES GARCIA MANUEL;CRUZ DIAZ FRANCISCO JAVIER;CRUZ DIAZ FRANCISCO JAVIER;FLORES GARCIAMANUEL;GUTIERREZ MORENO ALFONSO;CANDAU ROMERO ALVARO;ESPINOSA CABA脩AS MERCEDES;MANUEL GOMEZSANCHEZ. Apo.Sol.: SANCHEZ DE CUETO LORENZO JAVIER. Apo.Manc.: CRUZ DIAZ FRANCISCO JAVIER;CASSILLASOVANDO ALVARO JOSE;FLORES GARCIA MANUEL;FLORES GARCIA MANUEL;CASSILLAS OVANDO ALVARO JOSE;CRUZDIAZ FRANCISCO JAVIER;CASSILLAS OVANDO ALVARO JOSE;FLORES GARCIA MANUEL;CRUZ DIAZ FRANCISCO JAVIER.Apo.Sol.: DIAZ NOMBELA LUIS GREGORIO. Apoderado: SHOUEIRY GEORGE J.;FLORES GARCIA MANUEL. Apo.Man.Soli:FERNANDEZ MARTOS MARIA ISABEL. Apoderado: GUTIERREZ MORENO ALFONSO;ESPINOSA CABA脩AS MERCEDES;PI脩EROGRANDE DAVID. Apo.Man.Soli: FLORES GARCIA MANUEL. Apo.Manc.: CASSILLAS OVANDO ALVARO JOSE;CRUZ DIAZFRANCISCO JAVIER. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ MARTOS MARIA ISABEL. Apo.Manc.: CRUZ DIAZ FRANCISCO JAVIER;FLORESGARCIA MANUEL. Apo.Man.Soli: CRUZ DIAZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: CASSILLAS OVANDO ALVARO JOSE;FLORESGARCIA MANUEL. Apoderado: SANCHEZ DE CUETO LORENZO JAVIER;ESCAMILLA AMO ANTONIO;CARRABEO MARTINMIGUEL ANGEL;ALVAREZ GIL ALBERTO;ATIENZA AGUILAR CARLOS;DAMAS FERNANDEZ GLORIA ALEJANDRA;PAQUELOPEZ LUIS;CANDAU ROMERO ALVARO;DAMAS FERNANDEZ GLORIA ALEJANDRA. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ MARTOSMARIA ISABEL;FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE JESUS. Apoderado: CASSILLAS OVANDO ALVARO JOSE. Apo.Manc.:FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE JESUS;FERNANDEZ MARTOS MARIA ISABEL. Apoderado: ALVAREZ GIL ALBERTO. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 1335/2012. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 7/09/2017. Auto de conclusi贸n del concurso.Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SEVILLA. Juez: EDUARDO GOMEZLOPEZ. Resoluciones: CONCLUSION CONCURSO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1335/2012. Fecha de resoluci贸n26/12/2012. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞 1. Juez: EDUARDOGOMEZ LOPEZ. Administrador Concursal. Fecha 7/09/2017, NIF/CIF B79031290. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.Extinci贸n. Datos registrales. T 4916 , F 66, S 8, H SE 4544, I/A 89 ( 4.03.19).
19 de Abril de 2013Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1335/2012. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 26/12/2012. Auto de declaraci贸n deconcurso. Necesario. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞 1. Juez: EDUARDO GOMEZ LOPEZ. Resoluciones:DECLARACION DE CONCURSO NECESARIO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1335/2012. FIRME: Si, Fecha deresoluci贸n 26/12/2012. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n delconcursado. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞 1. Juez: EDUARDO GOMEZ LOPEZ. Resoluciones: INTERVENCIONDE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1335/2012. Fechade resoluci贸n 26/12/2012. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞 1. Juez: EDUARDOGOMEZ LOPEZ. Administrador Concursal. Fecha 26/12/2012, NIF/CIF B79031290. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORESSL. Datos registrales. T 4916 , F 64, S 8, H SE 4544, I/A 86 ( 8.04.13).
28 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ GIL ALBERTO. Datos registrales. T 4916 , F 63, S 8, H SE 4544, I/A 85 (14.03.12).
14 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE JESUS. Apo.Manc.: FERNANDEZ MARTOS MARIA ISABEL.Datos registrales. T 4916 , F 62, S 8, H SE 4544, I/A 84 ( 2.11.11).
10 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ MARTOS MARIA ISABEL. Apo.Manc.: FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE JESUS.Datos registrales. T 4916 , F 61, S 8, H SE 4544, I/A 83 (26.10.11).
31 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: FLORES GARCIA MANUEL. Secretario: FLORES GARCIA MANUEL. Nombramientos. Consejero:DAMAS FERNANDEZ GLORIA ALEJANDRA. Secretario: DAMAS FERNANDEZ GLORIA ALEJANDRA. Reelecciones. Consejero:FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE JESUS;FERNANDEZ MARTOS MARIA ISABEL;FERNANDEZ HEREDIA ENRIQUE RAMON.Presidente: FERNANDEZ HEREDIA ENRIQUE RAMON. Con.Delegado: FERNANDEZ HEREDIA ENRIQUE RAMON. Datosregistrales. T 4916 , F 61, S 8, H SE 4544, I/A 82 (10.10.11).
23 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apoderado: DAMAS FERNANDEZ GLORIA ALEJANDRA. Datos registrales. T 4916 , F 59, S 8, H SE 4544, I/A 80(12.09.11).
Nombramientos. Apoderado: CASSILLAS OVANDO ALVARO. Datos registrales. T 4916 , F 60, S 8, H SE 4544, I/A 81 (12.09.11).
02 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: CANDAU ROMERO ALVARO. Datos registrales. T 4916 , F 58, S 8, H SE 4544, I/A 79 (15.02.11).
13 de Diciembre de 2010Nombramientos. Auditor: MLB CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 4916 , F 58, S 8, H SE 4544, I/A 77 (24.11.10).
Nombramientos. Aud.C.Con.: MLB CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 4916 , F 58, S 8, H SE 4544, I/A 78 (24.11.10).
17 de Marzo de 2010Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ AGUDO ALVARO MARIO. Datos registrales. T 4916 , F 58, S 8, H SE 4544, I/A 76 (4.03.10).
19 de Enero de 2010Reelecciones. Auditor: ML & B CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 4916 , F 57, S 8, H SE 4544, I/A 74 (31.12.09).
Reelecciones. Aud.C.Con.: ML & B CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 4916 , F 57, S 8, H SE 4544, I/A 75 (31.12.09).
11 de Agosto de 2009Nombramientos. Apoderado: ATIENZA AGUILAR CARLOS. Datos registrales. T 4916 , F 56, S 8, H SE 4544, I/A 71 (24.07.09).
Nombramientos. Apoderado: DAMAS FERNANDEZ GLORIA ALEJANDRA. Datos registrales. T 4916 , F 56, S 8, H SE 4544, I/A 72(24.07.09).
Nombramientos. Apoderado: PAQUE LOPEZ LUIS. Datos registrales. T 4916 , F 57, S 8, H SE 4544, I/A 73 (24.07.09).
20 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ GIL ALBERTO. Datos registrales. T 4916 , F 55, S 8, H SE 4544, I/A 70 ( 8.07.09).
16 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: CARRABEO MARTIN MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4916 , F 54, S 8, H SE 4544, I/A 68(25.06.09).
Nombramientos. Apoderado: ESCAMILLA AMO ANTONIO. Datos registrales. T 4916 , F 55, S 8, H SE 4544, I/A 69 (25.06.09).
29 de Junio de 2009Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 2潞.-. Cambio de objeto social. LaSociedad tiene por objeto: a.- Construcci贸n, reparaci贸n y conservaci贸n de toda clase de obras.- b.- Realizaci贸n de todo tipo de trabajosde ingenier铆a, especialmente los destinados a tratamiento y depuraci贸n de aguas potables, industriales, residuales y de cualquier tipoque precise la industria,. Datos registrales. T 4351 , F 60, S 8, H SE 4544, I/A 65 (16.06.09).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ AGUDO ALVARO MARIO. Datos registrales. T 4916 , F 54, S 8, H SE 4544, I/A 66(17.06.09).
Revocaciones. Apoderado: PI脩ERO GRANDE DAVID. Datos registrales. T 4916 , F 54, S 8, H SE 4544, I/A 67 (17.06.09).
27 de Enero de 2009Nombramientos. Apoderado: JAVIER SANCHEZ DE CUETO LORENZO. Datos registrales. T 4351 , F 59, S 8, H SE 4544, I/A 64(13.01.09).