Actos BORME de Econectia Uniasser Sl
25 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SPENGER MEINRAD. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 42447 , F 96, S 8, HM 751202, I/A 15 (18.03.22).
26 de Noviembre de 2021Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SPOTTING BRANDS TECHNOLOGIES SL. Datos registrales. T 42447 , F 96, S 8,H M 751202, I/A 14 (19.11.21).
07 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUERRERO FERRER VICTOR;HUMBERT GUILLAUME PIERRE ANTOINE MARIN;MARIN DE LAPLAZA FRANCISCO JAVIER;DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS;LOPEZ FERNANDEZ JOSE GERMAN;SUAREZ GARCIA MIGUELANGEL;MEDINA SANTAMARIA ARTURO;FREIRE BARRAL PABLO. Datos registrales. T 42447 , F 82, S 8, H M 751202, I/A 3(30.09.21).
Nombramientos. Apoderado: JUANAS FABEIRO ALEXANDRA. Datos registrales. T 42447 , F 85, S 8, H M 751202, I/A 4(30.09.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PASCUAL ZARATE PILAR. Datos registrales. T 42447 , F 86, S 8, H M 751202, I/A 5 (30.09.21).
Nombramientos. Apoderado: MARTOS RIPOLL JORGE. Datos registrales. T 42447 , F 88, S 8, H M 751202, I/A 6 (30.09.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: CARDONA ARRANZ BELEN;LOIS CIGARRAN PEDRO;CALVO GOMEZ JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 42447 , F 88, S 8, H M 751202, I/A 7 (30.09.21).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ GRANADOS BELEN. Datos registrales. T 42447 , F 90, S 8, H M 751202, I/A 8 (30.09.21).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ TEJERA REBECA. Datos registrales. T 42447 , F 92, S 8, H M 751202, I/A 9 (30.09.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ-TELLO HERRERA JOSE CARLOS. Datos registrales. T 42447 , F 92, S 8, H M 751202, I/A10 (30.09.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: TEJEDOR CUESTA OSCAR. Datos registrales. T 42447 , F 93, S 8, H M 751202, I/A 11 (30.09.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: CASTA脩EDA GONZALEZ ALBERTO;GARCIA SANCHEZ JESUS MARIA. Datos registrales. T 42447 ,F 95, S 8, H M 751202, I/A 12 (30.09.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS FERNANDEZ MIGUEL;MONTERO SANCHEZ ANTONIO. Datos registrales. T 42447 , F95, S 8, H M 751202, I/A 13 (30.09.21).
22 de Septiembre de 2021Cambio de domicilio social. AVDA DE BRUSELAS 38 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 42447 , F 82, S 8, H M 751202, I/A 2(15.09.21).
14 de Septiembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: SPOTTING BRANDS TECHNOLOGIES SL;MARTI ALBELLA ENRIQUE JOSE;INVERSIONESLOCUA SL;ARENOS FERRER SANTIAGO;ARENOS FERRER MARIA JOSE. Con.Delegado: MARTI ALBELLA ENRIQUE JOSE.Presidente: INVERSIONES LOCUA SL. Consejero: RED LTE MM SL. SecreNoConsj: PINTO LOPEZ ALFONSO MARIA.Nombramientos. Adm. Unico: SPENCER MEINRAD. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 1571, L 1133, F 89, S 8, H CS 32954, I/A 8 ( 7.09.21).
24 de Diciembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 26.610,00 Euros. Resultante Suscrito: 80.020,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: MODIFICACION del art铆culo 5潞 de los estatutos sociales por aumento de capital.. Datos registrales. T 1571, L 1133, F89, S 8, H CS 32954, I/A 7 (16.12.19).
31 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: ARENOS FERRER MARIA JOSE. Datos registrales. T 1561, L 1123, F 163, S 8, H CS 32954, I/A 6(24.07.18).
24 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ARENOS FERRER SANTIAGO;MARTI ALBELLA ENRIQUE JOSE;ARENOS FERRER MARIA JOSE.Secretario: ARENOS FERRER SANTIAGO. Cons.Del.Sol: ARENOS FERRER SANTIAGO. Presidente: MARTI ALBELLA ENRIQUEJOSE. Cons.Del.Sol: MARTI ALBELLA ENRIQUE JOSE;ARENOS FERRER MARIA JOSE. Nombramientos. Consejero: ARENOSFERRER SANTIAGO;ARENOS FERRER MARIA JOSE;MARTI ALBELLA ENRIQUE JOSE;RED LTE MM SL;INVERSIONES LOCUASL;SPOTTING BRANDS TECHNOLOGIES SL. Presidente: INVERSIONES LOCUA SL. Con.Delegado: MARTI ALBELLA ENRIQUEJOSE. SecreNoConsj: PINTO LOPEZ ALFONSO MARIA. Ampliaci贸n de capital. Capital: 13.410,00 Euros. Resultante Suscrito:53.410,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: modificaci贸n del art铆culo 5潞 por ampliaci贸n del capital .Datos registrales. T 1561, L 1123, F 161, S 8, H CS 32954, I/A 5 (13.04.18).
15 de Octubre de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 20.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 40.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: ampliacion capital. mod. art.. Datos registrales. T 1561, L 1123, F 161, S 8, H CS 32954, I/A 4 ( 8.10.13).
02 de Abril de 2013Otros conceptos: subsanacion los errores que involuntariamente conten铆a la certificaci贸n del acta de la Junta de fecha 4 de octubrede 2012, protocolizada en la escritura otorgada en Vila-Real el 5 de Octubre de 2012, ante el Notario Don Jose Manuel SanchezAlmela, con el n煤mero 1801 de protocolo. Datos registrales. T 1561, L 1123, F 160, S 8, H CS 32954, I/A 3 (21.03.13).
30 de Octubre de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 20.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: MODIFICADO por aumento de capital.. Datos registrales. T 1561, L 1123, F 160, S 8, H CS 32954, I/A 2 (22.10.12).
11 de Abril de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 10.03.11. Objeto social: la consultor铆a y comercializaci贸n de productos y servicios detelecomunicaciones , incluidos servicios de operador de telecomunicaciones. La consultar铆a y comercializaci贸n de productos y serviciosinform谩ticos, redes y programas de aplicaci贸n. La formaci贸n en las 谩reas de la inform谩tica, telecomunic. Domicilio: C/ DUCATD'ATENES 8 BAJO (VILLARREAL). Capital: 10.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: ARENOS FERRER SANTIAGO;MARTIALBELLA ENRIQUE JOSE;ARENOS FERRER MARIA JOSE. Presidente: MARTI ALBELLA ENRIQUE JOSE. Secretario: ARENOSFERRER SANTIAGO. Cons.Del.Sol: ARENOS FERRER SANTIAGO;ARENOS FERRER MARIA JOSE;MARTI ALBELLA ENRIQUEJOSE. Otros conceptos: DISPENSA A LOS CONSEJEROS DE LA PROHIBICION DE COMPETENCIA. Datos registrales. T 1561,L 1123, F 159, S 8, H CS 32954, I/A 1 (25.03.11).