Actos BORME de Edetania Bus Sa
20 de Abril de 2023Reelecciones. Adm. Unico: NABAS BELTRAN SALVADOR MARIA. Datos registrales. T 7177, L 4480, F 204, S 8, H V 77596, I/A33 (13.04.23).
14 de Octubre de 2020Cambio de objeto social. 1.- La prestaci贸n del servicio p煤blico regular del transporte urbano e interurbano colectivo de viajeros enautob煤s, tanto en l铆neas regulares mediante explotaci贸n de Concesiones Administrativas, como de viajes discrecionales en laComunidad Valenciana. 2.- Alquiler de veh铆culos sin conductor. Datos registrales. T 7177, L 4480, F 204, S 8, H V 77596, I/A 32 (6.10.20).
13 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: NABAS BELTRAN JUAN PABLO;NABAS BELTRAN SALVADOR MARIA;NABAS ORENGASALVADOR. Secretario: NABAS BELTRAN SALVADOR MARIA. Presidente: NABAS ORENGA SALVADOR. Nombramientos. Adm.Unico: NABAS BELTRAN SALVADOR MARIA. Modificaciones estatutarias. Como consecuencia del cambio en la estructura del
02 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: RIUS LOPEZ ANA BELEN. Datos registrales. T 7177, L 4480, F 203, S 8, H V 77596, I/A 30
25 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: NABAS BELTRAN SALVADOR MARIA. Datos registrales. T 7177, L 4480, F 201, S 8, H V 77596, I/A29 (18.01.17).
21 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apoderado: RUBIO DIAZ DE TUDANCA JOSE LUIS;NABAS ORENGA SALVADOR;PEREZ LOZANO JOSEMARIA;SANTOS MARTIN ALVARO. Datos registrales. T 7177, L 4480, F 201, S 8, H V 77596, I/A 28 (14.12.16).
09 de Junio de 2016Cambio de domicilio social. AVDA MIGUEL HERNANDEZ 3 (ALDAIA). Datos registrales. T 7177, L 4480, F 201, S 8, H V 77596,I/A 27 ( 2.06.16).
21 de Enero de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: CATALAN LORENTE JOSE MARIA;CATALAN PARACUELLOS ANTONIO;AGUILAR ALMUDEVER LUIS.Datos registrales. T 7177, L 4480, F 199, S 8, H V 77596, I/A 26 (14.01.15).
29 de Septiembre de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 981.720,00 Euros. Resultante Suscrito: 836.280,00 Euros. Datos registrales. T 7177, L4480, F 199, S 8, H V 77596, I/A 25 (22.09.14).
16 de Julio de 2014Nombramientos. Auditor: FINAUDIT SLP. Datos registrales. T 7177, L 4480, F 198, S 8, H V 77596, I/A 24 ( 9.07.14).
28 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: NABAS BELTRAN JUAN PABLO;NABAS ORENGA SALVADOR;NABAS BELTRAN SALVADORMARIA. Presidente: NABAS ORENGA SALVADOR. Secretario: NABAS BELTRAN SALVADOR MARIA. Nombramientos. Consejero:NABAS ORENGA SALVADOR;NABAS BELTRAN JUAN PABLO;NABAS BELTRAN SALVADOR MARIA. Presidente: NABASORENGA SALVADOR. Secretario: NABAS BELTRAN SALVADOR MARIA. Datos registrales. T 7177, L 4480, F 198, S 8, H V 77596,I/A 23 (20.05.14).
23 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 201.000,00 Euros. Desembolsado: 201.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.818.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.818.000,00 Euros. Datos registrales. T 7177, L 4480, F 198, S 8, H V 77596, I/A 22 (14.02.11).
29 de Septiembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 220.000,00 Euros. Desembolsado: 220.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.617.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.617.000,00 Euros. Datos registrales. T 7177, L 4480, F 197, S 8, H V 77596, I/A 20 (18.09.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BOVAIRA LAPUERTA JOSE. Nombramientos. Consejero: NABAS BELTRAN JUAN PABLO.Cambio de domicilio social. C/ CIUDAD DE CARTAGENA 9 - POLIGONO INDUSTRIAL FU (PATERNA). Datos registrales. T7177, L 4480, F 198, S 8, H V 77596, I/A 21 (18.09.09).
18 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: NABAS ORENGA SALVADOR;NABAS BELTRAN SALVADOR MARIA;BOVAIRA LAPUERTA JOSE.Presidente: NABAS ORENGA SALVADOR. Vicepresid.: BOVAIRA LAPUERTA JOSE. Secretario: NABAS BELTRAN SALVADORMARIA. Nombramientos. Consejero: NABAS ORENGA SALVADOR;NABAS BELTRAN SALVADOR MARIA;BOVAIRA LAPUERTAJOSE. Presidente: NABAS ORENGA SALVADOR. Secretario: NABAS BELTRAN SALVADOR MARIA. Datos registrales. T 7177, L4480, F 197, S 8, H V 77596, I/A 19 ( 9.09.09).