Actos BORME de Edible Casings Sl
28 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3277 , F 214, S 8, H GI 4770, I/A 71 (20.12.23).
06 de Marzo de 2023Nombramientos. Apoderado: I脩AKI ELOSUA FRANCIA. Datos registrales. T 3277 , F 213, S 8, H GI 4770, I/A 69 (28.02.23).
26 de Octubre de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.426.068,29 Euros. Resultante Suscrito: 3.863.438,71 Euros. Ampliaci贸n de capital.Capital: 7.680.444,12 Euros. Resultante Suscrito: 11.543.882,83 Euros. Datos registrales. T 3277 , F 212, S 8, H GI 4770, I/A 68(20.10.22).
06 de Octubre de 2022Ceses/Dimisiones. Secretario: ESTEBAN MA脩A REY. Miem.CTE.CON: WILLY HOFMANN MONTAGUT. Nombramientos.SecreNoConsj: DAVID ELVIRA BENITO. Miem.CTE.CON: ELSA CRISTINA MERCEDES HOFMANN. Datos registrales. T 3277 , F212, S 8, H GI 4770, I/A 67 (29.09.22).
12 de Febrero de 2021Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. Nombramientos. Auditor:DELOITTE SL. Datos registrales. T 3277 , F 212, S 8, H GI 4770, I/A 66 ( 5.02.21).
15 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: ANNA ANTON MARTIN;JORDI ROQUER PRAT;PABLO DE LASTRES ANDRADA. Nombramientos.Apo.Manc.: MARCOS HOFMANN BATLLORI;SANDRA EGEA KRIER;I脩AKI ELOSUA FRANCIA;JORDI MERCADER CROS;JOSEPCUADROS BERTOLIN;JOSE ANTONIO RAFOLS LLACH;SANTIAGO LOPEZ CRESPI. Datos registrales. T 2397 , F 85, S 8, H GI4770, I/A 65 ( 4.12.20).
28 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: I脩AKI ELOSUA FRANCIA. Datos registrales. T 2397 , F 84, S 8, H GI 4770, I/A 64 (21.07.20).
15 de Junio de 2020Ceses/Dimisiones. Pres.CTE.CON: ROBERTO BLASCO BERNADAS. Miem.CTE.CON: ROBERTO BLASCO BERNADAS. Datosregistrales. T 2397 , F 84, S 8, H GI 4770, I/A 63 ( 8.06.20).
17 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: WILLY HOFMANN MONTAGUT. Nombramientos. Apo.Manc.: MARCOS HOFMANN BATLLORI.Datos registrales. T 2397 , F 82, S 8, H GI 4770, I/A 62 ( 5.12.19).
08 de Octubre de 2019Fe de erratas: En el env铆o 174 del a帽o 2013 se hizo constar com fecha de nombramiento el 11/11/2013 cuando deb铆a ser 01/01/2014.Datos registrales. T 2397 , F 32, S 8, H GI 4770, I/A 46 ( 9.12.13).
21 de Agosto de 2019Reelecciones. Auditor: AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. Datos registrales. T 2397 , F 82, S 8, H GI 4770, I/A 59(12.08.19).
Ceses/Dimisiones. Miem.CTE.CON: JOSE CUROS FERNANDEZ;MARCOS HOFMANN BATLLORI;PATRICK EDMOND KRIERGUNTHER. Nombramientos. Miem.CTE.CON: WILLY HOFMANN MONTAGUT;JOSE CUROS GARRETA;MONTSERRATDONADEU PARERA;EXPLIA SL. Modificaciones estatutarias. 23 BIS, del Comit茅 Consultivo, composici贸n, funciones, r茅gimen铆nterno y retribuci贸n. Datos registrales. T 2397 , F 82, S 8, H GI 4770, I/A 60 (12.08.19).
12 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: JOSE CUROS GARRETA. Nombramientos. Apo.Manc.: SANDRA EGEA KRIER. Modificaci贸n depoderes. Apo.Manc.: JOSE ANTONIO RAFOLS LLACH;WILLY HOFMANN MONTAGUT;PABLO DE LASTRES ANDRADA;ANNAANTON MARTIN;JORDI ROQUER PRAT;SANTIAGO LOPEZ CRESPI. Datos registrales. T 2397 , F 81, S 8, H GI 4770, I/A 58 (3.12.18).
07 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Presidente: GENERAL AUSETANA DE SERVEIS SL. Miem.CTE.CON: SANDRA EGEA KRIER. Cancelacionesde oficio de nombramientos. Auditor: AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. Nombramientos. Presidente: KRIWENS 2018SL. Miem.CTE.CON: PATRICK EDMOND KRIER GUNTHER. Datos registrales. T 2397 , F 81, S 8, H GI 4770, I/A 57 (30.10.18).
14 de Agosto de 2018Nombramientos. Consejero: FRANCISCO MONSO DE PRAT. Datos registrales. T 2397 , F 81, S 8, H GI 4770, I/A 55 ( 6.08.18).
18 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: PABLO DE LASTRES ANDRADA. Modificaci贸n de poderes. Apo.Manc.: JOSE ANTONIO RAFOLSLLACH;WILLY HOFMANN MONTAGUT;JOSE CUROS GARRETA;ANNA ANTON MARTIN;JORDI ROQUER PRAT;SANTIAGOLOPEZ CRESPI. Datos registrales. T 2397 , F 80, S 8, H GI 4770, I/A 54 ( 8.06.18).
05 de Octubre de 2016Nombramientos. Auditor: AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. Datos registrales. T 2397 , F 80, S 8, H GI 4770, I/A 52
04 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: FRANK HOFMANN HANKE. Nombramientos. Consejero: MARCOS HOFMANN BATLLORI. Datosregistrales. T 2397 , F 32, S 8, H GI 4770, I/A 50 (27.07.15).
16 de Abril de 2014Nombramientos. Presidente: CUR INVEST SL. Datos registrales. T 2397 , F 32, S 8, H GI 4770, I/A 49 ( 9.04.14).
15 de Abril de 2014Fe de erratas: En el envio 174 del a帽o 2013, se hizo constar el nombramiento de CUR INVENT SL como Presidente del Consejo deadministraci贸n, cuando en realidad s贸lo era nombrado como Consejero. Datos registrales. T 2397 , F 32, S 8, H GI 4770, I/A 46 (9.12.13).
24 de Diciembre de 2013Nombramientos. Auditor: AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. Datos registrales. T 2397 , F 32, S 8, H GI 4770, I/A 48(16.12.13).
17 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE CUROS GARRETA;ROBERTO BLASCO BERNADAS. Presidente: JOSE CUROS GARRETA.Nombramientos. Consejero: CUR INVEST SL. Presidente: CUR INVEST SL. Datos registrales. T 2397 , F 32, S 8, H GI 4770, I/A46 ( 9.12.13).
Nombramientos. Pres.CTE.CON: ROBERTO BLASCO BERNADAS. Miem.CTE.CON: ROBERTO BLASCO BERNADAS;JOSECUROS FERNANDEZ;MARCOS HOFMANN BATLLORI;SANDRA EGEA KRIER. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organode Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Comit茅 Consultivo. Datos registrales. T 2397 , F 32, S 8, H GI 4770, I/A 47 ( 9.12.13).
23 de Julio de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: JOSEP BOSCH LLADO. Nombramientos. Apo.Manc.: JOSE ANTONIO RAFOLS LLACH. Datosregistrales. T 2397 , F 31, S 8, H GI 4770, I/A 45 (15.07.13).
06 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: FRANK HOFMANN HANKE. Nombramientos. Presidente: JOSE CUROS GARRETA. Datosregistrales. T 2397 , F 30, S 8, H GI 4770, I/A 43 (24.07.12).
Modificaciones estatutarias. 11. Junta General. Consejo Administraci贸n y Comit茅 Consultivo..23 bis. Creaci贸n de un ComiteConsultivo.. Datos registrales. T 2397 , F 30, S 8, H GI 4770, I/A 44 (24.07.12).
10 de Agosto de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: JOAQUIN GALINDO ROURA;JOAQUIN GALINDO FLORENCE;JOSE CUROS GARRETA;JOSE CUROSGARRIGA;WILLY HOFMANN MONTAGUT;JORDI ROQUER PRAT;SANTIAGO LOPEZ CRESPI;JOSEP BOSCH LLADO;ANNAANTON MARTIN. Nombramientos. Apo.Manc.: WILLY HOFMANN MONTAGUT;JOSE CUROS GARRETA;JOSEP BOSCHLLADO;ANNA ANTON MARTIN;JORDI ROQUER PRAT;SANTIAGO LOPEZ CRESPI. Datos registrales. T 2397 , F 29, S 8, H GI4770, I/A 42 (27.07.10).
07 de Abril de 2010Nombramientos. Consejero: JOSE CUROS GARRETA. Datos registrales. T 2397 , F 29, S 8, H GI 4770, I/A 41 (23.03.10).
02 de Febrero de 2010Modificaciones estatutarias. Art铆culo 12, de quorum de adopci贸n de acuerdos..Art铆culo 22, de la retribuci贸n de losConsejeros..Art铆culo 23, del Conseo de Administrci贸n, r茅gimen interno, adopci贸n de acuerdos y delegaci贸n de facultades.. Datosregistrales. T 2397 , F 29, S 8, H GI 4770, I/A 40 (22.01.10).
29 de Enero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: JOAQUIN GALINDO FLORENCE. Presidente: JOAQUIN GALINDO FLORENCE. Consejero: NITTACASINGS INC;CURFICO SL;FRANK HOFMANN HANKE;SAFIPAK SL. Nombramientos. Consejero: FRANK HOFMANN HANKE.Presidente: FRANK HOFMANN HANKE. Consejero: SAFIPAK SL;ROBERTO BLASCO BERNADAS. Datos registrales. T 2397 , F29, S 8, H GI 4770, I/A 39 (20.01.10).