Actos BORME de Edificios Financiados Sl
28 de Enero de 2021Modificaciones estatutarias. Art铆culo 6潞. Modificaci贸n transmisi贸n participaciones sociales.. Datos registrales. T 1870 , F 113, S 8,H A 9078, I/A 19 (20.01.21).
18 de Diciembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 324.546,48 Euros. Resultante Suscrito: 3.567.006,22 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:3.200.388,90 Euros. Resultante Suscrito: 6.767.395,12 Euros. Datos registrales. T 1870 , F 112, S 8, H A 9078, I/A 17 ( 9.12.19).
14 de Junio de 2019Cambio de domicilio social. C/ JUAN DE LA CIERVA 31 1 B - PARQUE EMPRESARIAL (ELCHE). Datos registrales. T 1870 , F112, S 8, H A 9078, I/A 15 ( 6.06.19).
06 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: VALLS FERRANDEZ EVARISTO;VALLS FERRANDEZ FRANCISCO JAVIER;VALLS PASTOREVARISTO;FERRANDEZ ARTERO ANTONIA;VALLS FERRANDEZ JERONIMO ANTONIO;VALLS FERRANDEZ MERCEDES.Cons.Del.Man: VALLS FERRANDEZ EVARISTO;VALLS FERRANDEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: VALLS PASTOREVARISTO. Vicepresid.: FERRANDEZ ARTERO ANTONIA. Cons.Del.Man: VALLS FERRANDEZ JERONIMO ANTONIO. Secretario:VALLS FERRANDEZ MERCEDES. Cons.Del.Man: VALLS FERRANDEZ MERCEDES. Nombramientos. Consejero: VALLSPASTOR EVARISTO;VALLS FERRANDEZ EVARISTO;VALLS FERRANDEZ JERONIMO ANTONIO;VALLS FERRANDEZFRANCISCO JAVIER;VALLS FERRANDEZ MERCEDES. Presidente: VALLS PASTOR EVARISTO. Vicepresid.: VALLS FERRANDEZEVARISTO. Secretario: VALLS FERRANDEZ JERONIMO ANTONIO. Con.Delegado: VALLS FERRANDEZ JERONIMO ANTONIO.Datos registrales. T 1870 , F 104, S 8, H A 9078, I/A 14 (29.01.18).