Actos BORME de Edisun Power Iberia Gamma Sa
04 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apoderado: SOTO CEBOLLERO MARIA JOSE. Datos registrales. T 11467, L 8745, F 25, S 8, H V 214264, I/A 3(27.11.23).
21 de Noviembre de 2023Cambio de domicilio social. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 27 4 (VALENCIA). Datos registrales. T 11467, L 8745, F 25, S 8, H V214264, I/A 2 (14.11.23).
09 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ISENRICH RAINER NIKLAUS. Nombramientos. Adm. Mancom.: CHORRO LOPEZ JOSELUIS. Apo.Sol.: MORERA JUAN FELIPE;CHORRO LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 33645 , F 84, S 8, H M 605598, I/A 6 (2.06.22).
19 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ISENRICH RAINER NIKLAUS;SIMMEN RETO ALEXANDER. Nombramientos. Adm. Mancom.:ISENRICH RAINER NIKLAUS;COTTING RENE. Datos registrales. T 33645 , F 84, S 8, H M 605598, I/A 5 (12.11.21).
17 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ISENRICH RAINER NIKLAUS;SIMMEN RETO ALEXANDER. Nombramientos. Adm. Mancom.:ISENRICH RAINER NIKLAUS;SIMMEN RETO ALEXANDER. Datos registrales. T 33645 , F 83, S 8, H M 605598, I/A 4 ( 9.10.17).
06 de Octubre de 2015Revocaciones. Apoderado: SCHITTENHELM TOMAS. Nombramientos. Apoderado: SOTO CEBOLLERO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 33645 , F 82, S 8, H M 605598, I/A 3 (23.09.15).
13 de Julio de 2015Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 36 - 1º IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 33645 , F 68, S 8, HM 605598, I/A 2 ( 3.07.15).
01 de Septiembre de 2014Revocaciones. APOD.MANCOMU: LORENA GUBELLO. Nombramientos. APOD.MANCOMU: EVELINE SILVIA KUSTER. Datosregistrales. T 42783 , F 225, S 8, H B 329913, I/A 17 (22.08.14).
30 de Mayo de 2014Revocaciones. ADM.CONJUNTO: URS SCHERRER. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: RETO ALEXANDER SIMMEN. Datosregistrales. T 42783 , F 225, S 8, H B 329913, I/A 16 (22.05.14).
20 de Agosto de 2013Revocaciones. ADM.CONJUNTO: MARKUS KOHLER. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: URS SCHERRER. Datos registrales.T 42783 , F 224, S 8, H B 329913, I/A 14 (12.08.13).
Revocaciones. APODERADO: PETER TOGGWEILER;URS SCHERRER. Nombramientos. APOD.MANCOMU: LLOBELLGONZALEZ CARLOS;LORENA GUBELLO. Datos registrales. T 42783 , F 224, S 8, H B 329913, I/A 15 (12.08.13).
21 de Diciembre de 2012Revocaciones. APODERADO: URS MARKUS WIDMER. Nombramientos. APODERADO: URS SCHERRER. Datos registrales. T42783 , F 223, S 8, H B 329913, I/A 13 (12.12.12).
23 de Octubre de 2012Revocaciones. ADM.CONJUNTO: PETER TOGGWEILER. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: RAINER NIKLAUS ISENRICH.Datos registrales. T 42783 , F 220, S 8, H B 329913, I/A 10 (10.10.12).
Nombramientos. APODERADO: PETER TOGGWEILER. Datos registrales. T 42783 , F 221, S 8, H B 329913, I/A 11 (10.10.12).
Revocaciones. APODERADO: ROBERT KRONI. Nombramientos. APODERADO: LLOBELL GONZALEZ CARLOS. Datosregistrales. T 42783 , F 222, S 8, H B 329913, I/A 12 (10.10.12).
31 de Mayo de 2012Revocaciones. ADM.CONJUNTO: MIRJANA BLUME. APODERADO: MIRJANA BLUME. Nombramientos. ADM.CONJUNTO:PETER TOGGWEILER. Datos registrales. T 42783 , F 220, S 8, H B 329913, I/A 9 (22.05.12).
01 de Diciembre de 2011Nombramientos. APODERADO: URS MARKUS WIDMER. Cambio de domicilio social. AV RIERA PRINCIPAL Num.8 (ALELLA).Datos registrales. T 42783 , F 219, S 8, H B 329913, I/A 8 (17.11.11).
22 de Agosto de 2011Otros conceptos: Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberseexpedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de BARCELONA. Datos registrales. T5054 , F 70, S 8, H SE 82189, I/A 6A ( 3.08.11).
02 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: KRONI ROBERT. Nombramientos. Adm. Mancom.: KOHLER MARKUS. Datos registrales. T5054 , F 70, S 8, H SE 82189, I/A 6 (19.05.11).
19 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: SCHITTENHELM TOMAS. Datos registrales. T 5054 , F 68, S 8, H SE 82189, I/A 4 ( 4.05.09).
Nombramientos. Apoderado: BLUME MIRJANA. Datos registrales. T 5054 , F 69, S 8, H SE 82189, I/A 5 ( 5.05.09).
28 de Abril de 2009Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: EDISUN POWER IBERIA SA. Datos registrales. T 5054 , F 69, S 8,H SE 82189, I/A 3 (15.04.09).
26 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: TOGGWEILER PETER. Nombramientos. Adm. Mancom.: BLUME MIRJANA. Desembolso dedividendos pasivos. Desembolsado: 45.750,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 7. Domicilio.-.Artículo de los estatutos: 8. Capital.-. Cambio de domicilio social. AVDA REPUBLICA ARGENTINA 28 - EDIFICIO DOMO CENTE(BORMUJOS). Datos registrales. T 5054 , F 67, S 8, H SE 82189, I/A 2 (12.03.09).