Actos BORME de Ednon Sl
19 de Enero de 2021Nombramientos. Auditor: CAPELLA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2964, L 2964, F 120, S 8, H PO 35058, I/A 20(11.01.21).
22 de Noviembre de 2019Cambio de domicilio social. C/ COLON 28 7潞 B (VIGO). Datos registrales. T 2964, L 2964, F 120, S 8, H PO 35058, I/A 19(14.11.19).
19 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: ALBO MU脩OZ ISABEL. Datos registrales. T 2964, L 2964, F 120, S 8, H PO 35058, I/A 18 ( 9.07.19).
11 de Junio de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: DIAZ GARCIA JAVIER;ESTEVEZ MACHO CARLOS LUIS;ESTEVEZ MACHO CARLOS LUIS. Datosregistrales. T 2964, L 2964, F 120, S 8, H PO 35058, I/A 17 ( 3.06.19).
29 de Diciembre de 2017Nombramientos. Auditor: CAPELLA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2964, L 2964, F 119, S 8, H PO 35058, I/A 16(20.12.17).
11 de Enero de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ SUAREZ ANDRES IVAN;LOPEZ SUAREZ ANDRES IVAN;BIGLIANI ALESSANDRO. Datosregistrales. T 2964, L 2964, F 118, S 8, H PO 35058, I/A 15 (28.12.16).
10 de Enero de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: ARRAZOLA CABRERA MARCELO RODRIGO;DIAZ GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 2964, L2964, F 119, S 8, H PO 35058, I/A 14 (28.12.16).
05 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: ATAN CASTRO JAVIER. Datos registrales. T 2964, L 2964, F 118, S 8, H PO 35058, I/A 13(28.12.16).
12 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: ESPINA CERRILLO ROBERTO;ESPINA CERRILLO ROBERTO. Datos registrales. T 2964, L 2964, F118, S 8, H PO 35058, I/A 12 ( 4.04.16).
26 de Octubre de 2015Nombramientos. Auditor: JUAN CAPELLA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2964, L 2964, F 118, S 8, H PO 35058, I/A 11(19.10.15).
12 de Mayo de 2014Nombramientos. Apoderado: ATAN CASTRO JAVIER. Datos registrales. T 2964, L 2964, F 117, S 8, H PO 35058, I/A 9 ( 5.05.14).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 27.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 45.000,00 Euros. Datos registrales. T 2964, L 2964, F 117, S8, H PO 35058, I/A 10 ( 5.05.14).
15 de Octubre de 2012Nombramientos. Auditor: JUAN CAPELLA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2964, L 2964, F 117, S 8, H PO 35058, I/A 8(28.09.12).
10 de Agosto de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ SUAREZ ANDRES IVAN;ESTEVEZ MACHO CARLOS LUIS;LEIS CARLES PABLO;BIGLIANIALESSANDRO. Datos registrales. T 2964, L 2964, F 116, S 8, H PO 35058, I/A 7 (29.07.10).
09 de Julio de 2010Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ MEDIERO PAULA. Datos registrales. T 2964, L 2964, F 116, S 8, H PO 35058, I/A 6(29.06.10).
29 de Abril de 2010Nombramientos. Apoderado: ESPINA CERRILLO ROBERTO. Datos registrales. T 2964, L 2964, F 115, S 8, H PO 35058, I/A 5(15.04.10).
10 de Febrero de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ SUAREZ ANDRES IVAN;ESTEVEZ MACHO CARLOS LUIS;LEIS CARLES PABLO. Datosregistrales. T 2964, L 2964, F 114, S 8, H PO 35058, I/A 4 (28.01.09).