Buscador CIF Logo

Actos BORME Edp Renewables Europe Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Edp Renewables Europe Sl

Actos BORME Edp Renewables Europe Sl - B74137100

Tenemos registrados 61 Actos BORME del Registro Mercantil de Asturias para Edp Renewables Europe Sl con CIF B74137100

馃敊 Perfil de Edp Renewables Europe Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Asturias

Actos BORME de Edp Renewables Europe Sl

06 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: ARAUJO VINAGRE PEDRO. Apo.Manc.: ARAUJO VINAGRE PEDRO. Apo.Sol.: CAMINERO MU脩OZCARMEN. Datos registrales. T 3435 , F 212, S 8, H AS 32359, I/A 101 (24.02.23).

14 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: ABREU MANO RUI PEDRO. Apo.Sol.: ABREU MANO RUI PEDRO. Apo.Manc.: RODRIGUEZ PRADODAMIAN OSCAR. Apo.Sol.: RODRIGUEZ PRADO DAMIAN OSCAR. Apo.Manc.: FERNANDEZ HORTELANO MIGUEL. Apo.Sol.:FERNANDEZ HORTELANO MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: STILWELL DE ANDRADE MIGUEL. Apo.Manc.: STILWELL DEANDRADE MIGUEL. Apo.Sol.: RODRIGUES LOPES TEIXEIRA RUI MANUEL. Apo.Manc.: RODRIGUES LOPES TEIXEIRA RUIMANUEL. Apo.Sol.: DA CUNHA E LORENA ALVES MACHADO JOSE PEDRO. Apo.Manc.: DA CUNHA E LORENA ALVESMACHADO JOSE PEDRO;PINTO AMARAL BARBOSA JOAQUIM HENRIQUEApo.Sol.: PINTO AMARAL BARBOSA JOAQUIMHENRIQUE;VILA TRUNAS MIREIA. Apo.Manc.: VILA TRUNAS MIREIA. Apo.Sol.: COSTA FARELO ATHAYDE MARQUES FILIPEMIGUEL. Apo.Manc.: COSTA FARELO ATHAYDE MARQUES FILIPE MIGUEL. Apo.Sol.: CUNHA DE VASCONCELOS ALVES ANALIDIA;SALAS MONGE FABIAN. Datos registrales. T 3435 , F 211, S 8, H AS 32359, I/A 100 ( 7.02.23).

01 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Secretario: GARCIA-CONDE NORIEGA EMILIO. Revocaciones. Apo.Sol.: SICRE ROSAL ROCIO;GARCIA-CONDE NORIEGA EMILIO;MENDEZ-VILLAAMIL MENENDEZ MARTA;GARCIA-CONDE NORIEGA EMILIO. Apo.Manc.: GARCIA-CONDE NORIEGA EMILIO;RODRIGUEZ SANCHEZ BAUTISTA JULIO. Apo.Sol.: RODRIGUEZ SANCHEZ BAUTISTA JULIO.Apo.Manc.: MARTIN SEGURADO ESTRELLA. Apo.Sol.: MARTIN SEGURADO ESTRELLA;GARCIA-CONDE NORIEGA EMILIO.Apoderado: GARCIA ALAJARIN MARIA PAZ. Apo.Sol.: GARCIA ALAJARIN MARIA PAZ. Apo.Manc.: GARCIA ALAJARIN MARIAPAZ;MARTINIS SPYRIDON. Apo.Sol.: MARTINIS SPYRIDON. Nombramientos. SecreNoConsj: GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA.VsecrNoConsj: PEREZ DAPENA FRANCISCO DE BORJA. Apo.Sol.: CUNHA DE VASCONCELOS ALVES ANA LIDIA. Apo.Manc.:CUNHA DE VASCONCELOS ALVES ANA LIDIA. Apo.Sol.: RODRIGUEZ SANCHEZ BAUTISTA JULIO. Apo.Manc.: RODRIGUEZSANCHEZ BAUTISTA JULIO. Apo.Sol.: MENDEZ-VILLAAMIL MENENDEZ MARTA. Datos registrales. T 3435 , F 207, S 8, H AS32359, I/A 99 (23.02.22).

03 de Diciembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINIS SPYRIDON. Nombramientos. Consejero: COLLARES PEREIRA DE VASCONCELOSPEDRO. Datos registrales. T 3435 , F 207, S 8, H AS 32359, I/A 98 (24.11.21).

17 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3435 , F 207, S 8, H AS 32359, I/A97 ( 9.11.21).

28 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ HORTELANO MIGUEL. Apo.Sol.: FERNANDEZ HORTELANO MIGUEL. Datosregistrales. T 3435 , F 207, S 8, H AS 32359, I/A 96 (21.10.21).

23 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: MANSO NETO JOAO MANUEL. Presidente: MANSO NETO JOAO MANUEL. Revocaciones.Apo.Manc.: MANSO NETO JOAO MANUEL. Apo.Sol.: MANSO NETO JOAO MANUEL;MARTINIS SPYRIDON. Apo.Manc.: MARTINISSPYRIDON;RODRIGUEZ PRADO DAMIAN OSCAR. Apo.Sol.: RODRIGUEZ PRADO DAMIAN OSCAR;BURNAY SUMMAVIELLEJOAO PEDRO. Apo.Manc.: BURNAY SUMMAVIELLE JOAO PEDRO;BATISTA PIRES CELMA JOAO. Apo.Sol.: BATISTA PIRESCELMA JOAO. Nombramientos. Consejero: STILWELL DE ANDRADE MIGUEL. Presidente: STILWELL DE ANDRADE MIGUEL.Apo.Manc.: STILWELL DE ANDRADE MIGUEL;RODRIGUES LOPES TEIXEIRA RUI MANUEL;MARTINIS SPYRIDONApo.Sol.:STILWELL DE ANDRADE MIGUEL;RODRIGUES LOPES TEIXEIRA RUI MANUEL;MARTINIS SPYRIDON;MENDEZ-VILLAAMILMENENDEZ MARTA;GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA. Apo.Manc.: MENDEZ-VILLAAMIL MENENDEZ MARTA;GONZALEZRODRIGUEZ MARIA;CANO ASUA CRISTINA;RIVERA VIZCARRONDO JAVIER;BURNAY SUMMAVIELLE JOAOPEDRO;RODRIGUEZ SANCHEZ BAUTISTA JULIO;RODRIGUEZ PRADO DAMIAN OSCAR. Apo.Sol.: RODRIGUEZ PRADO DAMIANOSCAR;BURNAY SUMMAVIELLE JOAO PEDRO;BATISTA PIRES CELMA JOAO. Apo.Manc.: BATISTA PIRES CELMA JOAO.Modificaciones estatutarias. 21. Funcionamiento Junta General.-. 33. Organizaci贸n y de la administraci贸n de la sociedad.-. Datosregistrales. T 3435 , F 172, S 8, H AS 32359, I/A 95 (15.04.21).

15 de Enero de 2021
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MELO DE CASTRO BELO DUARTE. Vicepresid.: MARTINIS SPYRIDON. Nombramientos.Consejero: RODRIGUES LOPES RUI MANUEL. Con.Delegado: MELO DE CASTRO BELO DUARTE. Vicepresid.: RODRIGUESLOPES RUI MANUEL. Reelecciones. Consejero: MELO DE CASTRO BELO DUARTE. Datos registrales. T 3435 , F 171, S 8, HAS 32359, I/A 94 ( 4.01.21).

17 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Vicepresid.: MARTINIS SPYRIDON. Datos registrales. T 3435 , F 171, S 8, H AS 32359, I/A 93 ( 6.11.20).

19 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: GARRIDO SANZ MAURICIO. Apo.Sol.: GARRIDO SANZ MAURICIO. Datos registrales. T 3435 , F170, S 8, H AS 32359, I/A 92 (10.08.20).

07 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: BLANCO PEREZ EUGENIO. Nombramientos. Apoderado: CANO ASUA CRISTINA. Datos registrales. T3435 , F 170, S 8, H AS 32359, I/A 91 (27.09.19).

24 de Julio de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: CANO ASUA CRISTINA. Apo.Sol.: CANO ASUA CRISTINA. Datos registrales. T 3435 , F 167, S 8, HAS 32359, I/A 90 (15.07.19).

04 de Junio de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ GARCIA DEL CAMPO MANUEL. Apo.Sol.: FERNANDEZ GARCIA DEL CAMPOMANUEL;NEBREDA MOLINERO GABRIEL. Apo.Manc.: NEBREDA MOLINERO GABRIEL. Nombramientos. Apo.Manc.: NIETODANIEL EDUARDO JOSE. Apo.Sol.: NIETO DANIEL EDUARDO JOSE. Datos registrales. T 3435 , F 167, S 8, H AS 32359, I/A 89(24.05.19).

04 de Abril de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: TALAVAN LUQUE DAVID. Apo.Manc.: TALAVAN LUQUE DAVID. Datos registrales. T 3435 , F 159, S8, H AS 32359, I/A 88 (27.03.19).

08 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: MANSO NETO JOAO MANUEL. Apo.Manc.: MANSO NETO JOAO MANUEL. Apo.Sol.: MANSO NETOJOAO MANUEL. Apo.Manc.: MANSO NETO JOAO MANUEL. Apo.Sol.: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO.Apo.Manc.: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO. Apo.Sol.: MARTINIS SPYRIDON. Apo.Manc.: MARTINIS SPYRIDON.Nombramientos. Apo.Manc.: MANSO NETO JOAO MANUEL. Apo.Sol.: MANSO NETO JOAO MANUEL;MARTINIS SPYRIDON.Apo.Manc.: MARTINIS SPYRIDON;RODRIGUEZ PRADO DAMIAN OSCAR. Apo.Sol.: RODRIGUEZ PRADO DAMIANOSCAR;BURNAY SUMMAVIELLE JOAO PEDRO. Apo.Manc.: BURNAY SUMMAVIELLE JOAO PEDRO;BATISTA PIRES CELMAJOAO. Apo.Sol.: BATISTA PIRES CELMA JOAO. Datos registrales. T 3435 , F 156, S 8, H AS 32359, I/A 87 ( 1.03.19).

01 de Marzo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO. Datos registrales. T 3435 , F 156, S 8, H AS32359, I/A 85 (22.02.19).

Nombramientos. Consejero: MARTINIS SPYRIDON. Datos registrales. T 3435 , F 156, S 8, H AS 32359, I/A 86 (22.02.19).

05 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: NIETO DANIEL EDUARDO JOSE;SOLIS HERNANDEZ RAFAEL. Datos registrales. T 3435 , F 156, S 8,H AS 32359, I/A 84 (29.01.19).

15 de Octubre de 2018
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3435 , F 156, S 8, H AS 32359,I/A 83 ( 4.10.18).

27 de Julio de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: ABREU MANO RUI PEDRO. Apo.Sol.: ABREU MANO RUI PEDRO. Datos registrales. T 3435 , F 155,S 8, H AS 32359, I/A 82 (20.07.18).

17 de Julio de 2018
Nombramientos. Apoderado: TARDIEU BENLLOCH MONICA. Datos registrales. T 3435 , F 155, S 8, H AS 32359, I/A 81 (9.07.18).

24 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ LAHERA JAVIER. Apo.Manc.: MARTIN SEGURADO ESTRELLA. Apo.Sol.: MARTIN SEGURADOESTRELLA;BURNAY SUMMAVIELLE JOAO PEDRO;BATISTA PIRES CELMA JOAO.Apo.Manc.: BURNAY SUMMAVIELLE JOAOPEDRO;BATISTA PIRES CELMA JOAO;VEGA FERNANDEZ MIGUEL;DILLA QUINTERO DANIEL. Apo.Sol.: BURNAYSUMMAVIELLE JOAO PEDRO. Apo.Manc.: BATISTA PIRES CELMA JOAO. Apo.Sol.: BATISTA PIRES CELMA JOAO. Apo.Manc.:BURNAY SUMMAVIELLE JOAO PEDRO;DOS SANTOS PIRES JOSE LUIS;BARRETO CHUNG NUNO MIGUEL;PERESTRELO DA

12 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: DIAS AMARO MIGUEL. Apo.Manc.: DIAS AMARO MIGUEL;DIAS AMARO MIGUEL. Nombramientos.Apo.Sol.: MANSO NETO JOAO MANUEL. Apo.Manc.: MANSO NETO JOAO MANUEL. Apo.Sol.: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRAJOAO PAULO. Apo.Manc.: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO. Apo.Sol.: MARTINIS SPYRIDON. Apo.Manc.:MARTINIS SPYRIDON. Apo.Sol.: PEREZ MARTINEZ RAQUEL. Apo.Manc.: PEREZ MARTINEZ RAQUEL. Apo.Sol.: NEBREDAMOLINERO GABRIEL. Apo.Manc.: NEBREDA MOLINERO GABRIEL. Apo.Sol.: GARCIA ALAJARIN MARIA PAZ. Apo.Manc.: GARCIAALAJARIN MARIA PAZ. Datos registrales. T 3435 , F 66, S 8, H AS 32359, I/A 78 (30.11.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: EDP RENOVAVEIS SERVICIOS FINANCIEROS SA. Datos registrales. T 3435 , F 154, S 8, H AS32359, I/A 79 (30.11.17).

02 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAS AMARO MIGUEL. Con.Delegado: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO.Nombramientos. Consejero: MELO DE CASTRO BELO DUARTE. Con.Delegado: MELO DE CASTRO BELO DUARTE. Datosregistrales. T 3435 , F 66, S 8, H AS 32359, I/A 77 (24.10.17).

22 de Agosto de 2017
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3435 , F 66, S 8, H AS 32359, I/A 76 (11.08.17).

06 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO. Nombramientos. Con.Delegado:NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO. Reelecciones. Consejero: MANSO NETO JOAO MANUEL;NOGUEIRA DESOUSA COSTEIRA JOAO PAULO. Presidente: MANSO NETO JOAO MANUEL. Consejero: DIAS AMARO MIGUEL. Datosregistrales. T 3435 , F 66, S 8, H AS 32359, I/A 75 (27.06.17).

31 de Enero de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ GARCIA DEL CAMPO MANUEL. Apo.Manc.: FERNANDEZ GARCIA DEL CAMPOMANUEL. Datos registrales. T 3435 , F 50, S 8, H AS 32359, I/A 74 (23.01.17).

11 de Enero de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: VIESCAS FERNANDEZ CEFERINO. Apo.Sol.: VIESCAS FERNANDEZ CEFERINO. Datos registrales.T 3435 , F 50, S 8, H AS 32359, I/A 73 (30.12.16).

09 de Diciembre de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3435 , F 50, S 8, H AS 32359, I/A 72 (29.11.16).

12 de Abril de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: MANSO NETO JOAO MANUEL;DIAS AMARO MIGUEL;BURNAY SUMMAVIELLE JOAOPEDRO;BATISTA PIRES CELMA JOAO;DILLA QUINTERO DANIEL. Datos registrales. T 3435 , F 50, S 8, H AS 32359, I/A 71 (4.04.16).

16 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: SALAMANCA SEGOVIANO JUAN CARLOS. Apo.Manc.: LOBO GONCALVES ANTONIO MANUEL.Apoderado: VALLINA DEL ROSAL VALENTIN. Apo.Sol.: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO;RODRIGUES LOPESTEIXEIRA RUI MANUEL. Apo.Manc.: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO;RODRIGUES LOPES TEIXEIRA RUIMANUEL;RODRIGUES LOPES TEIXEIRA RUI MANUEL;NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO;BATISTA PIRES CELMAJOAO;BURNAY SUMMAVIELLE JOAO PEDRO;SOARES DE ALBERGARIA ALMIRO RUI MANUEL;DA PURIFICACAO CARVALHOEUGENIO ANDRE;PERESTRELO DA CAMARA RIBEIRO FERREIRA MIGUEL TIAGO;NUNES DO CARMO VITOR MANUEL;FLAVIONUNES ANTONIO;DA MOTA FERREIRA MARINHO ANA MARIA;GALHAVANO FRAGOSO JULIA EMILIA;RIBEIRO RODRIGUESFERREIRA ISABEL MARIA;MARTINS LOPES ALICE PATROCINIO;FERNANDES GASPAR MARIA ALICE DE JESUS;DOS SANTOSRODRIGUES HENRIQUE. Apoderado: GUERRERO MARTINEZ BURGOS ALMUDENA. Datos registrales. T 3435 , F 49, S 8, H AS32359, I/A 70 ( 5.11.15).

14 de Octubre de 2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3435 , F 49, S 8, H AS 32359, I/A 69 ( 5.10.15).

10 de Agosto de 2015
Nombramientos. Apoderado: GARCIA ALAJARIN MARIA PAZ. Datos registrales. T 3435 , F 49, S 8, H AS 32359, I/A 68(30.07.15).

21 de Julio de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: DOS SANTOS PIRES JOSE LUIS;BARRETO CHUNG NUNO MIGUEL;PERESTRELO DA CAMARARIBEIRO FERREIRA MIGUEL TIAGO;NUNES DO CARMO VITOR MANUEL;FLAVIO NUNES ANTONIO;DA MOTA FERREIRAMARINHO ANA MARIA;RIBEIRO RODRIGUES FERREIRA ISABEL MARIA;FERNANDES GASPAR MARIA ALICE DEJESUS;GOMES DE ALMEIDA CARLOS MIGUEL;BAPTISTA RASTEIRO JOAO;DOS SANTOS RODRIGUES HENRIQUE. Datosregistrales. T 3435 , F 48, S 8, H AS 32359, I/A 67 (13.07.15).

08 de Julio de 2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3435 , F 48, S 8, H AS 32359, I/A 66 (30.06.15).

23 de Junio de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: MANSO NETO JOAO MANUEL;DIAS AMARO MIGUEL. Apo.Manc.: MANSO NETO JOAOMANUEL;DIAS AMARO MIGUEL;NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO;MARTIN SEGURADO ESTRELLA. Apo.Sol.:MARTIN SEGURADO ESTRELLA;BURNAY SUMMAVIELLE JOAO PEDRO. Apo.Manc.: BATISTA PIRES CELMA JOAO;DILLAQUINTERO DANIEL;RIVERA VIZCARRONDO JAVIER. Apo.Sol.: RIVERA VIZCARRONDO JAVIER;GARCIA-CONDE NORIEGAEMILIO;BATISTA PIRES CELMA JOAO. Apo.Manc.: BURNAY SUMMAVIELLE JOAO PEDRO. Datos registrales. T 3435 , F 43, S 8,H AS 32359, I/A 65 (15.06.15).

11 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUES LOPES TEIXEIRA RUI MANUEL. Nombramientos. Consejero: DIAS AMAROMIGUEL. Datos registrales. T 3435 , F 43, S 8, H AS 32359, I/A 64 ( 3.06.15).

18 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO. Nombramientos. Con.Delegado:NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO. Reelecciones. Consejero: MANSO NETO JOAO MANUEL;RODRIGUES LOPESTEIXEIRA RUI MANUEL;NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO. Presidente: MANSO NETO JOAO MANUEL. Datosregistrales. T 3435 , F 42, S 8, H AS 32359, I/A 63 ( 7.08.14).

29 de Enero de 2014
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3435 , F 42, S 8, H AS 32359, I/A 62 (20.01.14).

03 de Septiembre de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3435 , F 42, S 8, H AS 32359, I/A 61 (22.08.13).

21 de Marzo de 2013
Nombramientos. Apoderado: GUERRERO MARTINEZ BURGOS ALMUDENA. Datos registrales. T 3435 , F 42, S 8, H AS 32359,I/A 60 (12.03.13).

13 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: MENENDEZ MENENDEZ MANUEL. Datos registrales. T 3435 , F 41, S 8, H AS 32359, I/A 58 (4.03.13).

Nombramientos. Apoderado: BATISTA PIRES CELMA JOAO. Datos registrales. T 3435 , F 41, S 8, H AS 32359, I/A 59 ( 4.03.13).

27 de Febrero de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 219.498.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 249.498.800,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales. T 3435 , F 41, S 8, H AS 32359, I/A 57 (18.02.13).

30 de Noviembre de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: ADAO DA FONSECA LUIS. Apo.Manc.: ADAO DA FONSECA LUIS;ADAO DA FONSECA LUIS;ADAO DAFONSECA LUIS;ADAO DA FONSECA LUIS;ADAO DA FONSECA LUIS;ADAO DA FONSECA LUIS;ADAO DA FONSECA LUIS;ADAODA FONSECA LUIS;ADAO DA FONSECA LUIS;ADAO DA FONSECA LUIS;ADAO DA FONSECA LUIS;ADAO DA FONSECALUIS;ADAO DA FONSECA LUIS;ADAO DA FONSECA LUIS;ADAO DA FONSECA LUIS. Apo.Sol.: ADAO DA FONSECA LUIS;PEONCADAVIECO JESUS. Apo.Manc.: MATEACHE SACRISTAN JAVIER;DE SOUSA TEIXEIRA JORGE FILIPE;CAPARROS GARCIAMIGUEL.Apo.Sol.: CAPARROS GARCIA MIGUEL. Datos registrales. T 3435 , F 41, S 8, H AS 32359, I/A 56 (20.11.12).

20 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: ADAO DA FONSECA LUIS. Datos registrales. T 3435 , F 41, S 8, H AS 32359, I/A 55 ( 6.11.12).

24 de Mayo de 2012
Ceses/Dimisiones. Presidente: MACHADO FERNANDES ANA MARIA. Consejero: MACHADO FERNANDES ANA MARIA.Nombramientos. Consejero: MANSO NETO JOAO MANUEL. Presidente: MANSO NETO JOAO MANUEL. Datos registrales. T3435 , F 40, S 8, H AS 32359, I/A 54 (14.05.12).

23 de Abril de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ ALVAREZ CASIMIRO;DE LA FUENTE ARIAS JOSE RAMON. Datos registrales. T 3435 ,F 40, S 8, H AS 32359, I/A 53 (12.04.12).

17 de Abril de 2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3435 , F 40, S 8, H AS 32359, I/A 52 ( 3.04.12).

22 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA-CONDE NORIEGA EMILIO. Apo.Manc.: GARCIA-CONDE NORIEGA EMILIO;RODRIGUEZSANCHEZ BAUTISTA JULIO;SICRE ROSAL ROCIO;ORTIZ PLAZA MANUEL;RIVERA VIZCARRONDO JAVIER;ANGEL DIAZJOSE;VIESCAS FERNANDEZ CEFERINO;LAINEZ ARACAMA IGNACIO;GALVAN GONZALEZ FRANCISCO. Apo.Sol.: RODRIGUEZSANCHEZ BAUTISTA JULIO;ORTIZ PLAZA MANUEL;BURNAY SUMMAVIELLE JOAO PEDRO;BATISTA PIRES CELMA JOAO.Apo.Manc.: BURNAY SUMMAVIELLE JOAO PEDRO;BATISTA PIRES CELMA JOAO;VEGA FERNANDEZ MIGUEL;DILLAQUINTERO DANIEL;NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO;RODRIGUES LOPES TEIXEIRA RUI MANUEL. Apo.Sol.:LOPEZ LAHERA JAVIER;ANGEL DIAZ JOSE;VIESCAS FERNANDEZ CEFERINO;LAINEZ ARACAMA IGNACIO;GALVANGONZALEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 3435 , F 35, S 8, H AS 32359, I/A 50 ( 9.03.12).

Nombramientos. Apo.Manc.: SOARES DE ALBERGARIA ALMIRO RUI MANUEL;DA PURIFICACAO CARVALHO EUGENIOANDRE;PERESTRELO DA CAMARA RIBEIRO FERREIRA MIGUEL TIAGO;NUNES DO CARMO VITOR MANUEL;FLAVIO NUNESANTONIO;DA MOTA FERREIRA MARINHO ANA MARIA;GALHAVANO FRAGOSO JULIA EMILIA;RIBEIRO RODRIGUES FERREIRAISABEL MARIA;MARTINS LOPES ALICE PATROCINIO;FERNANDES GASPAR MARIA ALICE DE JESUS;DOS SANTOSRODRIGUES HENRIQUE. Datos registrales. T 3435 , F 39, S 8, H AS 32359, I/A 51 ( 9.03.12).

25 de Noviembre de 2011
Revocaciones. Apo.Manc.: RUBIO BUENO JOAQUIN. Apo.Sol.: RUBIO BUENO JOAQUIN. Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINSEGURADO ESTRELLA. Apo.Sol.: MARTIN SEGURADO ESTRELLA. Datos registrales. T 3435 , F 34, S 8, H AS 32359, I/A 49(15.11.11).

08 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: ARRIBAS ARIAS FELIX;BLANCO PEREZ EUGENIO. Datos registrales. T 3435 , F 34, S 8, H AS 32359,I/A 48 (26.10.11).

13 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO. Nombramientos. Con.Delegado:NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO. Reelecciones. Consejero: MACHADO FERNANDES ANA MARIA;MENENDEZMENENDEZ MANUEL;ADAO DA FONSECA LUIS;RODRIGUES LOPES TEIXEIRA RUI MANUEL;NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRAJOAO PAULO. Presidente: MACHADO FERNANDES ANA MARIA. Datos registrales. T 3435 , F 33, S 8, H AS 32359, I/A 47(31.08.11).

11 de Febrero de 2011
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AGRUPACION EOLICA FRANCIA SL. Datos registrales. T 3435 , F 33, S 8, H AS32359, I/A 46 (28.01.11).

04 de Noviembre de 2010
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Ampliacion del objeto social. LA FINANCIACION DEPROYECTOS DE INSTALACIONES DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE CARACTER RENOVABLE. Datosregistrales. T 3435 , F 32, S 8, H AS 32359, I/A 45 (22.10.10).

11 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUES LOPES TEIXEIRA RUI MANUEL;DE SOUSA TEIXEIRA JORGE FILIPE;NOGUEIRA DESOUSA COSTEIRA JOAO PAULO;BATISTA PIRES CELMA JOAO;BURNAY SUMMAVIELLE JOAO PEDRO. Datos registrales. T3435 , F 32, S 8, H AS 32359, I/A 43 (29.09.10).

Nombramientos. Apoderado: MARTINIS SPYRIDON. Datos registrales. T 3435 , F 32, S 8, H AS 32359, I/A 44 (29.09.10).

05 de Julio de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: TARDIEU BENLLOCH MONICA. Apo.Sol.: TARDIEU BENLLOCH MONICA. Datos registrales. T 3435 ,F 32, S 8, H AS 32359, I/A 42 (24.06.10).

07 de Junio de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO BUENO JOAQUIN. Apo.Manc.: RUBIO BUENO JOAQUIN;NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRAJOAO PAULO. Datos registrales. T 3435 , F 31, S 8, H AS 32359, I/A 41 (26.05.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n