Actos BORME de Efi Cretaprint Sl
14 de Junio de 2023Otros conceptos: RECTIFICADA la inscripci贸n 32陋 en cuanto a la indicaci贸n del NIE X2337626K del apoderado Don REMCOHEINSDIJK. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 47, S 8, H CS 34979, I/A 33 ( 7.06.23).
09 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: HEINSDIJK REMCO. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 46, S 8, H CS 34979, I/A 32 (28.04.23).
21 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1687, L 1248,F 46, S 8, H CS 34979, I/A 31 (14.04.23).
27 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROMERO ARTIGAS ELISA. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 46, S 8, H CS 34979, I/A 30(19.12.22).
12 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: OLIN MARC DAVID. Nombramientos. Adm. Unico: PADILLA PEDRO JAVIER. Datos registrales.T 1687, L 1248, F 45, S 8, H CS 34979, I/A 29 ( 4.08.21).
28 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: AGUDO CARDO EVA. Apo.Man.Soli: ROMERO ARTIGAS ELISA;RAMON MORENO JOSE LUIS;ARNAIZAMADOR SANTIAGO. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 44, S 8, H CS 34979, I/A 26 (18.06.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROMERO ARTIGAS ELISA. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 44, S 8, H CS 34979, I/A 27(18.06.21).
Nombramientos. Apo.Manc.: AGUDO CARDO EVA. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 45, S 8, H CS 34979, I/A 28 (18.06.21).
01 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 43, S 8,H CS 34979, I/A 25 (24.11.20).
04 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: NATTEUCCI EVANDRO. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 43, S 8, H CS 34979, I/A 23 (26.05.20).
Nombramientos. Apoderado: JAVIER PADILLA PEDRO. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 43, S 8, H CS 34979, I/A 24(26.05.20).
17 de Marzo de 2020Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 42, S 8, H CS 34979, I/A 22 ( 9.03.20).
31 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GENE MARTIN ZAMISKA. Nombramientos. Adm. Unico: OLIN MARC DAVID. Datos registrales.T 1687, L 1248, F 42, S 8, H CS 34979, I/A 21 (16.01.20).
31 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GREEN BRANDON WAGNER. Nombramientos. Adm. Unico: GENE MARTIN ZAMISKA. Datosregistrales. T 1687, L 1248, F 42, S 8, H CS 34979, I/A 20 (22.01.19).
21 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 42, S 8, H CS 34979, I/A 19 (14.12.17).
03 de Noviembre de 2017Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 42, S 8, H CS 34979, I/A 18 (24.10.17).
10 de Agosto de 2016Revocaciones. Apoderado: GRANT THORNTON ASESORES SL;LOPEZ PELEGRIN DE SIMON ALFONSO;CRIPPS JR. PAULARNOLD;PILETTE VINCENT JEAN CLAUDE. Apo.Sol.: MOLINA CUBILLO BELEN;NAVARRO MARTINEZ-AVIALGONZALO;ROMERO CABELLO DE ALBA MANUEL;GOMEZ CUETARA MARTINEZ ISABEL;DE CUETO MORENO MANUEL.Apoderado: MATAMOROS UZ IGNACIO. Apo.Sol.: MATAMOROS UZ IGNACIO;DEL CAMPO LOPEZ INMACULADA;CEPRIACARLAMPIO SERGIO. Apoderado: WESSEL JOHANNES CORNELIS;DEN HARTOG DE REUS MARJOLIJN JANNETTE;MEIJERMIA KRISTIN. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 41, S 8, H CS 34979, I/A 17 (22.07.16).
06 de Mayo de 2016Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: MODIFICADO por cambio de domicilio.. Art铆culo de los estatutos:MODIFICADO por ampliaci贸n del objeto.. Cambio de domicilio social. C/ DELS IBERS 54 - POLIGONO INDUSTRIAL SUPOI-8(ALMAZORA). Cambio de objeto social. a.- La fabricaci贸n, compra, distribuci贸n, alquiler y venta de maquinaria industrial, as铆 comoel mantenimiento y venta de repuestos. b.- La fabricaci贸n, comercializaci贸n y distribuci贸n de todo tipo de tintas para la impresi贸n digital.c.- La distribuci贸n, venta, compra y promoci贸n para la venta de c. Datos registrales. T 1687, L 1248, F 41, S 8, H CS 34979, I/A 16(28.04.16).
09 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: ARMAIZ AMADOR SANTIAGO. Apo.Man.Soli: ROMERO ARTIGAS ELISA. Apo.Manc.: AGUDO CARDOEVA. Datos registrales. T 1611, L 1173, F 14, S 8, H CS 34979, I/A 15 (30.11.15).
16 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAMON MORENO JOSE LUIS;ROMERO ARTIGAS ELISA;ARNAIZ AMADOR SANTIAGO.Apo.Manc.: AGUDO CARDO EVA. Datos registrales. T 1611, L 1173, F 14, S 8, H CS 34979, I/A 14 ( 6.11.15).
20 de Abril de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: BLASCO CLARET VICTOR IGNACIO;BLASCO CLARET VICTOR IGNACIO. Datos registrales. T1611, L 1173, F 14, S 8, H CS 34979, I/A 13 (10.04.15).
31 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: KO BRYAN SEUK;GREEN BRANDON WEGNER. Nombramientos. Adm. Unico: GREENBRANDON WAGNER. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 1611, L 1173, F 14, S 8, H CS 34979, I/A 12 (22.12.14).
30 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datosregistrales. T 1611, L 1173, F 14, S 8, H CS 34979, I/A 11 (22.12.14).
26 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: TERCERO SANCHEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 1611, L 1173, F 14, S 8, H CS 34979, I/A 10(12.08.14).
30 de Julio de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: MATAMOROS UZ IGNACIO. Datos registrales. T 1611, L 1173, F 13, S 8, H CS 34979, I/A 8(21.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLASCO CLARET VICTOR IGNACIO;ROMERO ARTIGAS ELISA. Apo.Manc.: ARMAIZ AMADORSANTIAGO;AGUDO CARDO EVA. Datos registrales. T 1611, L 1173, F 13, S 8, H CS 34979, I/A 9 (21.07.14).
16 de Junio de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: CEPRIA CARLAMPIO SERGIO. Datos registrales. T 1611, L 1173, F 13, S 8, H CS 34979, I/A 7 (9.06.14).
28 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Auditor: AEC AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.Datos registrales. T 1611, L 1173, F 12, S 8, H CS 34979, I/A 6 (21.02.14).
16 de Julio de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLASCO CLARET VICTOR IGNACIO;MATAMOROS UZ IGNACIO. Apo.Manc.: CEPRIACARLAMPIO SERGIO;AGUDO CARDO EVA. Datos registrales. T 1611, L 1173, F 12, S 8, H CS 34979, I/A 5 ( 9.07.13).
25 de Marzo de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: MATAMOROS UZ IGNACIO;DEL CAMPO LOPEZ INMACULADA;CEPRIA CARLAMPIO SERGIO. Datosregistrales. T 1611, L 1173, F 12, S 8, H CS 34979, I/A 4 (15.03.13).
07 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ROSENZWEIG FRED;MALLOZZI FRANK. Nombramientos. Auditor: AEC AUDITORES SLP. Adm.Solid.: KO BRYAN SEUK;GREEN BRANDON WEGNER. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Modificado elArt铆culo 2潞 de losEstatutos por cambio del objeto social. Art铆culo de los estatutos: Modificado el Art铆culo 31潞 de los Estatutos por cambioen la fecha de cierre del ejercicio. Cambio de objeto social. a) La fabricaci贸n, compra, distribuci贸n, alquiler y venta de maquinariaindustrial, as铆 como el mantenimiento y venta de repuestos. b) La distribuci贸n, venta, compra y promoci贸n para la venta de cualquiertipo de software, hardware o cualquier otro tipo de material inform谩tico. Datos registrales. T 1611, L 1173, F 11, S 8, H CS 34979, I/A3 (30.01.13).