Actos BORME de Egasa Distribucion Sl
14 de Marzo de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38120 , F 144, S 8, H M 105851, I/A 56 ( 7.03.23).
09 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: FONDEVILA TABOADA MANUEL ANGEL. Datos registrales. T 38120 , F 144, S 8, H M 105851, I/A 55( 2.03.23).
12 de Abril de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38120 , F 144, S 8, H M 105851, I/A 54 ( 5.04.22).
11 de Abril de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: RACERO GARCIA FRANCISCO MIGUEL;RUBIO TORRES FRANCISCO. Datos registrales. T 38120 , F144, S 8, H M 105851, I/A 53 ( 4.04.22).
28 de Septiembre de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38120 , F 144, S 8, H M 105851, I/A 52 (21.09.21).
19 de Julio de 2021Revocaciones. Apoderado: MAYORAL MARTINEZ JUAN;GARCIA-BORREGON MILLAN AMADEO JOSE;GARCIA ORDO脩EZALBERTO;RUFAS MARTINEZ GUSTAVO;GOMEZ MECA JUAN MANUEL;GARCIA RODRIGUEZ JOSE RAMON. Datos registrales.T 38120 , F 143, S 8, H M 105851, I/A 50 (12.07.21).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: LUCKIA GAMING GROUP SA. Datos registrales. T 38120 , F 143,S 8, H M 105851, I/A 51 (12.07.21).
14 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: MA脩AS CALVET ALBERTO. Datos registrales. T 38120 , F 142, S 8, H M 105851, I/A 49 ( 6.10.20).
27 de Febrero de 2020Revocaciones. Apoderado: RODAL GIL ALFONSO. Datos registrales. T 38120 , F 142, S 8, H M 105851, I/A 48 (20.02.20).
26 de Febrero de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38120 , F 142, S 8, H M 105851, I/A 47 (19.02.20).
16 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: COUCEIRO DORADO ANTONIO;GONZALEZ FUENTES JOSE ALFREDO;BERTOLO OTERO JOSEROBERTO;MA脩AS CALVET ALBERTO. Datos registrales. T 38120 , F 141, S 8, H M 105851, I/A 46 ( 5.12.19).
18 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apoderado: RUIZ GALVEZ MARCELO. Datos registrales. T 38120 , F 141, S 8, H M 105851, I/A 45 (11.11.19).
20 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ FUENTES JOSE. Datos registrales. T 6499 , F 210, S 8, H M 105851, I/A 43 (13.09.18).
Nombramientos. Apoderado: RUIZ GALVEZ MARCELO. Datos registrales. T 38120 , F 140, S 8, H M 105851, I/A 44 (13.09.18).
18 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apoderado: FREIRE DURO JOSE MARIA. Datos registrales. T 6499 , F 210, S 8, H M 105851, I/A 42 (11.09.18).
22 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: RACERO GARCIA MIGUEL. Datos registrales. T 6499 , F 210, S 8, H M 105851, I/A 41 (14.02.17).
27 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 6499 , F 210, S 8, H M 105851, I/A 40 (19.01.17).
19 de Octubre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: CEBRIAN SUAREZ ISABEL;SIMON MOSQUERA PILAR;GONZALEZ MANTEIGA EVA. Datosregistrales. T 6499 , F 209, S 8, H M 105851, I/A 39 (19.09.16).
20 de Junio de 2016Reelecciones. Auditor: BARCELONA AUDITORS SL. Datos registrales. T 6499 , F 209, S 8, H M 105851, I/A 38 ( 9.06.16).
12 de Abril de 2016Reelecciones. Auditor: BARCELONA AUDITORS SL. Datos registrales. T 6499 , F 209, S 8, H M 105851, I/A 37 ( 5.04.16).
31 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GONZALEZ FUENTES JOSE ALFREDO;GONZALEZ FUENTES JOSE. Nombramientos. Adm.Unico: GONZALEZ FUENTES JOSE ALFREDO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoressolidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 6499 , F 207, S 8, H M 105851, I/A 34 (23.12.15).
Nombramientos. Apoderado: RODAL GIL ALFONSO. Datos registrales. T 6499 , F 208, S 8, H M 105851, I/A 35 (23.12.15).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA RODRIGUEZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 6499 , F 208, S 8, H M 105851, I/A 36(23.12.15).
03 de Julio de 2014Revocaciones. Apoderado: LOPEZ REBOREDO CARLOS;LOPEZ REBOREDO CARLOS. Datos registrales. T 6499 , F 207, S 8, HM 105851, I/A 33 (25.06.14).
06 de Mayo de 2014Nombramientos. Auditor: BARCELONA AUDITORS SL. Datos registrales. T 6499 , F 207, S 8, H M 105851, I/A 32 (24.04.14).
23 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: BARCELONA AUDITORS SL. Datos registrales. T 6499 , F 207, S 8, H M 105851, I/A 31 (14.01.13).
05 de Octubre de 2012Nombramientos. Apoderado: RAMALLAL JIMENEZ DE LLANO JOSE LUIS. Datos registrales. T 6499 , F 206, S 8, H M 105851, I/A30 (25.09.12).
19 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: BARCELONA AUDITORS SL. Datos registrales. T 6499 , F 206, S 8, H M 105851, I/A 29 ( 9.01.12).
16 de Noviembre de 2011Cambio de objeto social. Distribuci贸n, comercializaci贸n, fabricaci贸n, producci贸n... de toda clase de productos y material apto paraser instalado y/o dar servicio a establecimientos de hosteler铆a. Datos registrales. T 6499 , F 206, S 8, H M 105851, I/A 28 (31.10.11).
22 de Septiembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 30.050,00 Euros. Resultante Suscrito: 90.150,00 Euros. Datos registrales. T 6499 , F 205, S 8, H M105851, I/A 27 (10.09.09).
13 de Marzo de 2009Nombramientos. Apoderado: RUFAS MARTINEZ GUSTAVO;GOMEZ MECA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 6499 , F 204, S8, H M 105851, I/A 26 ( 3.03.09).
13 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: RUFAS MARTINEZ GUSTAVO;GOMEZ MECA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 6499 , F 204, S8, H M 105851, I/A 25 ( 4.02.09).