Buscador CIF Logo

Actos BORME Egasa Distribucion Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Egasa Distribucion Sl

Actos BORME Egasa Distribucion Sl - B79001061

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Egasa Distribucion Sl con CIF B79001061

馃敊 Perfil de Egasa Distribucion Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Egasa Distribucion Sl

14 de Marzo de 2023
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38120 , F 144, S 8, H M 105851, I/A 56 ( 7.03.23).

09 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: FONDEVILA TABOADA MANUEL ANGEL. Datos registrales. T 38120 , F 144, S 8, H M 105851, I/A 55( 2.03.23).

12 de Abril de 2022
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38120 , F 144, S 8, H M 105851, I/A 54 ( 5.04.22).

11 de Abril de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: RACERO GARCIA FRANCISCO MIGUEL;RUBIO TORRES FRANCISCO. Datos registrales. T 38120 , F144, S 8, H M 105851, I/A 53 ( 4.04.22).

28 de Septiembre de 2021
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38120 , F 144, S 8, H M 105851, I/A 52 (21.09.21).

19 de Julio de 2021
Revocaciones. Apoderado: MAYORAL MARTINEZ JUAN;GARCIA-BORREGON MILLAN AMADEO JOSE;GARCIA ORDO脩EZALBERTO;RUFAS MARTINEZ GUSTAVO;GOMEZ MECA JUAN MANUEL;GARCIA RODRIGUEZ JOSE RAMON. Datos registrales.T 38120 , F 143, S 8, H M 105851, I/A 50 (12.07.21).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: LUCKIA GAMING GROUP SA. Datos registrales. T 38120 , F 143,S 8, H M 105851, I/A 51 (12.07.21).

14 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apoderado: MA脩AS CALVET ALBERTO. Datos registrales. T 38120 , F 142, S 8, H M 105851, I/A 49 ( 6.10.20).

27 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: RODAL GIL ALFONSO. Datos registrales. T 38120 , F 142, S 8, H M 105851, I/A 48 (20.02.20).

26 de Febrero de 2020
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38120 , F 142, S 8, H M 105851, I/A 47 (19.02.20).

16 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: COUCEIRO DORADO ANTONIO;GONZALEZ FUENTES JOSE ALFREDO;BERTOLO OTERO JOSEROBERTO;MA脩AS CALVET ALBERTO. Datos registrales. T 38120 , F 141, S 8, H M 105851, I/A 46 ( 5.12.19).

18 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: RUIZ GALVEZ MARCELO. Datos registrales. T 38120 , F 141, S 8, H M 105851, I/A 45 (11.11.19).

20 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ FUENTES JOSE. Datos registrales. T 6499 , F 210, S 8, H M 105851, I/A 43 (13.09.18).

Nombramientos. Apoderado: RUIZ GALVEZ MARCELO. Datos registrales. T 38120 , F 140, S 8, H M 105851, I/A 44 (13.09.18).

18 de Septiembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: FREIRE DURO JOSE MARIA. Datos registrales. T 6499 , F 210, S 8, H M 105851, I/A 42 (11.09.18).

22 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apoderado: RACERO GARCIA MIGUEL. Datos registrales. T 6499 , F 210, S 8, H M 105851, I/A 41 (14.02.17).

27 de Enero de 2017
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 6499 , F 210, S 8, H M 105851, I/A 40 (19.01.17).

19 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: CEBRIAN SUAREZ ISABEL;SIMON MOSQUERA PILAR;GONZALEZ MANTEIGA EVA. Datosregistrales. T 6499 , F 209, S 8, H M 105851, I/A 39 (19.09.16).

20 de Junio de 2016
Reelecciones. Auditor: BARCELONA AUDITORS SL. Datos registrales. T 6499 , F 209, S 8, H M 105851, I/A 38 ( 9.06.16).

12 de Abril de 2016
Reelecciones. Auditor: BARCELONA AUDITORS SL. Datos registrales. T 6499 , F 209, S 8, H M 105851, I/A 37 ( 5.04.16).

31 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GONZALEZ FUENTES JOSE ALFREDO;GONZALEZ FUENTES JOSE. Nombramientos. Adm.Unico: GONZALEZ FUENTES JOSE ALFREDO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoressolidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 6499 , F 207, S 8, H M 105851, I/A 34 (23.12.15).

Nombramientos. Apoderado: RODAL GIL ALFONSO. Datos registrales. T 6499 , F 208, S 8, H M 105851, I/A 35 (23.12.15).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA RODRIGUEZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 6499 , F 208, S 8, H M 105851, I/A 36(23.12.15).

03 de Julio de 2014
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ REBOREDO CARLOS;LOPEZ REBOREDO CARLOS. Datos registrales. T 6499 , F 207, S 8, HM 105851, I/A 33 (25.06.14).

06 de Mayo de 2014
Nombramientos. Auditor: BARCELONA AUDITORS SL. Datos registrales. T 6499 , F 207, S 8, H M 105851, I/A 32 (24.04.14).

23 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: BARCELONA AUDITORS SL. Datos registrales. T 6499 , F 207, S 8, H M 105851, I/A 31 (14.01.13).

05 de Octubre de 2012
Nombramientos. Apoderado: RAMALLAL JIMENEZ DE LLANO JOSE LUIS. Datos registrales. T 6499 , F 206, S 8, H M 105851, I/A30 (25.09.12).

19 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: BARCELONA AUDITORS SL. Datos registrales. T 6499 , F 206, S 8, H M 105851, I/A 29 ( 9.01.12).

16 de Noviembre de 2011
Cambio de objeto social. Distribuci贸n, comercializaci贸n, fabricaci贸n, producci贸n... de toda clase de productos y material apto paraser instalado y/o dar servicio a establecimientos de hosteler铆a. Datos registrales. T 6499 , F 206, S 8, H M 105851, I/A 28 (31.10.11).

22 de Septiembre de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 30.050,00 Euros. Resultante Suscrito: 90.150,00 Euros. Datos registrales. T 6499 , F 205, S 8, H M105851, I/A 27 (10.09.09).

13 de Marzo de 2009
Nombramientos. Apoderado: RUFAS MARTINEZ GUSTAVO;GOMEZ MECA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 6499 , F 204, S8, H M 105851, I/A 26 ( 3.03.09).

13 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apoderado: RUFAS MARTINEZ GUSTAVO;GOMEZ MECA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 6499 , F 204, S8, H M 105851, I/A 25 ( 4.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n