Actos BORME de Eis Maritimo Sa
10 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: AUDICEF ASESORES SL. Datos registrales. T 41008 , F 181, S 8, H M 297814, I/A 84 ( 3.10.22).
04 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ BARROSO BENIGNO. Datos registrales. T 41008 , F 181, S 8, H M 297814, I/A 83(25.02.22).
17 de Marzo de 2021Fe de erratas: Se public贸 por error la inscripci贸n 35陋 de fecha 23/02/2021, siendo la correcta la 82陋 de fecha 25/02/2021. Datosregistrales. T 41008 , F 181, S 8, H M 297814, I/A 82 (25.02.21).
04 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: SUAREZ FERNANDEZ MARIA JESUS. Datos registrales. T 26891 , F 34, S 8, H M 297814, I/A 81(25.02.21).
02 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ CAMPILLO LUIS. Datos registrales. T 41008 , F 181, S 8, H M 297814, I/A 35 (23.02.21).
12 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: GAIZKA ERAUZQUIN NAVARRO JOSU. Datos registrales. T 26891 , F 33, S 8, H M 297814, I/A 80 (5.02.21).
29 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ ALONSO LUIS-TEOGENES;RUIZ ALONSO MANUEL;LUENGO MANJON JESUS GASPAR.Presidente: RUIZ ALONSO LUIS-TEOGENES. Cons.Del.Sol: RUIZ ALONSO LUIS-TEOGENES;LUENGO MANJON JESUS GASPAR.Nombramientos. Representan: LUENGO MANJON JESUS GASPAR. Consejero: DIRENOR SL;NOEMA Y VALL SL. Representan:RUIZ ALONSO LUIS TEOGENES;RUIZ ALONSO MANUEL. Presidente: PARTHELIO SL. Cons.Del.Sol: DIRENOR SL;PARTHELIOSL;NOEMA Y VALL SL. Consejero: PARTHELIO SL. Reelecciones. SecreNoConsj: MENDAZONA DE PABLOS KARMELE. Datosregistrales. T 26891 , F 31, S 8, H M 297814, I/A 79 (22.01.20).
11 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ ALONSO LUIS TEOGENES. Presidente: RUIZ ALONSO LUIS TEOGENES. Consejero: RUIZALONSO MANUEL;LUENGO MANJON JESUS GASPAR. Cons.Del.Sol: LUENGO MANJON JESUS GASPAR;RUIZ ALONSO LUISTEOGENES. Secretario: MENDAZONA DE PABLOS KARMELE. Nombramientos. Consejero: RUIZ ALONSO LUIS-TEOGENES;RUIZ ALONSO MANUEL;LUENGO MANJON JESUS GASPAR. Presidente: RUIZ ALONSO LUIS-TEOGENES.Cons.Del.Sol: RUIZ ALONSO LUIS-TEOGENES;LUENGO MANJON JESUS GASPAR. SecreNoConsj: MENDAZONA DE PABLOSKARMELE. Datos registrales. T 26891 , F 29, S 8, H M 297814, I/A 78 (30.11.19).
09 de Julio de 2019Reelecciones. Auditor: AUDICEF ASESORES SL. Datos registrales. T 26891 , F 29, S 8, H M 297814, I/A 77 ( 2.07.19).
23 de Abril de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ ECHEVERRIA BIENVENIDO;LOPEZ MARTIN LUIS CARLOS;ORTU脩O MORENTEMANUEL;LOPEZ BELTRAN EMILIO;ROMERO NAVARRO MANUEL;CORTES RAMIS RAFAEL;AUNEAU JEAN MICHEL GERARD.Datos registrales. T 26891 , F 28, S 8, H M 297814, I/A 76 (10.04.18).
13 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: CRESPI ORELL MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 26891 , F 28, S 8, H M 297814, I/A 75 (5.03.18).
12 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: CRESPI ORELL MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 26891 , F 28, S 8, H M 297814, I/A 72 (5.03.18).
Nombramientos. Apoderado: MARZA BATTAINI MASSIMILIANO. Datos registrales. T 26891 , F 28, S 8, H M 297814, I/A 73 (5.03.18).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ BARROSO BENIGNO. Datos registrales. T 26891 , F 28, S 8, H M 297814, I/A 74 (5.03.18).
30 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Auditor: EUROREVISION SL. Nombramientos. Auditor: AUDICEF ASESORES SL. Datos registrales. T 26891, F 27, S 8, H M 297814, I/A 71 (20.01.17).
22 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: EUROREVISION SL. Datos registrales. T 26891 , F 27, S 8, H M 297814, I/A 70 (14.12.15).
11 de Febrero de 2015Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 31 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. . Datos registrales. T 26891 , F27, S 8, H M 297814, I/A 69 ( 3.02.15).
08 de Enero de 2015Reelecciones. Consejero: RUIZ ALONSO LUIS TEOGENES. Presidente: RUIZ ALONSO LUIS TEOGENES. Consejero: RUIZALONSO MANUEL;LUENGO MANJON JESUS GASPAR. Cons.Del.Sol: LUENGO MANJON JESUS GASPAR;RUIZ ALONSO LUISTEOGENES. Secretario: MENDAZONA DE PABLOS KARMELE. Datos registrales. T 26891 , F 26, S 8, H M 297814, I/A 68(29.12.14).
27 de Mayo de 2013Revocaciones. Apoderado: ALEPUZ TORRECILLA JOSEFA. Datos registrales. T 26891 , F 26, S 8, H M 297814, I/A 67 (20.05.13).
27 de Diciembre de 2012Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 60.000,00 Euros. Datos registrales. T 26891 , F 26, S 8, H M 297814, I/A 66(18.12.12).
25 de Septiembre de 2012Reelecciones. Auditor: EUROREVISION SL. Datos registrales. T 26891 , F 26, S 8, H M 297814, I/A 65 (12.09.12).
03 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: ALEPUZ TORRECILLA JOSEFA. Datos registrales. T 26891 , F 26, S 8, H M 297814, I/A 64(24.01.12).
22 de Marzo de 2011Cambio de objeto social. Gestion integral de prestaci贸n de servicios y suministros a buques. Comercio al por mayor, compra y venta,ejercido directamente o por cuenta de terceros, de todo tipo de productos de alimentaci贸n, bebidas, perfumer铆a, complementos ytabacos con entidades de car谩cter p煤lbico y privado de cualquier c. Datos registrales. T 26891 , F 25, S 8, H M 297814, I/A 63(10.03.11).
13 de Septiembre de 2010Cambio de domicilio social. C/ OQUENDO 23 - PLANTA 4潞 (MADRID). Datos registrales. T 26891 , F 25, S 8, H M 297814, I/A 62( 1.09.10).
21 de Abril de 2010P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 300.000,00 Euros. Resultante Suscrito:300.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 300.000,00 Euros. Desembolsado: 240.000,00 Euros. Resultante Suscrito:600.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 540.000,00 Euros. Datos registrales. T 26891 , F 24, S 8, H M 297814, I/A 61(12.04.10).
19 de Abril de 2010Nombramientos. Auditor: EUROREVISION SL. Datos registrales. T 26891 , F 24, S 8, H M 297814, I/A 60 ( 8.04.10).
01 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: GALAN RODRIGUEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 26891 , F 23, S 8, H M 297814, I/A 59(19.01.10).
28 de Enero de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: RUIZ ALONSO LUIS-TEOGENES;RUIZ ALONSO MANUEL. Nombramientos. SecreNoConsj:MENDAZONA DE PABLOS KARMELE. Consejero: RUIZ ALONSO LUIS TEOGENES. Presidente: RUIZ ALONSO LUIS TEOGENES.Consejero: RUIZ ALONSO MANUEL;LUENGO MANJON JESUS GASPAR. Cons.Del.Sol: LUENGO MANJON JESUS GASPAR;RUIZALONSO LUIS TEOGENES. Modificaciones estatutarias. ART. 16.-. ART. 28.-. ART. 30.-. ART. 31.-. Datos registrales. T 26891 ,F 21, S 8, H M 297814, I/A 58 (19.01.10).
09 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: MARZA BATTAINI MASSIMILIANO;RODRIGUEZ BARROSO BENIGNO. Datos registrales. T 26891 , F21, S 8, H M 297814, I/A 57 (26.11.09).
11 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: RIGO MARTORELL JUAN. Apo.Manc.: LOPEZ MARTIN LUIS CARLOS;NAVARRO ROMEROMANUEL;NAVARRO MORENO MANUEL;LOPEZ MARTINEZ LUIS CARLOS. Datos registrales. T 26891 , F 21, S 8, H M 297814,I/A 56 (29.10.09).
19 de Octubre de 2009Cambio de domicilio social. AVDA MENENDEZ PELAYO, NUMERO 2, 3潞-DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 26891 , F20, S 8, H M 297814, I/A 55 ( 6.10.09).
06 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RUIZ ALONSO MANUEL. Nombramientos. Adm. Solid.: RUIZ ALONSO LUIS-TEOGENES;RUIZALONSO MANUEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradoressolidarios.QUEDAN MODIFICADOS LOS ARTICULOS 16, 28, 30 Y 31 DE LOS ESTATUTOS - IMPLICANDO EL CAMBIO DEORGANO SOCIAL -. Art铆culo de los estatutos: 32. Cierre del Ejercicio.-. Cambio de domicilio social. C/ ALCALA 119 2潞 (MADRID).Datos registrales. T 17360 , F 223, S 8, H M 297814, I/A 50 (27.07.09).
Revocaciones. Apo.Manc.: AUNEAU JEAN MICHEL GERARD. Apo.Sol.: VERDERA SERVERA GUILLERMO;CRESPI ORELLMIGUEL ANGEL;MELGUIZO BERMUDEZ FRANCISCO JOSE;POL ROMO PEDRO. Apoderado: LLORET LLORET MARCOS.Apo.Sol.: MARCH SORIANO NURIA. Apoderado: ESCRIBANO MU脩OZ AMADOR. Apo.Man.Soli: SANCHEZ GUTIERREZ JOSE.Apoderado: DELGADO ROSELL RICARDO;CORTES RAMIS RAFAEL. Datos registrales. T 17360 , F 224, S 8, H M 297814, I/A 51(27.07.09).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 539.400,00 Euros. Desembolsado: 271.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 600.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 331.600,00 Euros. Datos registrales. T 17360 , F 225, S 8, H M 297814, I/A 52 (28.07.09).
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 268.400,00 Euros. Datos registrales. T 26891 , F 20, S 8, H M 297814, I/A 53(28.07.09).
Nombramientos. Auditor: EUROREVISION SL. Datos registrales. T 26891 , F 20, S 8, H M 297814, I/A 54 (28.07.09).