Actos BORME de Eja Instalaciones Sa
18 de Julio de 2023Reelecciones. Adm. Solid.: TARIN TRUCHADO DAVID;PEREZ ZAFRA MANUEL. Datos registrales. T 30605 , F 13, S 8, H M54596, I/A 31 (11.07.23).
17 de Julio de 2023Cambio de domicilio social. C/ NU脩EZ DE BALBOA, NUMERO 120 (MADRID). Datos registrales. T 30605 , F 13, S 8, H M 54596,I/A 30 (10.07.23).
25 de Mayo de 2017Reelecciones. Adm. Solid.: TARIN TRUCHADO DAVID;PEREZ ZAFRA MANUEL. Datos registrales. T 30605 , F 12, S 8, H M54596, I/A 29 (17.05.17).
09 de Octubre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 93.471,00 Euros. Resultante Suscrito: 171.241,00 Euros. Datos registrales. T 30605 , F11, S 8, H M 54596, I/A 28 ( 1.10.13).
29 de Enero de 2013Nombramientos. Auditor: GTC AUDITORES SL. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 54.712,00 Euros. Desembolsado: 54.712,00Euros. Resultante Suscrito: 264.712,00 Euros. Resultante Desembolsado: 264.712,00 Euros. Modificaciones estatutarias. 11.Funcionamiento Junta Gral.-.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Otros conceptos: Se deja sin contenido el art铆culo 12 de losEstatutos Sociales. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.ejainstalaciones.com. Fusi贸n porabsorci贸n. Sociedades absorbidas: SITEC SA. Datos registrales. T 25607 , F 177, S 8, H M 54596, I/A 27 (18.01.13).
29 de Febrero de 2012Nombramientos. Auditor: G T C AUDITORES SL. Datos registrales. T 25607 , F 177, S 8, H M 54596, I/A 26 (17.02.12).
16 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: TARIN TRUCHADO DAVID. Secretario: PEREZ ZAFRA MANUEL. Consejero: PEREZ ESTEBANMANUEL;TARIN MARTIN FEDERICO;TARIN TRUCHADO DAVID;PEREZ ZAFRA MANUEL. Cons.Del.Sol: TARIN TRUCHADODAVID;PEREZ ZAFRA MANUEL. Nombramientos. Adm. Solid.: TARIN TRUCHADO DAVID;PEREZ ZAFRA MANUEL.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios.ARTICULO 18潞.- LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA Y REGIDA PORDOS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS QUE ASUMEN LAREPRESENTACIONSOCIAL CON PODERES Y FUNCIONES PERMANENTES. . Otros conceptos: POR ACUERDO DE LA JUNTAGENERAL Y UNIVERSAL DEL 31 DE MARZODE 2011, SE MODIFICAN Y REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 25607 , F 174, S 8, H M 54596, I/A 24 ( 4.05.11).
Revocaciones. Apoderado: TARIN MARTIN FEDERICO;PEREZ ESTEBAN MANUEL. Datos registrales. T 25607 , F 177, S 8, H M54596, I/A 25 ( 4.05.11).
02 de Febrero de 2011Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 4潞. Domicilio Social. Cambio de domicilio social. C/ ALFONSOGOMEZ NUMERO 42 (MADRID). Datos registrales. T 25607 , F 174, S 8, H M 54596, I/A 23 (21.01.11).
02 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Presidente: PEREZ ESTEBAN MANUEL. Cons.Del.Sol: PEREZ ESTEBAN MANUEL;TARIN MARTINFEDERICO. Secretario: TARIN MARTIN FEDERICO. Nombramientos. Presidente: TARIN TRUCHADO DAVID. Secretario: PEREZZAFRA MANUEL. Reelecciones. Consejero: PEREZ ESTEBAN MANUEL;TARIN MARTIN FEDERICO;TARIN TRUCHADODAVID;PEREZ ZAFRA MANUEL. Cons.Del.Sol: TARIN TRUCHADO DAVID;PEREZ ZAFRA MANUEL. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 18潞. -DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR-. Datos registrales. T 25607 , F 173, S 8, H M 54596, I/A 22(19.11.09).
06 de Marzo de 2009Nombramientos. Apoderado: PEREZ ZAFRA MANUEL;TARIN TRUCHADO DAVID. Datos registrales. T 25607 , F 173, S 8, H M54596, I/A 21 (25.02.09).