Actos BORME de El Adelantado De Segovia Sl
23 de Febrero de 2022Nombramientos. Auditor: M SEGOVIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 180 , F 108, S 8, H SG 965, I/A 28 (15.02.22).
29 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Presidente: HERRANZ CANO CARLOS. Consejero: HERRANZ CANO CARLOS. Vicepresid.: HERRANZ CANOJOSE. Consejero: HERRANZ CANO JOSE;HERRANZ CONTRERAS LUCIA. Secretario: HERRANZ CONTRERAS LUCIA.Con.Delegado: HERRANZ CONTRERAS TERESA. Consejero: HERRANZ CONTRERAS TERESA. Nombramientos. Adm. Unico:HERRANZ CONTRERAS TERESA. Auditor: MANUEL ANTONIO SEGOVIA ADANERO. Aud.Supl.: SALVADOR MU脩OZ-PEREAPI脩AR. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 180 , F 108, S 8, H SG 965, I/A 27 (18.12.20).
05 de Diciembre de 2018Nombramientos. Auditor: SEGOVIA ADANERO MANUEL ANTONIO. Aud.Supl.: SARA GARRIDO GARCIA. Datos registrales. T180 , F 108, S 8, H SG 965, I/A 26 (22.11.18).
29 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRANZ CONTRERAS ELISA. SecreNoConsj: JULIA GONZALEZ HERRERO. Consejero:HERRANZ CANO PEDRO. Revocaciones. Apoderado: REBOLLAR HERRANZ CARLOS. Nombramientos. Secretario: HERRANZCONTRERAS LUCIA. Datos registrales. T 180 , F 107, S 8, H SG 965, I/A 25 (18.08.17).
25 de Octubre de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 388.406,34 Euros. Resultante Suscrito: 443.892,96 Euros. Datos registrales. T 180 , F106, S 8, H SG 965, I/A 24 (14.10.16).
23 de Abril de 2015Nombramientos. Auditor: SEGOVIA ADANERO, MANUEL ANTONIO. Aud.Supl.: SARA GARRIDO GARCIA. Ampliaci贸n de capital.Capital: 200.029,95 Euros. Resultante Suscrito: 724.310,55 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 80.477,55 Euros. ResultanteSuscrito: 804.788,10 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 27.511,20 Euros. Resultante Suscrito: 832.299,30 Euros. Otrosconceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 3潞 Y EL APARTADO A) DEL ARTICULO 5潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 180 , F 104, S 8, H SG 965, I/A 23 (10.04.15).
22 de Agosto de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 337.035,60 Euros. Resultante Suscrito: 524.280,60 Euros. Otros conceptos: CAMBIO DEL VALORNOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y MODIFICACION DEL ARTICULO 3潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 180 , F 103, S 8, H SG 965, I/A 22 (14.08.14).
20 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: PROMOTORA DE MEDIOS DE CASTILLA Y LEON SL. Secretario: REBOLLAR HERRANZ CARLOS.Consejero: REBOLLAR HERRANZ CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: JULIA GONZALEZ HERRERO. Datos registrales. T180 , F 102, S 8, H SG 965, I/A 21 (13.06.14).
21 de Mayo de 2013Nombramientos. Consejero: HERRANZ CONTRERAS, ELISA. Datos registrales. T 180 , F 102, S 8, H SG 965, I/A 20 (13.05.13).
14 de Junio de 2011Cambio de objeto social. 1. - La edici贸n y publicaci贸n del peri贸dico "EL ADELANTADO DE SEGOVIA". 2.- El ejercicio de la industriade imprenta. 3.- Participar, en los t茅rminos que el 贸rgano de Administraci贸n determine, en la creaci贸n o en el capitalde otrassociedades cuyo objeto social est茅 relacionado con las artes gr谩fi. Datos registrales. T 180 , F 102, S 8, H SG 965, I/A 19 ( 3.06.11).
03 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDO DOMINGO JAVIER. Revocaciones. Apo.Manc.: HERNANDO DOMINGOJAVIER;REBOLLAR HERRANZ CARLOS. Nombramientos. Apoderado: REBOLLAR HERRANZ CARLOS. Datos registrales. T180 , F 101, S 8, H SG 965, I/A 18 (24.05.11).
31 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: FERNANDEZ GARCIA DE LOS RIOS RICARDO. Datos registrales. T 180 , F 101, S 8, H SG 965,I/A 17 (18.03.11).
07 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: HERRANZ CANO CARLOS. Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDO DOMINGOJAVIER;REBOLLAR HERRANZ CARLOS. Nombramientos. Consejero: HERRANZ CONTRERAS TERESA. Con.Delegado:HERRANZ CONTRERAS TERESA. Apo.Manc.: HERNANDO DOMINGO JAVIER;REBOLLAR HERRANZ CARLOS. Datosregistrales. T 180 , F 101, S 8, H SG 965, I/A 16 (25.03.10).
04 de Diciembre de 2009Nombramientos. Consejero: HERRANZ CONTRERAS LUCIA. Datos registrales. T 180 , F 101, S 8, H SG 965, I/A 15 (25.11.09).