Buscador CIF Logo

Actos BORME El Adelantado De Segovia Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera El Adelantado De Segovia Sl

Actos BORME El Adelantado De Segovia Sl - B40000267

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Segovia para El Adelantado De Segovia Sl con CIF B40000267

馃敊 Perfil de El Adelantado De Segovia Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Segovia

Actos BORME de El Adelantado De Segovia Sl

23 de Febrero de 2022
Nombramientos. Auditor: M SEGOVIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 180 , F 108, S 8, H SG 965, I/A 28 (15.02.22).

29 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Presidente: HERRANZ CANO CARLOS. Consejero: HERRANZ CANO CARLOS. Vicepresid.: HERRANZ CANOJOSE. Consejero: HERRANZ CANO JOSE;HERRANZ CONTRERAS LUCIA. Secretario: HERRANZ CONTRERAS LUCIA.Con.Delegado: HERRANZ CONTRERAS TERESA. Consejero: HERRANZ CONTRERAS TERESA. Nombramientos. Adm. Unico:HERRANZ CONTRERAS TERESA. Auditor: MANUEL ANTONIO SEGOVIA ADANERO. Aud.Supl.: SALVADOR MU脩OZ-PEREAPI脩AR. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 180 , F 108, S 8, H SG 965, I/A 27 (18.12.20).

05 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Auditor: SEGOVIA ADANERO MANUEL ANTONIO. Aud.Supl.: SARA GARRIDO GARCIA. Datos registrales. T180 , F 108, S 8, H SG 965, I/A 26 (22.11.18).

29 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRANZ CONTRERAS ELISA. SecreNoConsj: JULIA GONZALEZ HERRERO. Consejero:HERRANZ CANO PEDRO. Revocaciones. Apoderado: REBOLLAR HERRANZ CARLOS. Nombramientos. Secretario: HERRANZCONTRERAS LUCIA. Datos registrales. T 180 , F 107, S 8, H SG 965, I/A 25 (18.08.17).

25 de Octubre de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 388.406,34 Euros. Resultante Suscrito: 443.892,96 Euros. Datos registrales. T 180 , F106, S 8, H SG 965, I/A 24 (14.10.16).

23 de Abril de 2015
Nombramientos. Auditor: SEGOVIA ADANERO, MANUEL ANTONIO. Aud.Supl.: SARA GARRIDO GARCIA. Ampliaci贸n de capital.Capital: 200.029,95 Euros. Resultante Suscrito: 724.310,55 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 80.477,55 Euros. ResultanteSuscrito: 804.788,10 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 27.511,20 Euros. Resultante Suscrito: 832.299,30 Euros. Otrosconceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 3潞 Y EL APARTADO A) DEL ARTICULO 5潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 180 , F 104, S 8, H SG 965, I/A 23 (10.04.15).

22 de Agosto de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 337.035,60 Euros. Resultante Suscrito: 524.280,60 Euros. Otros conceptos: CAMBIO DEL VALORNOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y MODIFICACION DEL ARTICULO 3潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 180 , F 103, S 8, H SG 965, I/A 22 (14.08.14).

20 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: PROMOTORA DE MEDIOS DE CASTILLA Y LEON SL. Secretario: REBOLLAR HERRANZ CARLOS.Consejero: REBOLLAR HERRANZ CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: JULIA GONZALEZ HERRERO. Datos registrales. T180 , F 102, S 8, H SG 965, I/A 21 (13.06.14).

21 de Mayo de 2013
Nombramientos. Consejero: HERRANZ CONTRERAS, ELISA. Datos registrales. T 180 , F 102, S 8, H SG 965, I/A 20 (13.05.13).

14 de Junio de 2011
Cambio de objeto social. 1. - La edici贸n y publicaci贸n del peri贸dico "EL ADELANTADO DE SEGOVIA". 2.- El ejercicio de la industriade imprenta. 3.- Participar, en los t茅rminos que el 贸rgano de Administraci贸n determine, en la creaci贸n o en el capitalde otrassociedades cuyo objeto social est茅 relacionado con las artes gr谩fi. Datos registrales. T 180 , F 102, S 8, H SG 965, I/A 19 ( 3.06.11).

03 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDO DOMINGO JAVIER. Revocaciones. Apo.Manc.: HERNANDO DOMINGOJAVIER;REBOLLAR HERRANZ CARLOS. Nombramientos. Apoderado: REBOLLAR HERRANZ CARLOS. Datos registrales. T180 , F 101, S 8, H SG 965, I/A 18 (24.05.11).

31 de Marzo de 2011
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: FERNANDEZ GARCIA DE LOS RIOS RICARDO. Datos registrales. T 180 , F 101, S 8, H SG 965,I/A 17 (18.03.11).

07 de Abril de 2010
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: HERRANZ CANO CARLOS. Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDO DOMINGOJAVIER;REBOLLAR HERRANZ CARLOS. Nombramientos. Consejero: HERRANZ CONTRERAS TERESA. Con.Delegado:HERRANZ CONTRERAS TERESA. Apo.Manc.: HERNANDO DOMINGO JAVIER;REBOLLAR HERRANZ CARLOS. Datosregistrales. T 180 , F 101, S 8, H SG 965, I/A 16 (25.03.10).

04 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Consejero: HERRANZ CONTRERAS LUCIA. Datos registrales. T 180 , F 101, S 8, H SG 965, I/A 15 (25.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n