Buscador CIF Logo

Actos BORME El Arce De Villalba Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera El Arce De Villalba Sl

Actos BORME El Arce De Villalba Sl - B85674109

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para El Arce De Villalba Sl con CIF B85674109

馃敊 Perfil de El Arce De Villalba Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de El Arce De Villalba Sl

03 de Octubre de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26588 , F 209, S 8, H M 479171,I/A 24 (26.09.23).

23 de Septiembre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26588 , F 209, S 8, H M 479171,I/A 23 (16.09.22).

30 de Agosto de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26588 , F 209, S 8, H M 479171,I/A 22 (23.08.21).

18 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26588 , F 209, S 8, H M 479171,I/A 21 (11.11.20).

02 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: DOMINGUEZ SIDERAJUAN-LUIS. Consejero: CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO;CARPINTERO GRANDE CARLOS;CARPINTERO GRANDEMARIA;ARCE ALONSO RAUL;CUERVO-ARANGO MARTINEZ CARLOS;MERINO PANADERO FRANCISCO;BARTUREN PANERA

Revocaciones. Apo.Manc.: CARPINTERO GRANDE MARIA;CARPINTERO LOPEZ EMILIO;ARCE ALONSO RAUL. Apoderado:CARPINTERO LOPEZ ROBERTO;CARPINTERO GRANDE SARA. Apo.Sol.: GARCIA MARTINA VIRGINIA ANASTASIA. Datosregistrales. T 26588 , F 208, S 8, H M 479171, I/A 20 (24.12.19).

12 de Julio de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26588 , F 207, S 8, H M 479171,I/A 18 ( 5.07.19).

11 de Julio de 2019
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI SA. Datos registrales. T26588 , F 207, S 8, H M 479171, I/A 17 ( 4.07.19).

09 de Julio de 2019
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MARTIN LORENA;DE LA FUENTE SANZ ALBERTO;GUERRERO MORENO MARIAANGELES ASUNCION. Datos registrales. T 26588 , F 205, S 8, H M 479171, I/A 16 ( 2.07.19).

17 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26588 , F 205, S 8, H M 479171,I/A 15 (10.09.18).

19 de Diciembre de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26588 , F 204, S 8, H M 479171,I/A 14 (12.12.17).

22 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MARTINA VIRGINIA ANASTASIA;CARPINTERO GRANDE MARIA. Datos registrales. T 26588, F 203, S 8, H M 479171, I/A 13 (12.08.16).

13 de Abril de 2015
Revocaciones. Auditor: AVANTER AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.Datos registrales. T 26588 , F 203, S 8, H M 479171, I/A 12 ( 1.04.15).

26 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apoderado: CARPINTERO GRANDE SARA. Datos registrales. T 26588 , F 201, S 8, H M 479171, I/A 11 (6.08.13).

05 de Junio de 2013
Nombramientos. Apoderado: DE LA TORRE DIAZ GONZALO. Datos registrales. T 26588 , F 201, S 8, H M 479171, I/A 10(28.05.13).

29 de Enero de 2013
Nombramientos. Auditor: AVANTER AUDITORES SL. Datos registrales. T 26588 , F 201, S 8, H M 479171, I/A 9 (22.01.13).

17 de Septiembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARPINTERO GRANDE JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: CARPINTERO LOPEZ JUANANTONIO. Datos registrales. T 26588 , F 200, S 8, H M 479171, I/A 8 ( 5.09.12).

09 de Agosto de 2012
Revocaciones. Apo.Manc.: MIQUEL VALERO JULIO MARIA. Datos registrales. T 26588 , F 200, S 8, H M 479171, I/A 7 (31.07.12).

15 de Diciembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 26588 , F 91, S 8, H M 479171, I/A 6 (1.12.11).

18 de Marzo de 2011
Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ SIDERA JUAN-LUIS. Datos registrales. T 26588 , F 89, S 8, H M 479171, I/A 5 (8.03.11).

02 de Agosto de 2010
Cambio de domicilio social. AVDA ENSANCHE DE VALLECAS 44 (MADRID). Datos registrales. T 26588 , F 89, S 8, H M 479171,I/A 4 (20.07.10).

26 de Junio de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: CARPINTERO GRANDE MARIA;CARPINTERO LOPEZ EMILIO;MIQUEL VALERO JULIOMARIA;ARCE ALONSO RAUL. Datos registrales. T 26588 , F 87, S 8, H M 479171, I/A 2 (15.06.09).

Nombramientos. Apoderado: CARPINTERO LOPEZ ROBERTO. Datos registrales. T 26588 , F 87, S 8, H M 479171, I/A 3(15.06.09).

04 de Mayo de 2009
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 2.04.09. Objeto social: LA PROMOCION, CONSTRUCCION, ALQUILER, VENTA,ALQUILER CON OPCION A COMPRADE TODO TIPO DE VIVIENDAS. Domicilio: C/ SANTA MARIA MAGDALENA NUMERO 14(MADRID). Capital: 3.010,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: AGRICOLA EL CASAR SL. Nombramientos.Adm. Unico: CARPINTERO GRANDE JAVIER. Datos registrales. T 26588 , F 84, S 8, H M 479171, I/A 1 (21.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n