Actos BORME de El Correo De Andalucia Sl
08 de Octubre de 2015Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ AVIACION 14 4& - EDIFICIOMORERA VALLEJO 2 (SEVILLA). Datos registrales. T 3759 , F 160, S 8, H SE 53967, I/A 23 (23.09.15).
12 de Mayo de 2014Nombramientos. Adm. Unico: CASTREJON BARCO DIEGO ISRAEL. Datos registrales. T 3759 , F 159, S 8, H SE 53967, I/A 20(29.04.14).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CASTREJON BARCO DIEGO ISRAEL. Nombramientos. Adm. Unico: IBEAS ALONSOGUILLERMO. Datos registrales. T 3759 , F 159, S 8, H SE 53967, I/A 21 (30.04.14).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: IBEAS ALONSO GUILLERMO. Nombramientos. Adm. Unico: MORERA & VALLEJOCOMUNICACION SL. Datos registrales. T 3759 , F 160, S 8, H SE 53967, I/A 22 (30.04.14).
06 de Mayo de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3759 , F 158, S 8, H SE 53967, I/A 18 (21.04.14).
Nombramientos. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 3759 , F 159, S 8, H SE 53967, I/A 19 (21.04.14).
14 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GRUPO ALFONSO GALLARDO SL. Datos registrales. T 3759 , F 158, S 8, H SE 53967, I/A 17 (4.02.14).
11 de Enero de 2013Nombramientos. Apoderado: AMIAN CORDERO RAUL. Datos registrales. T 3759 , F 158, S 8, H SE 53967, I/A 16 (27.12.12).
11 de Septiembre de 2012Revocaciones. Apoderado: PAGUILLO LOPEZ MANUEL FRANCISCO. Apo.Sol.: MANUEL FRANCISCO PAGUILLO LOPEZ. Datosregistrales. T 3759 , F 157, S 8, H SE 53967, I/A 14 (29.08.12).
Nombramientos. Apo.Manc.: AMIAN CORDERO RAUL. Apoderado: BLANCO DE LA CRUZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T3759 , F 157, S 8, H SE 53967, I/A 15 (29.08.12).
04 de Mayo de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3759 , F 156, S 8, H SE 53967, I/A 12 (13.04.11).
10 de Enero de 2011Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3759 , F 156, S 8, H SE 53967, I/A 11 (28.12.10).