Buscador CIF Logo

Actos BORME El Enebro Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera El Enebro Sociedad Anonima

Actos BORME El Enebro Sociedad Anonima - A24011165

Tenemos registrados 55 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para El Enebro Sociedad Anonima con CIF A24011165

馃敊 Perfil de El Enebro Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de El Enebro Sociedad Anonima

20 de Diciembre de 2023
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 549.902,98 Euros. Resultante Suscrito: 1.310.720,90 Euros. Datos registrales. T 19346 ,F 209, S 8, H M 339112, I/A 64 (13.12.23).

07 de Diciembre de 2023
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MEZQUAL IBERICA SL. Datos registrales. T 19346 , F 208, S 8, H M 339112, I/A63 (29.11.23).

07 de Noviembre de 2023
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9潞. CONVOCATORIA, ASISTENCIA A LA JUNTA Y SOBERANIA DE LA JUNTA. Datosregistrales. T 19346 , F 207, S 8, H M 339112, I/A 62 (30.10.23).

11 de Octubre de 2023
Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 207, S 8, H M339112, I/A 61 ( 4.10.23).

23 de Agosto de 2022
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 207, S 8, H M339112, I/A 60 (16.08.22).

08 de Agosto de 2022
Reelecciones. Adm. Unico: MEZQUAL IBERICA SL. Representan: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T19346 , F 206, S 8, H M 339112, I/A 59 ( 1.08.22).

08 de Marzo de 2022
Otros conceptos: CANCELADA parcialmente la inscripci贸n 27, al haberse declarado la nulidad del acuerdo sexto de la junta generalde accionistas de 27 de mayo de 2011. Datos registrales. T 19346 , F 206, S 8, H M 339112, I/A 58 ( 1.03.22).

08 de Febrero de 2022
Modificaciones estatutarias. 9. Modificaci贸n del art铆culo 9潞 de los estatutos sociales.-. Datos registrales. T 19346 , F 206, S 8, H M339112, I/A 57 ( 1.02.22).

24 de Diciembre de 2021
P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.elenebro.com. Datos registrales. T 19346 , F 205, S 8, HM 339112, I/A 56 (17.12.21).

25 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: VITORICA FUERTES FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 19346 , F 205, S 8, H M 339112, I/A55 (18.11.21).

10 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 204, S 8, H M 339112, I/A 53 ( 2.11.21).

Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 205, S 8, H M 339112, I/A 54 ( 2.11.21).

13 de Mayo de 2021
Fe de erratas: Declaraci贸n de nulidad de la Junta General de Accionistas y de los acuerdos adoptados en la misma, celebrada el 15de enero de 2013, por Sentencia firme dictada el 22 de diciembre de 2020, por el Juzgo de lo Mercantil n潞 10 de Madrid, procedimienton煤mero 159/2013. Anulacion de la inscripcion 30. Datos registrales. T 19346 , F 204, S 8, H M 339112, I/A 52 ( 6.05.21).

22 de Enero de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MEZQUAL LIMITED. Representan: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS. RepresSuplen:ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS. Adm.Supl.: MEZQUAL IBERICA SL. Nombramientos. Adm. Unico: MEZQUAL IBERICA SL.Representan: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 19346 , F 204, S 8, H M 339112, I/A 51 (15.01.21).

08 de Enero de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 204, S 8, H M 339112, I/A 50 (28.12.20).

23 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 203, S 8, H M 339112, I/A 49 (16.12.20).

02 de Octubre de 2020
Nombramientos. Adm.Supl.: MEZQUAL IBERICA SL. RepresSuplen: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS. Modificacionesestatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 7 Y 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 19346 , F 202, S 8,H M 339112, I/A 48 (25.09.20).

29 de Enero de 2020
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los estatutos sociales incluyendo un nuevo art铆culo el 16 bis.. Datos registrales. T19346 , F 202, S 8, H M 339112, I/A 47 (22.01.20).

09 de Agosto de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 201, S 8, H M339112, I/A 46 ( 2.08.19).

25 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 201, S 8, H M339112, I/A 45 (18.09.18).

03 de Agosto de 2018
Otros conceptos: CANCELADA la anotaci贸n preventiva de solicitud de publicaci贸n de un complemento a la convocatoria de la JuntaGeneral convocada para ser celebrada los d铆as 22 o 25 de junio de 2018. Datos registrales. T 19346 , F 201, S 8, H M 339112, I/A 44(27.07.18).

03 de Julio de 2018
Otros conceptos: Anotaci贸n preventiva de solicitud de publicaci贸n de un COMPLEMENTO a la convocatoria de la Junta Generalconvocada para ser celebrada el d铆a 22 de junio de 2018, en primera convocatoria, o el d铆a 25 de junio de 2018, en segundaconvocatoria. Datos registrales. T 19346 , F 201, S 8, H M 339112, I/A D (25.06.18).

09 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUIRAO PEREZ MARTA MARIA. Datos registrales. T 19346 , F 198, S 8, H M 339112, I/A 42 (2.03.18).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA VELILLA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 19346 , F 200, S 8, H M 339112, I/A 43 (2.03.18).

10 de Agosto de 2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 198, S 8, H M339112, I/A 41 ( 3.08.17).

13 de Octubre de 2016
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 198, S 8, H M339112, I/A 40 ( 4.10.16).

21 de Septiembre de 2016
Otros conceptos: CANCELACION DE LA ANOTACION LETRA C. Datos registrales. T 19346 , F 197, S 8, H M 339112, I/A 38(14.09.16).

Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 7潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 19346 , F197, S 8, H M 339112, I/A 39 (14.09.16).

15 de Julio de 2016
Otros conceptos: Anotaci贸n preventiva de solicitud de publicaci贸n de un COMPLEMENTO a la convocatoria de la Junta Generalconvocada para ser celebrada el d铆a 29 de junio de 2016, en primera convocatoria, o el d铆a 30 de junio de 2016, en segundaconvocatoria. Datos registrales. T 19346 , F 196, S 8, H M 339112, I/A C ( 7.07.16).

18 de Abril de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;RODRIGUEZ-ARIAS DELGADO FERNANDO;GARCIA GARCIA JULIA.Datos registrales. T 19346 , F 196, S 8, H M 339112, I/A 37 ( 8.04.16).

13 de Abril de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZJUAN CARLOS;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA MARIA;RODRIGUEZ-ARIAS DELGADOFERNANDO. Presidente: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO. Vicepresid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA. Secretario:RODRIGUEZ-ARIAS DELGADO FERNANDO. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTAMARIA. Nombramientos. Adm. Unico: MEZQUAL LIMITED. Representan: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS. Modificacionesestatutarias. 9, 11 A 18. REFUNDICION DE ESTATUTOS.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 19346 , F 194, S 8, H M 339112, I/A 36 ( 5.04.16).

23 de Junio de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 194, S 8, H M339112, I/A 35 (12.06.15).

18 de Junio de 2015
Reelecciones. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ JUANCARLOS;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA MARIA;RODRIGUEZ-ARIAS DELGADOFERNANDO. Presidente: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO. Vicepresid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA. Secretario:RODRIGUEZ-ARIAS DELGADO FERNANDO. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTAMARIA. Datos registrales. T 19346 , F 193, S 8, H M 339112, I/A 34 ( 8.06.15).

08 de Septiembre de 2014
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 193, S 8, H M339112, I/A 33 ( 1.09.14).

11 de Febrero de 2014
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 7潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LATRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES.. Datos registrales. T 19346 , F 192, S 8, H M 339112, I/A 32 ( 4.02.14).

05 de Septiembre de 2013
Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 192, S 8, H M339112, I/A 31 (29.08.13).

14 de Junio de 2013
Otros conceptos: ANOTACION PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE IMPUGNACION DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DEFECHA 15 DE ENERO DE 2013. Y SUSPENSION DE ACUERDOS. Datos registrales. T 19346 , F 192, S 8, H M 339112, I/A B (6.06.13).

20 de Febrero de 2013
Modificaciones estatutarias. 7潞 Transmisibilidad de las acciones .24潞 Resoluci贸n de Conflictos. Datos registrales. T 19346 , F 190,S 8, H M 339112, I/A 30 (11.02.13).

11 de Febrero de 2013
Otros conceptos: anotaci贸n preventiva de solicitud de publicaci贸n de un COMPLEMENTO a la convocatoria de la Junta Generalconvocada paraser celebrada el d铆a 15 de enero de 2013, en primera convocatoria, o el d铆a 16 de enero de 2013, en segunda

21 de Agosto de 2012
Revocaciones. Apoderado: PARES RON PEDRO;PFLUGER SAMPER VICTOR JUAN;GARCIA MARTIN JUAN. Datos registrales.T 19346 , F 190, S 8, H M 339112, I/A 29 ( 8.08.12).

28 de Septiembre de 2011
Revocaciones. Apoderado: ESCUDERO HERREROS ELEUTERIO. Datos registrales. T 19346 , F 190, S 8, H M 339112, I/A 28(16.09.11).

19 de Julio de 2011
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los art铆culos 9潞, 10潞 y 12潞 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 19346 , F189, S 8, H M 339112, I/A 27 ( 7.07.11).

13 de Mayo de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 189, S 8, H M339112, I/A 26 ( 4.05.11).

13 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLOMANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA;ALVAREZMEZQUIRIZ MARTA MARIA. Presidente: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO. Vicepresid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA.Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA MARIA. Secretario: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL. Nombramientos.Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ JUANCARLOS;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA MARIA;RODRIGUEZ-ARIAS DELGADOFERNANDO. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA MARIA. Presidente: ALVAREZMEZQUIRIZ EMILIO. Vicepresid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA. Secretario: RODRIGUEZ-ARIAS DELGADO FERNANDO.Datos registrales. T 19346 , F 187, S 8, H M 339112, I/A 25 (31.03.11).

28 de Enero de 2011
Revocaciones. Apoderado: SALAZAR ROMAN ANTONIO;ESCORIAL PINELA CARLOS. Datos registrales. T 19346 , F 187, S 8, HM 339112, I/A 24 (18.01.11).

20 de Enero de 2011
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2009 mediante

13 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA VELILLA JOSE MANUEL;MARTINEZ ORTEGA ANA BELEN;ESCORIAL PINELA CARLOS.Datos registrales. T 19346 , F 184, S 8, H M 339112, I/A 22 (30.11.10).

02 de Julio de 2010
Otros conceptos: ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA DE IMPUGNACION DE ACUERDOS SOCIALES ADOPTADOS EN LAJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 18 DE ENERO DE 2010. PREVIA PRESTACION DE CAUCION. SE FIJA EN 15.000EUROS EL IMPORTE DE LA CAUCION, QUE DEBE PRESTARLA PARTE DEMANDANTE EN EL PLAZO DE CINCO DIAS. Datosregistrales. T 19346 , F 184, S 8, H M 339112, I/A A (22.06.10).

08 de Abril de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 184, S 8, H M339112, I/A 21 (24.03.10).

22 de Marzo de 2010
Revocaciones. Apoderado: CARRERO ANTIN SANTIAGO;MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS;GONZALEZ DE SANTIAGO EVAINES;JORDANO PEREZ JUAN BAUTISTA;JORDANO PEREZ JUAN BAUTISTA;MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS. Datosregistrales. T 19346 , F 184, S 8, H M 339112, I/A 20 (10.03.10).

12 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CARRERO ANTIN SANTIAGO. Nombramientos. Presidente: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO.Vicepresid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA MARIA. Secretario: ALVAREZMEZQUIRIZ PABLO MANUEL. Datos registrales. T 19346 , F 183, S 8, H M 339112, I/A 19 ( 1.03.10).

04 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Presidente: ALVAREZ DIEZ DAVID. Con.Delegado: ALVAREZDIEZ DAVID;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Consejero: ALVAREZ DIEZ DAVID;ALVAREZ MEZQUIRIZ JESUSDAVID;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 19346 , F 183, S 8, H M 339112, I/A 18 (26.01.10).

01 de Febrero de 2010
Nombramientos. Apoderado: JORDANO PEREZ JUAN BAUTISTA;MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS. Datos registrales. T19346 , F 181, S 8, H M 339112, I/A 17 (20.01.10).

18 de Enero de 2010
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE;ALVAREZ DIEZ DAVID. Datos registrales. T 19346 , F 180, S 8,H M 339112, I/A 16 ( 5.01.10).

04 de Febrero de 2009
Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19346 , F 180, S 8, H M 339112, I/A 15 (22.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n