Buscador CIF Logo

Actos BORME El Gato Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera El Gato Sl

Actos BORME El Gato Sl - B28033769

Tenemos registrados 47 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para El Gato Sl con CIF B28033769

馃敊 Perfil de El Gato Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de El Gato Sl

28 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: INIESTA ALCARAZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 45951 , F 47, S 8, H M 100131, I/A 66(20.12.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: CALDERON AREVALO LAURA. Datos registrales. T 45951 , F 49, S 8, H M 100131, I/A 67 (20.12.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ ABRIL ROCIO. Datos registrales. T 45951 , F 51, S 8, H M 100131, I/A 68 (20.12.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ CERNUDA MATIAS. Datos registrales. T 45951 , F 53, S 8, H M 100131, I/A 69 (20.12.23).

26 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES RODRIGUEZ LUISA MARIA. Datos registrales. T 45951 , F 43, S 8, H M 100131, I/A 64(18.12.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ MARTIALAY PAOLA. Datos registrales. T 45951 , F 45, S 8, H M 100131, I/A 65(18.12.23).

22 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA GANDARA MARTINEZ DE VELASCO JOSE. Datos registrales. T 44715 , F 194, S 8, H M100131, I/A 54 (15.12.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MATUTE PEREZ MARTA. Datos registrales. T 44715 , F 202, S 8, H M 100131, I/A 56 (15.12.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PERALTA MATEOS MARIA ROSA. Datos registrales. T 44715 , F 206, S 8, H M 100131, I/A 57(15.12.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ FLOREZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 44715 , F 209, S 8, H M 100131, I/A 58(15.12.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALMIRA GARCIA JOAQUIN. Datos registrales. T 44715 , F 212, S 8, H M 100131, I/A 59(15.12.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ GONZALEZ JAVIER. Datos registrales. T 44715 , F 215, S 8, H M 100131, I/A 60(15.12.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARINO ARZUA CARLOS. Datos registrales. T 44715 , F 198, S 8, H M 100131, I/A 55 (15.12.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLAZQUEZ RODRIGO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 44715 , F 218, S 8, H M 100131, I/A61 (15.12.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ COCHO RICARDO. Datos registrales. T 44715 , F 224, S 8, H M 100131, I/A 62(15.12.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LOPEZ-REY SERGIO. Datos registrales. T 45951 , F 41, S 8, H M 100131, I/A 63(15.12.23).

17 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUADO GARCIA SANTIAGO;AGUADO RUBIO ENRIQUE;AGUADO GAVILAN MIGUELANGEL;AGUADO GAVILAN EDUARDO. Cons.Del.Sol: AGUADO GARCIA SANTIAGO;AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL.Presidente: AGUADO GARCIA SANTIAGO. Consejero: AGUADO RUBIO MARIA MARTA. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO ENRIQUE.Nombramientos. Consejero: AGUADO RUBIO ENRIQUE. Presidente: AGUADO RUBIO ENRIQUE. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIOENRIQUE. Consejero: AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Sol: AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL. Consejero:AGUADO RUBIO MARIA MARTA;AGUADO GAVILAN EDUARDO;AGUADO GAVILAN ALMUDENA;FLORES PEREZ GONZALOJESUS. Datos registrales. T 44715 , F 192, S 8, H M 100131, I/A 53 ( 9.08.23).

04 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: MONTOYA LEGARIA JUAN ANTONIO. Apo.Manc.: MONTOYA LEGARIA JUAN ANTONIO. Datosregistrales. T 37647 , F 89, S 8, H M 100131, I/A 51 (25.04.23).

Nombramientos. Apoderado: MARINO ARZUA CARLOS. Datos registrales. T 37647 , F 89, S 8, H M 100131, I/A 52 (25.04.23).

19 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: CHURTICHAGA GUTIERREZ FRANCISCO. Datos registrales. T 37647 , F 89, S 8, H M 100131, I/A50 (12.12.22).

25 de Abril de 2022
Ampliaci贸n de capital. Capital: 250.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 630.000,00 Euros. Datos registrales. T 37647 , F 89, S 8, HM 100131, I/A 49 (18.04.22).

07 de Abril de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LOPEZ-REY SERGIO. Datos registrales. T 37647 , F 88, S 8, H M 100131, I/A 48(31.03.22).

21 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ DARRIBA BREOGAN. Datos registrales. T 37647 , F 88, S 8, H M 100131, I/A 47 (14.03.22).

02 de Marzo de 2022
Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 37647 , F 87, S 8, H M 100131, I/A 46 (23.02.22).

24 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: BLAQUEZ RODRIGO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 37647 , F 87, S 8, H M 100131, I/A 45(17.12.21).

08 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MARTIALAY PAOLA. Datos registrales. T 37647 , F 86, S 8, H M 100131, I/A 43 (1.06.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: CALDERON AREVALO LAURA;ISABEL ALONSO MARIA. Datos registrales. T 37647 , F 87, S 8, H M100131, I/A 44 ( 1.06.21).

08 de Febrero de 2021
Ampliaci贸n de capital. Capital: 151.615,40 Euros. Resultante Suscrito: 380.000,00 Euros. Datos registrales. T 37647 , F 86, S 8, HM 100131, I/A 42 ( 1.02.21).

21 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: BLAQUEZ RODRIGO MIGUEL ANGEL;LOPEZ DARRIBA BREOGAN. Datos registrales. T 37647 , F75, S 8, H M 100131, I/A 34 (14.12.20).

Nombramientos. Apoderado: BLAQUEZ RODRIGO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 37647 , F 77, S 8, H M 100131, I/A 35(14.12.20).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ SU脩ER OCTAVIO. Datos registrales. T 37647 , F 78, S 8, H M 100131, I/A 36(14.12.20).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ FLOREZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 37647 , F 79, S 8, H M 100131, I/A 37(14.12.20).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MARTIALAY PAOLA. Datos registrales. T 37647 , F 80, S 8, H M 100131, I/A 38(14.12.20).

Nombramientos. Apoderado: DE LA GANDARA MARTINEZ DE VELASCO JOSE. Datos registrales. T 37647 , F 81, S 8, H M100131, I/A 39 (14.12.20).

Nombramientos. Apoderado: CALDERON AREVALO LAURA;ISABEL ALONSO MARIA. Datos registrales. T 37647 , F 83, S 8, HM 100131, I/A 40 (14.12.20).

Nombramientos. Apoderado: FLORES PEREZ GONZALO;MATUTE PEREZ MARTA. Datos registrales. T 37647 , F 84, S 8, H M100131, I/A 41 (14.12.20).

08 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUADO RUBIO SANTIAGO. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO SANTIAGO. Nombramientos.Consejero: AGUADO RUBIO MARIA MARTA. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO ENRIQUE. Datos registrales. T 37647 , F 75, S 8, H M100131, I/A 33 ( 1.07.20).

24 de Septiembre de 2019
Nombramientos. Auditor: AVANTER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 37647 , F 74, S 8, H M 100131, I/A 32 (17.09.19).

30 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO ENRIQUE. Nombramientos. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO SANTIAGO.Datos registrales. T 37647 , F 74, S 8, H M 100131, I/A 31 (23.04.19).

31 de Enero de 2019
Cambio de domicilio social. C/ GOMERA 4 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 37647 , F 74, S 8, H M100131, I/A 30 (24.01.19).

21 de Junio de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: FLORES PEREZ GONZALO JESUS. Apo.Sol.: FLORES PEREZ GONZALO JESUS;MONTOYALEGARIA JUAN ANTONIO. Apo.Manc.: MONTOYA LEGARIA JUAN ANTONIO;DE LA GANDARA MARTINEZ DE VELASCO JOSE.Apo.Sol.: DE LA GANDARA MARTINEZ DE VELASCO JOSE. Datos registrales. T 6137 , F 101, S 8, H M 100131, I/A 28 (14.06.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MARTIALAY PAOLA;LOPEZ DARRIBA BREOGAN;CALDERON AREVALO LAURA. Datosregistrales. T 6137 , F 101, S 8, H M 100131, I/A 29 (14.06.18).

12 de Junio de 2018
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA. Datos registrales. T 6137 , F 100, S 8, H M100131, I/A 27 ( 4.06.18).

11 de Junio de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RAMOS PUENTES JERONIMO. Nombramientos. SecreNoConsj: RUEDA GONZALEZ PEDROANTONIO. Consejero: AGUADO GARCIA SANTIAGO;AGUADO RUBIO ENRIQUE;AGUADO RUBIO SANTIAGO;AGUADO GAVILANMIGUEL ANGEL;AGUADO GAVILAN EDUARDO;CHURTICHAGA GUTIERREZ FRANCISCO. Cons.Del.Sol: AGUADO GARCIASANTIAGO;AGUADO RUBIO ENRIQUE;AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL. Presidente: AGUADO GARCIA SANTIAGO.Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacci贸n de los art铆culos 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22 y 25 de los estatutos sociales.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T6137 , F 99, S 8, H M 100131, I/A 26 ( 1.06.18).

20 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Auditor: EUDITA CYE AUDITORES SA. Datos registrales. T 6137 , F 98, S 8, H M 100131, I/A 25 (12.12.16).

28 de Enero de 2013
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA FLORIDA 11 - 1潞 A Y B (MADRID). Datos registrales. T 6137 , F 98, S 8, H M 100131,I/A 24 (18.01.13).

23 de Marzo de 2012
Nombramientos. Auditor: CYE AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 6137 , F 98, S 8, H M 100131, I/A 23 (12.03.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n