Actos BORME de El Gato Sl
28 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: INIESTA ALCARAZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 45951 , F 47, S 8, H M 100131, I/A 66(20.12.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: CALDERON AREVALO LAURA. Datos registrales. T 45951 , F 49, S 8, H M 100131, I/A 67 (20.12.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ ABRIL ROCIO. Datos registrales. T 45951 , F 51, S 8, H M 100131, I/A 68 (20.12.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ CERNUDA MATIAS. Datos registrales. T 45951 , F 53, S 8, H M 100131, I/A 69 (20.12.23).
26 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES RODRIGUEZ LUISA MARIA. Datos registrales. T 45951 , F 43, S 8, H M 100131, I/A 64(18.12.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ MARTIALAY PAOLA. Datos registrales. T 45951 , F 45, S 8, H M 100131, I/A 65(18.12.23).
22 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA GANDARA MARTINEZ DE VELASCO JOSE. Datos registrales. T 44715 , F 194, S 8, H M100131, I/A 54 (15.12.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MATUTE PEREZ MARTA. Datos registrales. T 44715 , F 202, S 8, H M 100131, I/A 56 (15.12.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PERALTA MATEOS MARIA ROSA. Datos registrales. T 44715 , F 206, S 8, H M 100131, I/A 57(15.12.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ FLOREZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 44715 , F 209, S 8, H M 100131, I/A 58(15.12.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALMIRA GARCIA JOAQUIN. Datos registrales. T 44715 , F 212, S 8, H M 100131, I/A 59(15.12.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ GONZALEZ JAVIER. Datos registrales. T 44715 , F 215, S 8, H M 100131, I/A 60(15.12.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARINO ARZUA CARLOS. Datos registrales. T 44715 , F 198, S 8, H M 100131, I/A 55 (15.12.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLAZQUEZ RODRIGO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 44715 , F 218, S 8, H M 100131, I/A61 (15.12.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ COCHO RICARDO. Datos registrales. T 44715 , F 224, S 8, H M 100131, I/A 62(15.12.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LOPEZ-REY SERGIO. Datos registrales. T 45951 , F 41, S 8, H M 100131, I/A 63(15.12.23).
17 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUADO GARCIA SANTIAGO;AGUADO RUBIO ENRIQUE;AGUADO GAVILAN MIGUELANGEL;AGUADO GAVILAN EDUARDO. Cons.Del.Sol: AGUADO GARCIA SANTIAGO;AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL.Presidente: AGUADO GARCIA SANTIAGO. Consejero: AGUADO RUBIO MARIA MARTA. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO ENRIQUE.Nombramientos. Consejero: AGUADO RUBIO ENRIQUE. Presidente: AGUADO RUBIO ENRIQUE. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIOENRIQUE. Consejero: AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Sol: AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL. Consejero:AGUADO RUBIO MARIA MARTA;AGUADO GAVILAN EDUARDO;AGUADO GAVILAN ALMUDENA;FLORES PEREZ GONZALOJESUS. Datos registrales. T 44715 , F 192, S 8, H M 100131, I/A 53 ( 9.08.23).
04 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: MONTOYA LEGARIA JUAN ANTONIO. Apo.Manc.: MONTOYA LEGARIA JUAN ANTONIO. Datosregistrales. T 37647 , F 89, S 8, H M 100131, I/A 51 (25.04.23).
Nombramientos. Apoderado: MARINO ARZUA CARLOS. Datos registrales. T 37647 , F 89, S 8, H M 100131, I/A 52 (25.04.23).
19 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: CHURTICHAGA GUTIERREZ FRANCISCO. Datos registrales. T 37647 , F 89, S 8, H M 100131, I/A50 (12.12.22).
25 de Abril de 2022Ampliaci贸n de capital. Capital: 250.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 630.000,00 Euros. Datos registrales. T 37647 , F 89, S 8, HM 100131, I/A 49 (18.04.22).
07 de Abril de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LOPEZ-REY SERGIO. Datos registrales. T 37647 , F 88, S 8, H M 100131, I/A 48(31.03.22).
21 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: LOPEZ DARRIBA BREOGAN. Datos registrales. T 37647 , F 88, S 8, H M 100131, I/A 47 (14.03.22).
02 de Marzo de 2022Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 37647 , F 87, S 8, H M 100131, I/A 46 (23.02.22).
24 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: BLAQUEZ RODRIGO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 37647 , F 87, S 8, H M 100131, I/A 45(17.12.21).
08 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MARTIALAY PAOLA. Datos registrales. T 37647 , F 86, S 8, H M 100131, I/A 43 (1.06.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: CALDERON AREVALO LAURA;ISABEL ALONSO MARIA. Datos registrales. T 37647 , F 87, S 8, H M100131, I/A 44 ( 1.06.21).
08 de Febrero de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 151.615,40 Euros. Resultante Suscrito: 380.000,00 Euros. Datos registrales. T 37647 , F 86, S 8, HM 100131, I/A 42 ( 1.02.21).
21 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: BLAQUEZ RODRIGO MIGUEL ANGEL;LOPEZ DARRIBA BREOGAN. Datos registrales. T 37647 , F75, S 8, H M 100131, I/A 34 (14.12.20).
Nombramientos. Apoderado: BLAQUEZ RODRIGO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 37647 , F 77, S 8, H M 100131, I/A 35(14.12.20).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ SU脩ER OCTAVIO. Datos registrales. T 37647 , F 78, S 8, H M 100131, I/A 36(14.12.20).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ FLOREZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 37647 , F 79, S 8, H M 100131, I/A 37(14.12.20).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MARTIALAY PAOLA. Datos registrales. T 37647 , F 80, S 8, H M 100131, I/A 38(14.12.20).
Nombramientos. Apoderado: DE LA GANDARA MARTINEZ DE VELASCO JOSE. Datos registrales. T 37647 , F 81, S 8, H M100131, I/A 39 (14.12.20).
Nombramientos. Apoderado: CALDERON AREVALO LAURA;ISABEL ALONSO MARIA. Datos registrales. T 37647 , F 83, S 8, HM 100131, I/A 40 (14.12.20).
Nombramientos. Apoderado: FLORES PEREZ GONZALO;MATUTE PEREZ MARTA. Datos registrales. T 37647 , F 84, S 8, H M100131, I/A 41 (14.12.20).
08 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUADO RUBIO SANTIAGO. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO SANTIAGO. Nombramientos.Consejero: AGUADO RUBIO MARIA MARTA. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO ENRIQUE. Datos registrales. T 37647 , F 75, S 8, H M100131, I/A 33 ( 1.07.20).
24 de Septiembre de 2019Nombramientos. Auditor: AVANTER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 37647 , F 74, S 8, H M 100131, I/A 32 (17.09.19).
30 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO ENRIQUE. Nombramientos. Cons.Del.Sol: AGUADO RUBIO SANTIAGO.Datos registrales. T 37647 , F 74, S 8, H M 100131, I/A 31 (23.04.19).
31 de Enero de 2019Cambio de domicilio social. C/ GOMERA 4 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 37647 , F 74, S 8, H M100131, I/A 30 (24.01.19).
21 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: FLORES PEREZ GONZALO JESUS. Apo.Sol.: FLORES PEREZ GONZALO JESUS;MONTOYALEGARIA JUAN ANTONIO. Apo.Manc.: MONTOYA LEGARIA JUAN ANTONIO;DE LA GANDARA MARTINEZ DE VELASCO JOSE.Apo.Sol.: DE LA GANDARA MARTINEZ DE VELASCO JOSE. Datos registrales. T 6137 , F 101, S 8, H M 100131, I/A 28 (14.06.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MARTIALAY PAOLA;LOPEZ DARRIBA BREOGAN;CALDERON AREVALO LAURA. Datosregistrales. T 6137 , F 101, S 8, H M 100131, I/A 29 (14.06.18).
12 de Junio de 2018Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA. Datos registrales. T 6137 , F 100, S 8, H M100131, I/A 27 ( 4.06.18).
11 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RAMOS PUENTES JERONIMO. Nombramientos. SecreNoConsj: RUEDA GONZALEZ PEDROANTONIO. Consejero: AGUADO GARCIA SANTIAGO;AGUADO RUBIO ENRIQUE;AGUADO RUBIO SANTIAGO;AGUADO GAVILANMIGUEL ANGEL;AGUADO GAVILAN EDUARDO;CHURTICHAGA GUTIERREZ FRANCISCO. Cons.Del.Sol: AGUADO GARCIASANTIAGO;AGUADO RUBIO ENRIQUE;AGUADO GAVILAN MIGUEL ANGEL. Presidente: AGUADO GARCIA SANTIAGO.Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacci贸n de los art铆culos 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22 y 25 de los estatutos sociales.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T6137 , F 99, S 8, H M 100131, I/A 26 ( 1.06.18).
20 de Diciembre de 2016Nombramientos. Auditor: EUDITA CYE AUDITORES SA. Datos registrales. T 6137 , F 98, S 8, H M 100131, I/A 25 (12.12.16).
28 de Enero de 2013Cambio de domicilio social. PASEO DE LA FLORIDA 11 - 1潞 A Y B (MADRID). Datos registrales. T 6137 , F 98, S 8, H M 100131,I/A 24 (18.01.13).
23 de Marzo de 2012Nombramientos. Auditor: CYE AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 6137 , F 98, S 8, H M 100131, I/A 23 (12.03.12).