Actos BORME de El Horno De Pedro Sl
05 de Abril de 2021Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 225, S 8, H V 88871, I/A 21 (25.03.21).
22 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ RUIZ DIGNA-ISABEL. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 224, S 8, H V 88871, I/A 20(15.11.19).
05 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ RUIZ DIGNA-ISABEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: MARTINEZ RUIZ DIGNA-ISABEL;MARTINEZ RUIZ CLEMENTE;MARTINEZ RUIZ JESUS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 224, S 8, H V 88871, I/A 19 (28.10.19).
08 de Octubre de 2019Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: INVERSIONES CEJISA SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CASTELLO JUANSERVANDO DAMIAN. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ RUIZ DIGNA-ISABEL. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 222,S 8, H V 88871, I/A 16 ( 1.10.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ RUIZ CLEMENTE;MARTINEZ RUIZ JESUS;MARTINEZ VILLAGRA CARLOS. Datos
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAN MARTIN ARCE FRANCISCO;RAMON VILA JORGE;ARRIOLA MURRIETA JOSE MANUEL.Datos registrales. T 7435, L 4736, F 223, S 8, H V 88871, I/A 18 ( 1.10.19).
31 de Julio de 2019Revocaciones. Apoderado: RUIZ PARDO ALFONSO. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 222, S 8, H V 88871, I/A 15 (24.07.19).
14 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RUIZ PARDO ALFONSO. Revocaciones. Apoderado: CASTELLO JUAN SERVANDO DAMIAN.Nombramientos. Adm. Unico: CASTELLO JUAN SERVANDO DAMIAN. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 221, S 8, H V 88871,I/A 14 ( 7.05.19).
13 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CASTELLO JUAN SERVANDO DAMIAN. Nombramientos. Adm. Unico: RUIZ PARDO ALFONSO.Datos registrales. T 7435, L 4736, F 221, S 8, H V 88871, I/A 12 ( 5.11.18).
Nombramientos. Apoderado: CASTELLO JUAN SERVANDO DAMIAN. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 221, S 8, H V 88871,
25 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ GARCIA JOAN. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 220, S 8, H V 88871, I/A 10(18.09.17).
Nombramientos. Apoderado: RUIZ PARDO ALFONSO. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 220, S 8, H V 88871, I/A 11 (18.09.17).
27 de Diciembre de 2016Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art. 25 de los Estatutos Sociales relativo a la retribuci贸n del 贸rgano de administraci贸n. .Datos registrales. T 7435, L 4736, F 220, S 8, H V 88871, I/A 9 (19.12.16).
13 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CASTELLO SANZ SERVANDO. Nombramientos. Adm. Unico: CASTELLO JUAN SERVANDODAMIAN. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 219, S 8, H V 88871, I/A 8 ( 2.12.16).
30 de Enero de 2014Revocaciones. Apoderado: CASTELLO JUAN SERVANDO DAMIAN. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 219, S 8, H V 88871, I/A6 (23.01.14).
Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ GARCIA JOAN. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 219, S 8, H V 88871, I/A 7(23.01.14).
28 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: CASTELLO JUAN SERVANDO DAMIAN. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 218, S 8, H V 88871,I/A 5 (21.02.13).
20 de Febrero de 2013Revocaciones. Apoderado: BAYONA GIMENO JOSEFA. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 218, S 8, H V 88871, I/A 4 (13.02.13).
21 de Abril de 2009Nombramientos. Apoderado: BAYONA GIMENO JOSEFA. Datos registrales. T 7435, L 4736, F 217, S 8, H V 88871, I/A 3 (8.04.09).