Buscador CIF Logo

Actos BORME El Laboratorio De Almagro 36 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera El Laboratorio De Almagro 36 Sl

Actos BORME El Laboratorio De Almagro 36 Sl - B83940346

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para El Laboratorio De Almagro 36 Sl con CIF B83940346

馃敊 Perfil de El Laboratorio De Almagro 36 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de El Laboratorio De Almagro 36 Sl

03 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ NOAIN RODRIGALVAREZ ANTONIO;DE MADARIAGA SANCHEZ MARIALUISA;HOLEMANS MESTRES CARLOS. Presidente: HOLEMANS MESTRES CARLOS. Cons.Del.Sol: DE MADARIAGA SANCHEZMARIA LUISA;HOLEMANS MESTRES CARLOS. SecreNoConsj: LOPEZ LOZANO RAUL. Nombramientos. Liquidador: DEMADARIAGA SANCHEZ MARIA LUISA. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 28812 , F 209, S 8, H M 359176,I/A 26 (26.09.19).

20 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Secretario: LOPEZ CASTRO FERNANDO GABRIEL. Nombramientos. SecreNoConsj: LOPEZ LOZANO RAUL.Datos registrales. T 28812 , F 209, S 8, H M 359176, I/A 25 ( 7.04.17).

31 de Diciembre de 2014
Cambio de domicilio social. C/ MUSGO 3 (MADRID). Datos registrales. T 28812 , F 208, S 8, H M 359176, I/A 24 (22.12.14).

01 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Apoderado: RAMIREZ BLANCO CARLOS. Datos registrales. T 28812 , F 208, S 8, H M 359176, I/A 23 (24.11.14).

10 de Junio de 2014
Reelecciones. Consejero: DE MADARIAGA SANCHEZ MARIA LUISA;HOLEMANS MESTRES CARLOS. Presidente: HOLEMANSMESTRES CARLOS. Cons.Del.Sol: DE MADARIAGA SANCHEZ MARIA LUISA;HOLEMANS MESTRES CARLOS. Otros conceptos:CONSEJEROS DELEGADOS CON FACULTADES LIMITADAS. Datos registrales. T 28812 , F 207, S 8, H M 359176, I/A 22 (3.06.14).

07 de Febrero de 2014
Reelecciones. Auditor: HENILAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 28812 , F 207, S 8, H M 359176, I/A 20 (30.01.14).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.454,00 Euros. Resultante Suscrito: 28.969,00 Euros. Datos registrales. T 28812 , F 207,S 8, H M 359176, I/A 21 (30.01.14).

04 de Septiembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: SILVELA MENDIZABAL RAFAEL. Datos registrales. T 28812 , F 206, S 8, H M 359176, I/A 19(26.08.13).

12 de Febrero de 2013
Reelecciones. Auditor: HENILAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 28812 , F 206, S 8, H M 359176, I/A 18 ( 4.02.13).

01 de Febrero de 2012
Reelecciones. Auditor: HENILAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 28812 , F 206, S 8, H M 359176, I/A 17 (20.01.12).

08 de Junio de 2011
Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ BLANCO CARLOS. Otros conceptos: POR ACUERDO DEL CONSEJO DEADMINISTRACION DE 6 DE MAYO DE 2011 SE RATIFICA EL PODER CONFERIDO A FAVOR DE DON CARLOS RAMIREZBLANCO Y SE AMPLIAN LAS FACULTADES CONFERIDAS A LOS CONSEJEROS DO脩A MARIA LUISA DE MADARIAGASANCHEZ Y A DON CARLOSHOLEMANS MESTRES. Datos registrales. T 20314 , F 30, S 8, H M 359176, I/A 16 (27.05.11).

31 de Diciembre de 2010
Reelecciones. Auditor: HENILAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 20314 , F 30, S 8, H M 359176, I/A 15 (22.12.10).

07 de Octubre de 2010
Reelecciones. Consejero: GONZALEZ NOAIN RODRIGALVAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 20314 , F 30, S 8, H M 359176,I/A 14 (28.09.10).

15 de Junio de 2010
Nombramientos. Apoderado: SILVELA MENDIZABAL RAFAEL. Datos registrales. T 20314 , F 30, S 8, H M 359176, I/A 13 (4.06.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n