Actos BORME de El Puerto De Santa Maria Global Sl
17 de Marzo de 2023Nombramientos. Secr.Com.Liq: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 2293 , F 67, S 8, H CA 10893, I/A82 ( 8.03.23).
28 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: VICTOR MANUEL RAPOSO CHAVES. Nombramientos. Consejero: ANGEL MARIA GONZALEZARIAS. Datos registrales. T 2293 , F 66, S 8, H CA 10893, I/A 81 (16.12.22).
17 de Noviembre de 2022Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: PAYA ORZAES JOSE ANTONIO. Nombramientos. Vicesecret.: GARCIA RETORTILLOPEDRO. Datos registrales. T 2293 , F 66, S 8, H CA 10893, I/A 80 (10.11.22).
09 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: CALLEJA GARCIA RUIZ DAVID. Vicepresid.: CALLEJA GARCIA RUIZ DAVID. Nombramientos.Consejero: DE LA TORRE CARMONA CESAR. Vicepresid.: DE LA TORRE CARMONA CESAR. Datos registrales. T 2293 , F 66, S8, H CA 10893, I/A 79 (25.02.22).
11 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: LARA VALS MARIA EUGENIA. Nombramientos. Consejero: RAPOSO CHAVES VICTOR MANUEL.VsecrNoConsj: PAYA ORZAES JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 2293 , F 65, S 8, H CA 10893, I/A 78 ( 3.11.21).
10 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RICO JURADO ARACELI ISABEL. VsecrNoConsj: GARCIA CASAS JUAN ANTONIO.Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA CASAS JUAN ANTONIO. Cambio de objeto social. 1.- La sociedad El Puerto de SantaMar铆a Global, S.L.U. tiene como objeto social, de forma general, la prestaci贸n de servicios y ejecuci贸n de inversiones relacionadas conla comunicaci贸n e informaci贸n, las tecnolog铆as de la informaci贸n, inform谩tica, el equipamiento t茅cnico o tecnol贸gico, la gesti贸n. Datosregistrales. T 2293 , F 64, S 8, H CA 10893, I/A 77 ( 1.06.21).
24 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMINGUEZ FERNANDEZ JUAN LUIS. Datos registrales. T 2293 , F 64, S 8, H CA 10893, I/A 76(13.02.20).
16 de Octubre de 2019Revocaciones. Apoderado: DE LA MONEDA FERNANDEZ-SANZ FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: SERRANORODRIGUEZ RAFAEL EDUARDO. D. Gerente: SERRANO RODRIGUEZ RAFAEL EDUARDO. Datos registrales. T 2293 , F 63, S 8,H CA 10893, I/A 75 ( 9.10.19).
22 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ SANCHO ANTONIO;GOMEZ BORREGUERO SILVIA;DE LA PASCUA RAMIREZOLGA;OTERO GUILLEN DAVID;JIMENEZ GASENI ANDREA;PY RODRIGUEZ JESUS SACRAMENTADO;DOMINGUEZ CANOMARIA TRINIDAD;YESA HERRERA JESUS;LARA VALS MARIA EUGENIA. Presidente: LARA VALS MARIA EUGENIA.Nombramientos. Consejero: BELLO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER;LARA VALS MARIA EUGENIA;CALLEJA GARCIA RUIZDAVID;PARDO GONZALEZ NANDIN EDUARDO;CASTILLA OSORIO JOSE MANUEL;DOMINGUEZ FERNANDEZ JUANLUIS;BUENDIA DOCTOR JAVIER;FERNANDEZ SANCHO ANTONIO;PALOMINO MARTINEZ DEL CERRO LUIS. Presidente: BELLOGONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: CALLEJA GARCIA RUIZ DAVID. Datos registrales. T 2293 , F 62, S 8, H CA 10893,I/A 74 (14.08.19).
04 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: JIMENEZ ROMERO FERNANDO. Secretario: GARCIA CASAS JUAN ANTONIO. Presidente:FERNANDEZ SANCHO ANTONIO. Vicepresid.: LARA VALS MARIA EUGENIA. Nombramientos. SecreNoConsj: RICO JURADOARACELI ISABEL. VsecrNoConsj: GARCIA CASAS JUAN ANTONIO. Presidente: LARA VALS MARIA EUGENIA. Datos registrales.T 2293 , F 61, S 8, H CA 10893, I/A 73 (26.06.19).
03 de Julio de 2019Nombramientos. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 2293 , F 61, S 8, H CA 10893, I/A 72(26.06.19).
20 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: QUINTANA FERNANDEZ ANGEL. Vicepresid.: QUINTANA FERNANDEZ ANGEL. Nombramientos.Consejero: LARA VALS MARIA EUGENIA. Vicepresid.: LARA VALS MARIA EUGENIA. Datos registrales. T 2293 , F 61, S 8, H CA10893, I/A 71 (12.12.18).
07 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ ARIAS ANGEL MARIA. Vicepresid.: GONZALEZ ARIAS ANGEL MARIA.Nombramientos. Consejero: QUINTANA FERNANDEZ ANGEL. Vicepresid.: QUINTANA FERNANDEZ ANGEL. Datos registrales. T2188 , F 222, S 8, H CA 10893, I/A 70 (29.11.18).
07 de Noviembre de 2018Nombramientos. Consejero: DOMINGUEZ CANO MARIA TRINIDAD;YESA HERRERA JESUS. Datos registrales. T 2188 , F 222, S8, H CA 10893, I/A 68 (30.10.18).
Revocaciones. Apoderado: SERRANO RODRIGUEZ RAFAEL. Apo.Man.Soli: SERRANO RODRIGUEZ RAFAEL EDUARDO. Datosregistrales. T 2188 , F 222, S 8, H CA 10893, I/A 69 (30.10.18).
26 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: QUINTANA FERNANDEZ ANGEL. Vicepresid.: QUINTANA FERNANDEZ ANGEL. Nombramientos.Consejero: GONZALEZ ARIAS ANGEL MARIA. Vicepresid.: GONZALEZ ARIAS ANGEL MARIA. Datos registrales. T 2188 , F 222, S8, H CA 10893, I/A 67 (19.07.17).
13 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ LORENZO DANIEL;BELLO GONZALEZ JAVIER. Datos registrales. T 2188 , F 221, S 8, HCA 10893, I/A 66 ( 3.02.17).
16 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: BUENO PINTO JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: PY RODRIGUEZ JESUSSACRAMENTADO. Datos registrales. T 2188 , F 221, S 8, H CA 10893, I/A 65 ( 8.11.16).
29 de Septiembre de 2016Nombramientos. Auditor: BRAZA GALLO Y BARRIOS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2188 , F 221, S 8, H CA 10893, I/A 64(21.09.16).
14 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Gerente: SERRANO RODRIGUEZ RAFAEL EDUARDO. Datos registrales. T 1978 , F 213, S 8, H CA 10893, I/A62 ( 6.04.16).
Ceses/Dimisiones. Consejero: SALES MONTES NOELIA. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ GASENI ANDREA. Datosregistrales. T 1978 , F 213, S 8, H CA 10893, I/A 61 ( 6.04.16).
Nombramientos. Apoderado: DE LA MONEDA FERNANDEZ-SANZ FRANCISCO. Datos registrales. T 2188 , F 220, S 8, H CA10893, I/A 63 ( 6.04.16).
23 de Marzo de 2016Modificaciones estatutarias. TITULO III. DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. ARTICULO 9潞.- ORGANOS DEGOBIERNO. El gobierno, direcci贸n, r茅gimen y administraci贸n de la sociedad estar谩 a cargo de la Junta General, el Consejo deAdministraci贸n, el Consejero-Delegado o Consejeros Delegados, en su caso, y el Director ARTICULO 22潞.- COMPETENCIAS. Ser谩competencia del Consejo de Administraci贸n lo siguiente: a) El gobierno y gesti贸n superior de la empresa. b) Aprobar anualmente elorganigrama y plantilla de la empresa, en el momento de la aprobaci贸n de los estados de previsi贸n de gastos e ingresos, as铆 comoCAPITULO III. DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS. ARTICULO 24潞.- NOMBRAMIENTO. Ser谩 competencia asimismo, del Consejode Administraci贸n el proceder al nombramiento de un Consejero Delegado, determinando el contenido y l铆mite de sus facultades, paralo cual se requerir谩 el acuerdo favorable de los dos ARTICULO 25潞.- RETRIBUCION. Los cargos de Consejero o ConsejerosDelegados designados por el Consejo de Administraci贸n podr谩n ser o no retribuidos. En el caso de que fueren retribuidoscorresponder谩 determinar dicha retribuci贸n a la Junta General. Corresponde al Consejo de Administraci贸n la ARTICULO 28.-FACULTADES.- Con independencia de las facultades que en cada caso o de forma gen茅rica le confiera el Consejo de Administraci贸n,a trav茅s del correspondiente poder, el Director-Gerente, estatutariamente, tendr谩 las siguientes: a) Dictar las instrucciones, de car谩ctergeneral o. Datos registrales. T 1978 , F 212, S 8, H CA 10893, I/A 60 (14.03.16).
14 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: CAPDEVILA PEDRAJAS RAUL. Presidente: CAPDEVILA PEDRAJAS RAUL. Consejero: PORRASMARIN JOSE ANTONIO;TORRES AGARRADO JUSTO JUAN;BOLLULLOS ALTAMIRANO ANTONIO;GANAZA PARRAGONZALO;BUENO PINTO JOSE LUIS;LORENZO GOMEZ CONSUELO. Con.Delegado: LORENZO GOMEZ CONSUELO.Vicepresid.: GANAZA PARRA GONZALO. Consejero: CORONADO ROSSO CARLOS;RICO GOMEZ FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ SANCHO ANTONIO;QUINTANA FERNANDEZ ANGEL;GOMEZ BORREGUEROSILVIA;BELLO GONZALEZ JAVIER;PEREZ LORENZO DANIEL;DE LA PASCUA RAMIREZ OLGA;BUENO PINTO JOSE LUIS;SALESMONTES NOELIA;OTERO GUILLEN DAVID. Presidente: FERNANDEZ SANCHO ANTONIO. Vicepresid.: QUINTANA FERNANDEZANGEL. Datos registrales. T 1978 , F 211, S 8, H CA 10893, I/A 59 ( 2.12.15).
16 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GANAZA PARRA GONZALO. Nombramientos. Con.Delegado: LORENZO GOMEZCONSUELO. Datos registrales. T 1978 , F 210, S 8, H CA 10893, I/A 58 ( 5.03.15).
19 de Diciembre de 2014Nombramientos. Consejero: CORONADO ROSSO CARLOS;RICO GOMEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1978 , F210, S 8, H CA 10893, I/A 57 (12.12.14).
08 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ BORREGUERO SILVIA;VEGA CHERNICHERO ALFONSA MARIA. Datos registrales. T1978 , F 210, S 8, H CA 10893, I/A 56 (30.06.14).
18 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MORESCO GARCIA ENRIQUE. Presidente: MORESCO GARCIA ENRIQUE. Vicepresid.:CAPDEVILA PEDRAJAS RAUL. Nombramientos. Consejero: LORENZO GOMEZ CONSUELO. Presidente: CAPDEVILAPEDRAJAS RAUL. Vicepresid.: GANAZA PARRA GONZALO. Modificaciones estatutarias. Art铆culo 11.- RESUMEN ARTICULO 11.-ORGANO SUPREMO.- La Junta General ostenta la plena soberan铆a de la sociedad y sus acuerdos, tomados con arreglo a derecho,obligan a la misma. La Corporaci贸n Municipal, constituida en Junta General, es el 贸rgano supremo de la Sociedad. Ser谩 Presidente dela Junta ARTICULO 28.- FACULTADES.- Con independencia de las facultades que en cada caso o de forma gen茅rica le confiera elConsejo de Administraci贸n, a trav茅s del correspondiente poder, el Director-Gerente, estatutariamente, tendr谩 las siguientes: a) Dictarlas instrucciones, de car谩cter general o CAPITULO II.- DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DEADMINISTRACION. ARTICULO 23.- El Presidente del Consejo de Administraci贸n ser谩 designado por la junta General de entre losmiembros del Consejo de Administraci贸n que sean miembros del Ayuntamiento Pleno. Al Presidente le sustituir谩 el ARTICULO 15.-COMPOSICION.- El Consejo de Administraci贸n estar谩 integrado por nueve miembros, llamados Consejeros tres de los cuales ser谩nmiembros del Ayuntamiento Pleno y los seis restantes, personas especialmente capacitadas. Los Consejeros ser谩n designados por lajunta General. De entre los ARTICULO 12.- COMPETENCIAS.- Corresponde a la Junta General: a) Designar a los miembros delConsejo de Administraci贸n. b) Fijar las remuneraciones del Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administraci贸n, del Consejeroo Consejeros Delegados y de los dem谩s Consejeros. c) Aumentar o disminuir. Datos registrales. T 1978 , F 208, S 8, H CA 10893,I/A 55 (11.06.14).
21 de Abril de 2014Reelecciones. Auditor: SIERRA MOLINA JUAN LUIS. Datos registrales. T 1978 , F 206, S 8, H CA 10893, I/A 49 ( 8.04.14).
Reelecciones. Auditor: SIERRA MOLINA JUAN LUIS. Datos registrales. T 1978 , F 207, S 8, H CA 10893, I/A 50 ( 8.04.14).
Reelecciones. Auditor: SIERRA MOLINA JUAN LUIS. Datos registrales. T 1978 , F 207, S 8, H CA 10893, I/A 51 ( 8.04.14).
Reelecciones. Auditor: SIERRA MOLINA JUAN LUIS. Datos registrales. T 1978 , F 207, S 8, H CA 10893, I/A 52 ( 8.04.14).
Reelecciones. Auditor: SIERRA MOLINA JUAN LUIS. Datos registrales. T 1978 , F 208, S 8, H CA 10893, I/A 53 ( 8.04.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ SANCHO ANTONIO. Nombramientos. Consejero: BUENO PINTO JOSE LUIS.Datos registrales. T 1978 , F 208, S 8, H CA 10893, I/A 54 ( 8.04.14).
11 de Septiembre de 2013Nombramientos. Consejero: GANAZA PARRA GONZALO. Con.Delegado: GANAZA PARRA GONZALO. Datos registrales. T 1978, F 205, S 8, H CA 10893, I/A 48 ( 3.09.13).
25 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: NIETO CORRALES CANDIDO JESUS. Con.Delegado: NIETO CORRALES CANDIDO JESUS. Datosregistrales. T 1978 , F 205, S 8, H CA 10893, I/A 47 (16.04.13).
23 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: BOLLULLOS ALTAMIRANO ANTONIO;FERNANDEZ SANCHO ANTONIO;TORRES AGARRADOJORGE ALBERTO;DE HARO GIMENEZ CARLOS;SEGURA ARROYO JUAN JOSE;REBOLLO SERRANO JOSE MARIA.Con.Delegado: REBOLLO SERRANO JOSE MARIA. Consejero: GOMEZ BORREGUERO SILVIA;BENAVENTE LARA LEOCADIAMARIA. Vicepresid.: BENAVENTE LARA LEOCADIA MARIA. Presidente: MORESCO GARCIA ENRIQUE. Consejero: MORESCOGARCIA ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: MORESCO GARCIA ENRIQUE;CAPDEVILA PEDRAJAS RAUL;GOMEZBORREGUERO SILVIA;NIETO CORRALES CANDIDO JESUS;PORRAS MARIN JOSE ANTONIO;TORRES AGARRADO JUSTOJUAN;VEGA CHERNICERO ALFONSA MARIA;BOLLULLOS ALTAMIRANO ANTONIO;FERNANDEZ SANCHO ANTONIO. Presidente:MORESCO GARCIA ENRIQUE. Vicepresid.: CAPDEVILA PEDRAJAS RAUL. Datos registrales. T 1978 , F 203, S 8, H CA 10893, I/A44 (12.12.11).
Nombramientos. Con.Delegado: NIETO CORRALES CANDIDO JESUS. Datos registrales. T 1978 , F 204, S 8, H CA 10893, I/A 45(12.12.11).
Nombramientos. Apoderado: SERRANO RODRIGUEZ RAFAEL. Datos registrales. T 1978 , F 204, S 8, H CA 10893, I/A 46(12.12.11).
01 de Diciembre de 2010Nombramientos. Con.Delegado: REBOLLO SERRANO JOSE MARIA. Datos registrales. T 1978 , F 203, S 8, H CA 10893, I/A 43(19.11.10).
06 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: REBOLLO SERRANO JOSE MARIA. Reelecciones. Consejero: DE HARO GIMENEZCARLOS;SEGURA ARROYO JUAN JOSE;REBOLLO SERRANO JOSE MARIA;FERNANDEZ SANCHO ANTONIO;BOLLULLOSALTAMIRANO ANTONIO;TORRES AGARRADO JORGE ALBERTO. Datos registrales. T 1978 , F 203, S 8, H CA 10893, I/A 42(27.08.10).
05 de Julio de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1,24 Euros. Resultante Suscrito: 352.792,87 Euros. Modificaciones estatutarias.REFUNCION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de objeto social. 1.- La sociedad El Puerto de Santa Mar铆a Global S.L.U.tiene como objeto social, de forma general, la prestaci贸n de servicios y ejecuci贸n de inversiones relacionadas con la comunicaci贸n einformaci贸n, las nuevas tecnolog铆as,inform谩tica y ofim谩tica, el equipamiento t茅cnico o tecnol贸gico, gesti贸n ca. Datos registrales. T1772 , F 180, S 8, H CA 10893, I/A 41 (21.06.10).
26 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO ZAMORANO EDUARDO;GOMEZ FERNANDEZ JUAN;PAYAN FERNANDEZ FRANCISCO.Con.Delegado: PAYAN FERNANDEZ FRANCISCO. Consejero: RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 1772 ,F 178, S 8, H CA 10893, I/A 40 (17.05.10).