Actos BORME de El Quexigal Sa
21 de Marzo de 2022Escisi贸n total. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: FINCA EL QUEXIGAL SL. QX PALACE2 SL. Disoluci贸n. Escision.Extinci贸n. Datos registrales. T 170, L 128, F 164, S 8, H AV 533, I/A 55 (28.02.22).
18 de Octubre de 2021Reelecciones. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLOMANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA MARIA;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA. Presidente: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUANCARLOS. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO. Consejero: ALVAREZMEZQUIRIZ EMILIO. Datos registrales. T 170, L 128, F 163, S 8, H AV 533, I/A 54 ( 5.10.21).
30 de Septiembre de 2021Fe de erratas: El plazo de duraci贸n del cargo del Secretario No Consejero es indefinido y no por cinco a帽os como se public贸 por errorpor su inscripcion 43陋. Datos registrales. T 132, L 90, F 13, S 8, H AV 533, I/A 43 ( 9.12.11).
19 de Febrero de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: EL ENEBRO S.A. Datos registrales. T 170, L 128, F 163, S 8, H AV533, I/A 53 ( 8.02.21).
11 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTA MARIA GUIRAO PEREZ. Datos registrales. T 148, L 106, F 65, S 8, H AV 533, I/A 51(26.03.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA VELILLA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 148, L 106, F 65, S 8, H AV 533, I/A 52(26.03.18).
30 de Agosto de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.188.977,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.521.827,00 Euros. Datos registrales. T 148, L106, F 65, S 8, H AV 533, I/A 50 (11.08.17).
09 de Agosto de 2016Reelecciones. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLOMANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA MARIA;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA. Presidente: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUANCARLOS. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO. Consejero: ALVAREZMEZQUIRIZ EMILIO. Datos registrales. T 148, L 106, F 64, S 8, H AV 533, I/A 49 ( 1.08.16).
23 de Enero de 2015Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ DIEZ DAVID. Apo.Man.Soli: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 148,L 106, F 63, S 8, H AV 533, I/A 47 ( 5.01.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA VELILLA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 148, L 106, F 63, S 8, H AV 533, I/A 48 (5.01.15).
30 de Agosto de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARRERO ANTIN SANTIAGO;MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS. Apo.Sol.: PARES RONPEDRO;PFLUGER SAMPER VICTOR JUAN;GONZALEZ DE SANTIAGO EVA INES;MARTIN GARCIA JUAN. Apo.Man.Soli:JORDANO PEREZ JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 132, L 90, F 13, S 8, H AV 533, I/A 46 (14.08.12).
02 de Julio de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: ESCUDERO HERREROS ELEUTERIO. Datos registrales. T 132, L 90, F 13, S 8, H AV 533, I/A 45(18.06.12).
15 de Febrero de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 141.240,00 Euros. Desembolsado: 141.240,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.710.804,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.710.804,00 Euros. Datos registrales. T 132, L 90, F 13, S 8, H AV 533, I/A 44 (31.01.12).
26 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Nombramientos. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLOMANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA;ALVAREZMEZQUIRIZ MARTA MARIA. Presidente: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS. SecreNoConsj: RODRIGUEZ-ARIAS DELGADOFERNANDO. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Otros conceptos: Se d谩 nueva redacci贸n alos art铆culo 9潞, 11潞, 12潞, 13潞 y 14潞 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 132, L 90, F 13, S 8, H AV 533, I/A 43 ( 9.12.11).
01 de Marzo de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: SALAZAR ROMAN ANTONIO. Datos registrales. T 132, L 90, F 11, S 8, H AV 533, I/A 41 ( 7.02.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ ORTEGA ANA BELEN;ESCORIAL PINELA CARLOS. Datos registrales. T 132, L 90, F12, S 8, H AV 533, I/A 42 ( 7.02.11).
07 de Mayo de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 61.204,00 Euros. Desembolsado: 61.204,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.569.564,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.569.564,00 Euros. Datos registrales. T 132, L 90, F 11, S 8, H AV 533, I/A 40 (16.04.10).
30 de Marzo de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 61.204,00 Euros. Desembolsado: 61.204,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.508.360,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.508.360,00 Euros. Datos registrales. T 132, L 90, F 11, S 8, H AV 533, I/A 39 (14.03.09).
23 de Febrero de 2009Reelecciones. Adm. Unico: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 132, L 90, F 11, S 8, H AV 533, I/A 38(11.02.09).