Actos BORME de El Rompido Golf Club Sociedad Anonima
01 de Diciembre de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.691.961,40 Euros. Resultante Suscrito: 7.213.098,60 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 5潞.- El capital de la Sociedad se fija en la suma de SIETE MILLONESDOSCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y OCHO EUROS Y SESENTA CENTIMOS 7.213.098,60 E- representado por OCHOMILLONES NOVECIENTAS CINCO MIL SESENTA -8.905.060- acciones ordinarias nominativas de OCHENTA Y. Datos registrales.T 1141 , F 172, S 8, H H 25755, I/A 7 (24.11.23).
12 de Diciembre de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.905.060,00 Euros. Datos registrales. T 1141 , F171, S 8, H H 25755, I/A 5 (21.11.22).
Nombramientos. Consejero: BUSTILLO ICETA JUAN. Datos registrales. T 1141 , F 172, S 8, H H 25755, I/A 6 (21.11.22).
13 de Diciembre de 2021Modificaciones estatutarias. 9.bis. Funcionamiento Junta General.- ARTICULO 9潞.bis.- La Juntas Generales se podr谩n celebrar enla localidad donde la sociedad tenga su domicilio o, alternativamente, dentro del t茅rmino municipal de Bilbao". Datos registrales. T1141 , F 171, S 8, H H 25755, I/A 4 (29.11.21).
05 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ARDANZA FRESNO DANIEL. Reelecciones. Consejero: SOROA ZUBIAGA BARBARA;SOROAGALLANO JOSE MIGUEL;SOROA ZUBIAGA PEDRO;URIGUEN VILLALBA ALFONSO. Presidente: SOROA ZUBIAGA PEDRO.Secretario: SOROA ZUBIAGA BARBARA. Datos registrales. T 1141 , F 170, S 8, H H 25755, I/A 3 (21.06.21).
10 de Febrero de 2020Cambio de domicilio social. CTRA CARTAYA-EL ROMPIDO Km 7 (CARTAYA). Datos registrales. T 1141 , F 156, S 8, H H 25755,I/A 1 . (27.01.20).
Cambio de domicilio social. CTRA CARTAYA-EL ROMPIDO Km 7 (CARTAYA). Datos registrales. T 1141 , F 170, S 8, H H 25755,I/A 2 (27.01.20).
05 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ARANA YBARRA ALVARO;GEA ANDRES JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: BARRILEROYARNOZ EDUARDO;ARDANZA FRESNO DANIEL. Datos registrales. T 4083 , F 110, S 8, H BI 32181, I/A 24 (27.06.18).
10 de Septiembre de 2015Reelecciones. Consejero: SOROA ZUBIAGA BARBARA;SOROA GALLANO JOSE MIGUEL;SOROA ZUBIAGA PEDRO;ARANAYBARRA ALVARO;GEA ANDRES JOSE MARIA;URIGUEN VILLALBA ALFONSO. Con.Delegado: SOROA GALLANO JOSE MIGUEL.Presidente: SOROA ZUBIAGA PEDRO. Secretario: SOROA ZUBIAGA BARBARA. Datos registrales. T 4083 , F 109, S 8, H BI32181, I/A 23 ( 3.09.15).
03 de Diciembre de 2014Cambio de domicilio social. C/ MAXIMO AGUIRRE 18 BIS 6潞 - DEPARTAMENTO 6 (BILBAO). Datos registrales. T 4083 , F 109,S 8, H BI 32181, I/A 22 (25.11.14).
28 de Noviembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 450.000,00 Euros. Desembolsado: 450.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.305.060,00 Euros.Resultante Desembolsado: 9.305.060,00 Euros. Datos registrales. T 4083 , F 108, S 8, H BI 32181, I/A 21 (11.11.11).
21 de Noviembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.450.000,00 Euros. Desembolsado: 1.450.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.855.060,00 Euros.Resultante Desembolsado: 8.855.060,00 Euros. Datos registrales. T 4083 , F 108, S 8, H BI 32181, I/A 20 ( 7.11.11).
03 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MERCADAL ARGUIMBAU ANTONIO. Secretario: MERCADAL ARGUIMBAU ANTONIO. Consejero:MERCADAL ARGUIMBAU FRANCISCO. Nombramientos. Secretario: SOROA ZUBIAGA BARBARA. Reelecciones. Consejero:SOROA ZUBIAGA BARBARA;SOROA GALLANO JOSE MIGUEL;SOROA ZUBIAGA PEDRO;ARANA YBARRA ALVARO;GEAANDRES JOSE MARIA;URIGUEN VILLALBA ALFONSO. Con.Delegado: SOROA GALLANO JOSE MIGUEL. Presidente: SOROAZUBIAGA PEDRO. Datos registrales. T 4083 , F 107, S 8, H BI 32181, I/A 19 (16.08.10).
16 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. Presidente: SOROA GALLANO JOSE MIGUEL. Nombramientos. Presidente: SOROA ZUBIAGA PEDRO.Datos registrales. T 4083 , F 107, S 8, H BI 32181, I/A 18 ( 6.07.09).