Buscador CIF Logo

Actos BORME El Torreon Ocio Y Comercio Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera El Torreon Ocio Y Comercio Sa

Actos BORME El Torreon Ocio Y Comercio Sa - A85564508

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para El Torreon Ocio Y Comercio Sa con CIF A85564508

馃敊 Perfil de El Torreon Ocio Y Comercio Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de El Torreon Ocio Y Comercio Sa

18 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: ANDREU ANDRES FRANCISCO. Datos registrales. T 36148 , F 214, S 8, H M 473684, I/A 21(11.12.20).

20 de Octubre de 2020
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 915/2020. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 11/09/2020. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO.Resoluciones: Se declara en Concurso Voluntario a esta sociedad, quien conserva las facultades de administraci贸n y disposici贸n sobresu patrimonio, quedando sometido el ejercicio de 茅stas a la intervenci贸n de la administraci贸n concursal.- Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 915/2020. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 11/09/2020. Resoluciones acordando la intervenci贸n osuspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Datos registrales. T 36148 , F 214, S 8, H M 473684, I/A A (13.10.20).

22 de Abril de 2020
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: FERNANDEZ-PAINO DIEZ PEDRO. Reelecciones. Consejero: GARCIA CEBALLOSFERNANDO. Con.Delegado: GARCIA CEBALLOS FERNANDO. Secretario: GARCIA CEBALLOS FERNANDO. Datos registrales. T36148 , F 214, S 8, H M 473684, I/A 20 (15.04.20).

03 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Auditor: ABANTOS AUDITORES Y ASESORES SL. Datos registrales. T 36148 , F 213, S 8, H M 473684, I/A 19(24.08.18).

02 de Octubre de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.251.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:489.281,00 Euros. Desembolsado: 489.281,00 Euros. Resultante Suscrito: 489.281,00 Euros. Resultante Desembolsado: 489.281,00Euros. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5 Y 5 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datosregistrales. T 26286 , F 54, S 8, H M 473684, I/A 18 (21.09.17).

02 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: PROMOVAZAN SL. Representan: VAZQUEZ ARRIBAS PABLO. Consejero: VAZQUEZ ARRIBASPABLO. Datos registrales. T 26286 , F 54, S 8, H M 473684, I/A 17 (26.07.17).

17 de Julio de 2017
Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ ORTI ARTURO. Datos registrales. T 26286 , F 54, S 8, H M 473684, I/A 16 (10.07.17).

04 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Secretario: PROMOVAZAN SL. Nombramientos. Secretario: GARCIA CEBALLOS FERNANDO. VsecrNoConsj:FERNANDEZ-PAINO DIEZ PEDRO. Datos registrales. T 26286 , F 53, S 8, H M 473684, I/A 14 (24.04.17).

Nombramientos. Consejero: LORENTE ROYO MARIA CONSUELO;VAZQUEZ ARRIBAS PABLO. Datos registrales. T 26286 , F54, S 8, H M 473684, I/A 15 (24.04.17).

12 de Julio de 2016
Ceses/Dimisiones. Representan: GARCIA CEBALLOS FERNANDO. Nombramientos. Representan: VAZQUEZ ARRIBAS PABLO.Datos registrales. T 26286 , F 53, S 8, H M 473684, I/A 13 ( 4.07.16).

19 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANDREU ANDRES FRANCISCO;VAZQUEZ ORTI ARTURO. Presidente: ANDREU ANDRESFRANCISCO. Secretario: VAZQUEZ ORTI ARTURO. Nombramientos. Consejero: TENANCY SL;PROMOVAZAN SL. Representan:ANDREU ANDRES FRANCISCO;GARCIA CEBALLOS FERNANDO. Presidente: TENANCY SL. Secretario: PROMOVAZAN SL.Con.Delegado: GARCIA CEBALLOS FERNANDO. Modificaciones estatutarias. 10 bis. Pagina web corporativa.-. 16. Duraci贸n.Retribuci贸n.-. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.eltorreondepozuelo.com. Datos registrales.T 26286 , F 52, S 8, H M 473684, I/A 12 (12.08.15).

17 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAZQUEZ ARRIBAS PABLO;ANDREU LORENTE FRANCISCO;LOZANO GARCIA JUAN JOSE.Revocaciones. Apo.Sol.: LOZANO GARCIA JUAN JOSE. Modificaciones estatutarias. 10. Funcionamiento Junta Gral.-. Datosregistrales. T 26286 , F 51, S 8, H M 473684, I/A 11 ( 9.03.15).

13 de Agosto de 2014
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.000,00 Euros. Desembolsado: 1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.251.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.251.000,00 Euros. Datos registrales. T 26286 , F 49, S 8, H M 473684, I/A 10 ( 1.08.14).

07 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANDREU ANDRES FRANCISCO. Presidente: ANDREU ANDRES FRANCISCO. Consejero:VAZQUEZ ORTI ARTURO. Secretario: VAZQUEZ ORTI ARTURO. Consejero: LORENTE ROYO MARIA CONSUELO. Cons.Del.Sol:ANDREU ANDRES FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: ANDREU ANDRES FRANCISCO;VAZQUEZ ORTIARTURO;VAZQUEZ ARRIBAS PABLO;ANDREU LORENTE FRANCISCO;LOZANO GARCIA JUAN JOSE;GARCIA CEBALLOSFERNANDO. Presidente: ANDREU ANDRES FRANCISCO. Secretario: VAZQUEZ ORTI ARTURO. Datos registrales. T 26286 , F 48,S 8, H M 473684, I/A 9 (30.07.14).

09 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: LOZANO GARCIA JUAN JOSE;GARCIA CEBALLOS FERNANDO. Datos registrales. T 26286 , F 47, S8, H M 473684, I/A 8 (28.11.13).

08 de Noviembre de 2012
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.687.500,00 Euros. Datos registrales. T 26286 , F 47, S 8, H M 473684, I/A7 (26.10.12).

13 de Julio de 2011
Nombramientos. Auditor: GESEM AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 26286 , F 47, S 8, H M 473684, I/A 6 (1.07.11).

09 de Diciembre de 2010
Otros conceptos: POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DEL 22 DE OCTUBRE DE 2010, SE HA ACORDADO CONCEDER UNNUEVO PLAZO, QUE VENCERA EL 22 DEOCTBRE DE 2012, PARA EFECTUAR LOS DESEMBOLSOS PASIVOS DEL CAPITALSOCIAL PENDIENTE. Datos registrales. T 26286 , F 46, S 8, H M 473684, I/A 5 (26.11.10).

13 de Abril de 2010
Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ ORTI ARTURO. Datos registrales. T 26286 , F 45, S 8, H M 473684, I/A 3 (30.03.10).

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: VAZQUEZ ORTI ARTURO. Datos registrales. T 26286 , F 46, S 8, H M 473684, I/A 4 (30.03.10).

14 de Enero de 2009
Nombramientos. Apoderado: LORENTE ROYO MARIA CONSUELO. Datos registrales. T 26286 , F 44, S 8, H M 473684, I/A 2(30.12.08).

02 de Enero de 2009
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 27.10.08562500. Objeto social: REDACCION DE LOS PROYECTOS DE OBRA,ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DEMAS TRABAJOS TECNICOS QUE SEAN NECESARIOS. EJECUCION DE LAS OBRAS DE NUEVACONSTRUCCION Y DE REHABILITACION, ETC. Domicilio: AVDA JUAN XXIII, NUMERO 10, - CENTRO COMERCIAL EL (POZUELODE ALARCON). Capital suscrito: 2.250.000,00 Euros. Desembolsado: 562.500,00 Euros. Nombramientos. Consejero: ANDREUANDRES FRANCISCO. Presidente: ANDREU ANDRES FRANCISCO. Consejero: VAZQUEZ ORTI ARTURO. Secretario: VAZQUEZORTI ARTURO. Consejero: LORENTE ROYO MARIA CONSUELO. Cons.Del.Sol: ANDREU ANDRES FRANCISCO;VAZQUEZ ORTIARTURO. Datos registrales. T 26286 , F 39, S 8, H M 473684, I/A 1 (19.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n