Buscador CIF Logo

Actos BORME Elate Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Elate Sa

Actos BORME Elate Sa - A80063670

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Elate Sa con CIF A80063670

馃敊 Perfil de Elate Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Elate Sa

28 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: CARRILLO BLAS ANTONIO. Datos registrales. T 40549 , F 50, S 8, H M 28344, I/A 24(20.12.22).

13 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Secretario: GOMEZ PIQUERO LUIS FERNANDO. Nombramientos. Secretario: DELGADO MESONEROFRANCISCO JAVIER. Reelecciones. Consejero: RAMIREZ CABALLERO FRANCISCO;GOMEZ PIQUERO LUISFERNANDO;CARRILLO BLAS ANTONIO;DELGADO MESONERO FRANCISCO JAVIER. Presidente: RAMIREZ CABALLEROFRANCISCO. Cons.Del.Man: RAMIREZ CABALLERO FRANCISCO;GOMEZ PIQUERO LUIS FERNANDO;CARRILLO BLASANTONIO;DELGADO MESONERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 11691 , F 70, S 8, H M 28344, I/A 23 ( 6.07.20).

28 de Junio de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 304.286,30 Euros. Resultante Suscrito: 1.217.145,20 Euros. Datos registrales. T 11691 ,F 70, S 8, H M 28344, I/A 22 (24.06.19).

24 de Abril de 2018
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del articulo 16 de los estatutos y nueva redacci贸n de la totalidad de los estatutos sociales.. Ampliacion del objeto social. la fabricaci贸n, ensamblaje, compra, venta, importaci贸n y exportaci贸n de circuitos impresos e

28 de Marzo de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 304.286,30 Euros. Resultante Suscrito: 1.521.431,50 Euros. Datos registrales. T 11691 ,F 67, S 8, H M 28344, I/A 20 (20.03.18).

10 de Noviembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ESPINOSA GONZALEZ JUAN MIGUEL. Cons.Del.Man: ESPINOSA GONZALEZ JUAN MIGUEL.Datos registrales. T 11691 , F 67, S 8, H M 28344, I/A 19 (27.10.16).

19 de Agosto de 2015
Reelecciones. Consejero: RAMIREZ CABALLERO FRANCISCO;GOMEZ PIQUERO LUIS FERNANDO;CARRILLO BLASANTONIO;DELGADO MESONERO FRANCISCO JAVIER;ESPINOSA GONZALEZ JUAN MIGUEL. Presidente: RAMIREZCABALLERO FRANCISCO. Secretario: GOMEZ PIQUERO LUIS FERNANDO. Cons.Del.Man: RAMIREZ CABALLEROFRANCISCO;GOMEZ PIQUERO LUIS FERNANDO;CARRILLO BLAS ANTONIO;DELGADO MESONERO FRANCISCOJAVIER;ESPINOSA GONZALEZ JUAN MIGUEL. Datos registrales. T 11691 , F 66, S 8, H M 28344, I/A 18 (11.08.15).

04 de Noviembre de 2013
Modificaciones estatutarias. 15. Funcionamiento Junta Gral.- modificado. 21. Administraci贸n y Representacion.- modificado. Datosregistrales. T 11691 , F 66, S 8, H M 28344, I/A 17 (24.10.13).

08 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: RAMIREZ CABALLERO FRANCISCO. Secretario: GOMEZ PIQUERO LUIS FERNANDO. Consejero:RAMIREZ CABALLERO FRANCISCO;GOMEZ PIQUERO LUIS FERNANDO;MARTIN GONZALEZ ALEJANDRO;DELGADOMESONERO FRANCISCO JAVIER;CARRILLO BLAS ANTONIO;ESPINOSA GONZALEZ JUAN MIGUEL. Cons.Del.Man: RAMIREZCABALLERO FRANCISCO;GOMEZ PIQUERO LUIS FERNANDO;MARTIN GONZALEZ ALEJANDRO;DELGADO MESONEROFRANCISCO JAVIER;ESPINOSA GONZALEZ JUAN MIGUEL;CARRILLO BLAS ANTONIO. Nombramientos. Consejero: RAMIREZCABALLERO FRANCISCO;GOMEZ PIQUERO LUIS FERNANDO;CARRILLO BLAS ANTONIO;DELGADO MESONERO FRANCISCOJAVIER;ESPINOSA GONZALEZ JUAN MIGUEL. Presidente: RAMIREZ CABALLERO FRANCISCO. Secretario: GOMEZ PIQUEROLUIS FERNANDO. Cons.Del.Man: RAMIREZ CABALLERO FRANCISCO;GOMEZ PIQUERO LUIS FERNANDO;CARRILLO BLASANTONIO;DELGADO MESONERO FRANCISCO JAVIER;ESPINOSA GONZALEZ JUAN MIGUEL. Datos registrales. T 11691 , F 65,

04 de Febrero de 2009
Nombramientos. Auditor: VALCARCEL JIMENEZ JOSE. Aud.Supl.: AUDILEX AUDITORES SL. Datos registrales. T 11691 , F 65, S8, H M 28344, I/A 15 (22.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n