Actos BORME de Elche Club De Futbol Sad
31 de Mayo de 2023Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 3709 , F 216, S 8, H A 42149, I/A 111 (23.05.23).
05 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: RODRIGO BRAGARNIK CHRISTIAN. Datos registrales. T 3709 , F 215, S 8, H A 42149, I/A 110(27.06.22).
09 de Mayo de 2022Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 3709 , F 215, S 8, H A 42149, I/A 109 (29.04.22).
30 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ BARRIOS PATRICIA. Nombramientos. Consejero: SCORE CLUB 2019 SL. Datosregistrales. T 3709 , F 215, S 8, H A 42149, I/A 108 (22.04.21).
28 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ BARRIOS PATRICIA;GINER GOMEZ JULIO CESAR;MARTINEZ MONTOROALEJANDRO. Nombramientos. Apo.Manc.: GINER GOMEZ JULIO CESAR;MARTINEZ MONTORO ALEJANDRO;RODRIGOBRAGARNIK CHRISTIAN. Datos registrales. T 3709 , F 215, S 8, H A 42149, I/A 107 (20.04.21).
19 de Abril de 2021Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 3709 , F 214, S 8, H A 42149, I/A 106 (12.04.21).
22 de Diciembre de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.045.780,28 Euros. Resultante Suscrito: 5.533.950,88 Euros. Datos registrales. T 3709 , F 214, S8, H A 42149, I/A 105 (14.12.20).
19 de Junio de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.800.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.488.170,60 Euros. Datos registrales. T 3709 , F 213, S8, H A 42149, I/A 104 ( 9.06.20).
22 de Mayo de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: BUITRAGO MARHUENDA JOAQUIN;ANTON PEREZ OLAYA ANTONIO TOMAS;RODRIGUEZBARRIOS PATRICIA. Datos registrales. T 3709 , F 213, S 8, H A 42149, I/A 103 ( 8.05.20).
24 de Febrero de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 24.878.291,32 Euros. Resultante Suscrito: 314.915,08 Euros. Ampliaci贸n de capital.Capital: 1.373.255,52 Euros. Resultante Suscrito: 1.688.170,60 Euros. Datos registrales. T 3709 , F 213, S 8, H A 42149, I/A 102(14.02.20).
19 de Febrero de 2020Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 3709 , F 213, S 8, H A 42149, I/A 101 (10.02.20).
11 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: BUITRAGO MARHUENDA JOAQUIN;RODRIGUEZ BARRIOS PATRICIA;TENAMA INVERSIONESSL;SERRANO TORRES JUAN;MOXICA PRUNEDA PASCUAL. Presidente: BUITRAGO MARHUENDA JOAQUIN. SecreNoConsj:SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE. Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ MONTORO ALEJANDRO;GINER GOMEZ JULIOCESAR;RODRIGUEZ BARRIOS PATRICIA. Consejero: GINER GOMEZ JULIO CESAR;MARTINEZ MONTORO ALEJANDRO;FLOROCOSENZA OMAR LUIS;BUITRAGO MARHUENDA JOAQUIN;RODRIGUEZ BARRIOS PATRICIA. Presidente: BUITRAGOMARHUENDA JOAQUIN. Vicepresid.: GINER GOMEZ JULIO CESAR. Secretario: MARTINEZ MONTORO ALEJANDRO.Modificaciones estatutarias. Art铆culo 20潞. Consejo de administraci贸n. Art铆culo 24. Retribuci贸n del 贸rgano de administraci贸n. Art铆culo35. Presidencia honor铆fica. Datos registrales. T 3709 , F 212, S 8, H A 42149, I/A 100 ( 3.02.20).
10 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE;GARCIA JUAN DIEGO;SEGARRA ANIORTE RAMONJOSE;MARUENDA SANCHIS JOSE LUIS. Datos registrales. T 3709 , F 212, S 8, H A 42149, I/A 99 (28.11.19).
29 de Noviembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.142.060,80 Euros. Resultante Suscrito: 25.193.206,40 Euros. P谩gina web de la sociedad.Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.elchecf.es. Datos registrales. T 3709 , F 211, S 8, H A 42149, I/A 98 (21.11.19).
26 de Noviembre de 2019Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 3709 , F 211, S 8, H A 42149, I/A 97 (18.11.19).
05 de Septiembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.003.363,20 Euros. Resultante Suscrito: 24.051.145,60 Euros. Datos registrales. T 3709 , F 211, S8, H A 42149, I/A 96 (29.08.19).
03 de Septiembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.381.718,40 Euros. Resultante Suscrito: 5.678.652,80 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:15.666.729,60 Euros. Resultante Suscrito: 21.345.382,40 Euros. Datos registrales. T 3709 , F 210, S 8, H A 42149, I/A 94 (26.08.19).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.702.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.047.782,40 Euros. Datos registrales. T 3709 , F 210, S8, H A 42149, I/A 95 (27.08.19).
29 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MESEGUER GARCIA FRANCISCO VICENTE;MARUENDA SANCHIS JOSE LUIS. Nombramientos.Consejero: RODRIGUEZ BARRIOS PATRICIA. Con.Delegado: RODRIGUEZ BARRIOS PATRICIA. Datos registrales. T 3709 , F209, S 8, H A 42149, I/A 92 (21.08.19).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA JUAN DIEGO;SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE;MOXICA PRUNEDAPASCUAL;RODRIGUEZ BARRIOS PATRICIA. Con.Delegado: RODRIGUEZ BARRIOS PATRICIA. Presidente: GARCIA JUAN DIEGO.Secretario: SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE. Nombramientos. Consejero: TENAMA INVERSIONES SL;RODRIGUEZ BARRIOSPATRICIA;MOXICA PRUNEDA PASCUAL;SERRANO TORRES JUAN;BUITRAGO MARHUENDA JOAQUIN. Apo.Manc.: BUITRAGOMARHUENDA JOAQUIN;ANTON PEREZ OLAYA ANTONIO TOMAS;RODRIGUEZ BARRIOS PATRICIA. Presidente: BUITRAGOMARHUENDA JOAQUIN. SecreNoConsj: SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE. Datos registrales. T 3709 , F 209, S 8, H A 42149,I/A 93 (22.08.19).
10 de Julio de 2019Fe de erratas: Error, en la inscripci贸n 19陋, en el importe de la cantidad desembolsada, siendo la correcta: 1.355.001,60 euros. Datosregistrales. T 3709 , F 209, S 8, H A 42149, I/A 91 (17.06.19).
25 de Junio de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.355.001,60 Euros. Resultante Suscrito: 4.296.934,40 Euros. Datos registrales. T 3709 , F 209, S8, H A 42149, I/A 91 (17.06.19).
15 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: OLIVER LAZARO JAIME SALVADOR;SANCHEZ MATEOS FRANCISCO MANUEL;HELIKEFOOTBAL MANAGEMENT SL;MARUENDA SANCHIS JOSE LUIS;NOHALES HERRAIZ CESAR;SEGARRA ANIORTE RAMONJOSE;MOXICA PRUNEDA PASCUAL;MESEGUER GARCIA FRANCISCO VICENTE. Presidente: HELIKE FOOTBAL MANAGEMENTSL. Secretario: SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE. Nombramientos. Consejero: MOXICA PRUNEDA PASCUAL;MESEGUERGARCIA FRANCISCO VICENTE;GARCIA JUAN DIEGO;SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE;MARUENDA SANCHIS JOSE LUIS.Presidente: GARCIA JUAN DIEGO. Secretario: SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE. Apo.Manc.: GARCIA JUAN DIEGO;SEGARRAANIORTE RAMON JOSE;MARUENDA SANCHIS JOSE LUIS. Consejero: MESEGUER GARCIA FRANCISCO VICENTE;MOXICAPRUNEDA PASCUAL. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 21潞.- Composici贸n y nombramiento del consejo de Administraci贸n.-. Datos registrales. T 3709 , F 208, S 8, H A 42149, I/A 90 ( 3.10.18).
05 de Octubre de 2018Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 334/2015. Fecha de resoluci贸n 6/08/2015. Revocaci贸n de administradoresconcursales. Juzgado: num. 3 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. Juez: JOAQUIN FERNANDEZ MU脩OZ. Administrador Concursal.Fecha 18/04/2017, NIF/CIF 21977404F. PEREZ POMARES CARLOS. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 334/2015.Fecha de resoluci贸n 6/08/2015. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 3 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE.Juez: JOAQUIN FERNANDEZ MU脩OZ. Auxiliar Delegado Concursal. Fecha 18/04/2017, NIF/CIF 25313526W. BLANCO MANSOMARIA BEGO脩A. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 334/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 18/04/2017. Sentenciade aprobaci贸n del convenio. Juzgado: num. 0 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. Juez: JOSE LUIS FORTEA GORBE. Datosregistrales. T 3709 , F 208, S 8, H A 42149, I/A 89 (26.09.18).
23 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: SERRANO RAYA JUAN;SERRANO RAYA JUAN;ALBEROLA MOLINES JOSE;CONTRERAS ESCLAPEZJUAN ANTONIO. Datos registrales. T 3709 , F 207, S 8, H A 42149, I/A 88 (16.02.17).
07 de Febrero de 2017Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 334/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 11/11/2016. Auto de apertura de la fase deconvenio. Juzgado: num. 3 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. Juez: JOSE LUIS FORTEA GORBE. Datos registrales. T 3709 , F207, S 8, H A 42149, I/A 87 (30.01.17).
01 de Febrero de 2017Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 3709 , F 207, S 8, H A 42149, I/A 84 b ( 9.01.17).
11 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: SERRANO RAYA JUAN;ALBEROLA MOLINES JOSE;CONTRERAS ESCLAPEZ JUAN ANTONIO.Nombramientos. Consejero: MARUENDA SANCHIS JOSE LUIS. Apo.Manc.: SERRANO RAYA JUAN;ALBEROLA MOLINESJOSE;NOHALES HERRAIZ CESAR;SANCHEZ MATEOS FRANCISCO MANUEL;OLIVER LAZARO JAIME SALVADOR;CONTRERASESCLAPEZ JUAN ANTONIO;SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE;HELIKE FOOTBAL MANAGEMENT SL. Datos registrales. T 3709, F 207, S 8, H A 42149, I/A 86 ( 4.10.16).
17 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Presidente: SERRANO RAYA JUAN. Vicepresid.: ALBEROLA MOLINES JOSE. Nombramientos. Consejero:HELIKE FOOTBAL MANAGEMENT SL. Presidente: HELIKE FOOTBAL MANAGEMENT SL. Datos registrales. T 3709 , F 207, S 8, HA 42149, I/A 85 (10.06.16).
09 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: PASCUAL SANSANO JUAN. Nombramientos. Apo.Manc.: PASCUAL SANSANO JUAN;SERRANORAYA JUAN. Datos registrales. T 3709 , F 206, S 8, H A 42149, I/A 83 ( 2.06.16).
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES ALC SL. Datos registrales. T 3709 , F 207, S 8, H A 42149, I/A 84 ( 2.06.16).
08 de Junio de 2016Modificaciones estatutarias. =ARTICULO -16潞.- ASISTENCIA A LAS JUNTAS=.-. Datos registrales. T 3709 , F 206, S 8, H A42149, I/A 82 ( 1.06.16).
26 de Mayo de 2016Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 334/2015. Fecha de resoluci贸n 6/08/2015. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 3 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. Juez: JOAQUIN FERNANDEZ MU脩OZ. Auxiliar Delegado Concursal. Fecha6/08/2015, NIF/CIF 25313526W. BLANCO MANSO MARIA BEGO脩A. Datos registrales. T 3709 , F 206, S 8, H A 42149, I/A 81(19.05.16).
08 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ANGUIX GARRIDO JUAN FRANCISCO. Presidente: ANGUIX GARRIDO JUAN FRANCISCO.Con.Delegado: ANGUIX GARRIDO JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 3709 , F 205, S 8, H A 42149, I/A 76 (30.12.15).
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUBIO PEREZ DANIEL;ROMAN VERA FRANCISCO MANUEL;GARCIA HITA JOSEANTONIO;VILLAVERDE CARNEVALLI RAMON. Vicepresid.: RUBIO PEREZ DANIEL;ROMAN VERA FRANCISCO MANUEL.Consejero: GONZALEZ MATEU JORGE. SecreNoConsj: PRADO JIMENEZ JERONIMO LUCAS. Datos registrales. T 3709 , F 205, S8, H A 42149, I/A 77 (30.12.15).
Nombramientos. Presidente: SERRANO RAYA JUAN. Vicepresid.: ALBEROLA MOLINES JOSE. Secretario: SEGARRA ANIORTERAMON JOSE. Datos registrales. T 3709 , F 206, S 8, H A 42149, I/A 80 (30.12.15).
Nombramientos. Consejero: SERRANO RAYA JUAN;ALBEROLA MOLINES JOSE;CONTRERAS ESCLAPEZ JUANANTONIO;PASCUAL SANSANO JUAN;NOHALES HERRAIZ CESAR;SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE. Datos registrales. T3709 , F 206, S 8, H A 42149, I/A 79 (30.12.15).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MATIAS FERRANDEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 3709 , F 206, S 8, H A 42149, I/A 78(30.12.15).
02 de Septiembre de 2015Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 334/2015. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 6/08/2015. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 3 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. Juez: JOAQUIN FERNANDEZ MU脩OZ. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 334/2015. Fecha de resoluci贸n 6/08/2015. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 3DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. Juez: JOAQUIN FERNANDEZ MU脩OZ. Administrador Concursal. Fecha 6/08/2015, NIF/CIF21977404F. PEREZ POMARES CARLOS. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 334/2015. FIRME: No, Fecha deresoluci贸n 6/08/2015. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n delconcursado. Juzgado: num. 3 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. Juez: JOAQUIN FERNANDEZ MU脩OZ. Datos registrales. T 3709, F 205, S 8, H A 42149, I/A A (26.08.15).
02 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTINEZ MARTINEZ TERCERO PEDRO JOSE. Consejero: ROCAMORA MATEOANTONIO;VIDAL ALBALADEJO JOSE JAVIER;SEPULCRE COVES JOSE. Presidente: SEPULCRE COVES JOSE. Con.Delegado:SEPULCRE COVES JOSE. Nombramientos. Consejero: ANGUIX GARRIDO JUAN FRANCISCO;MATIAS FERRANDEZ JOSEMARIA;RUBIO PEREZ DANIEL;GONZALEZ MATEU JORGE;ROMAN VERA FRANCISCO MANUEL;VILLAVERDE CARNEVALLIRAMON. Presidente: ANGUIX GARRIDO JUAN FRANCISCO. Vicepresid.: RUBIO PEREZ DANIEL;ROMAN VERA FRANCISCOMANUEL. Con.Delegado: ANGUIX GARRIDO JUAN FRANCISCO. SecreNoConsj: PRADO JIMENEZ JERONIMO LUCAS. Datosregistrales. T 3709 , F 205, S 8, H A 42149, I/A 75 (26.05.15).
25 de Marzo de 2015Nombramientos. Con.Delegado: SEPULCRE COVES JOSE. Datos registrales. T 3709 , F 205, S 8, H A 42149, I/A 74 (17.03.15).
09 de Marzo de 2015Reelecciones. Auditor: SERRANO TORRES JUAN. Consejero: SANCHEZ MATEOS FRANCISCO MANUEL. Modificacionesestatutarias. ARTICULO 21潞.- Consejo de Administraci贸n.- . Datos registrales. T 3709 , F 204, S 8, H A 42149, I/A 73 (23.02.15).
02 de Marzo de 2015Nombramientos. Consejero: OLIVER LAZARO JAIME SALVADOR. Datos registrales. T 3709 , F 204, S 8, H A 42149, I/A 72(23.02.15).
06 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RUBIO PEREZ DANIEL. Con.Delegado: SEPULCRE COVES JOSE. Reelecciones. Consejero:SEPULCRE COVES JOSE. Presidente: SEPULCRE COVES JOSE. Datos registrales. T 3709 , F 204, S 8, H A 42149, I/A 71(29.01.15).
05 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS GINER LORENZO. Datos registrales. T 3709 , F 204, S 8, H A 42149, I/A 70 (28.01.15).
03 de Febrero de 2015Reelecciones. Auditor: SERRANO TORRES JUAN;SERRANO TORRES JUAN. Datos registrales. T 3709 , F 203, S 8, H A 42149,I/A 69 (27.01.15).
24 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: ANGUIX GARRIDO JUAN FRANCISCO. Revocaciones. Apoderado: LOPEZ FERNANDEZFRANCISCO. Apo.Manc.: POVEDA MARTINEZ AMADOR;SERRANO RAYA JUAN;RUIZ SANCHEZ JOAQUIN;LLOPIS QUILESJOSE;LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO;NAVARRO SOLER ANDRES. Datos registrales. T 3709 , F 203, S 8, H A 42149, I/A 68(14.03.14).
07 de Enero de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 19.122.563,20 Euros. Resultante Suscrito: 2.941.932,80 Euros. Datos registrales. T 3709, F 203, S 8, H A 42149, I/A 67 (26.12.13).
02 de Enero de 2014Otros conceptos: Cambio de denominaci贸n del domicilio social, siendo actualmente Avenida Manuel Mart铆nez Valero, n煤mero 3.Datos registrales. T 3709 , F 203, S 8, H A 42149, I/A 66 (23.12.13).
02 de Septiembre de 2013Reelecciones. Auditor: SERRANO TORRES JUAN. Datos registrales. T 3709 , F 203, S 8, H A 42149, I/A 65 (23.08.13).
20 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARADO LOZANO TOMAS;ROCAMORA MATEO MANUEL. Secretario: ROCAMORA MATEOMANUEL. Consejero: SEGURA RAMIREZ JOSE MANUEL;GARCIA HITA JOSE ANTONIO;RUBIO PEREZ DANIEL.Nombramientos. Consejero: ANGUIX GARRIDO JUAN FRANCISCO;RUBIO PEREZ DANIEL;GARCIA HITA JOSEANTONIO;ROCAMORA MATEO ANTONIO;CAMPOS GINER LORENZO;VIDAL ALBALADEJO JOSE JAVIER. SecreNoConsj:MARTINEZ MARTINEZ TERCERO PEDRO JOSE. Datos registrales. T 2509 , F 166, S 8, H A 42149, I/A 64 (12.06.13).
30 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTON MARTINEZ JOSE ANTONIO;ROCAMORA MATEO ANTONIO. Cons.Del.Man: ROCAMORAMATEO ANTONIO;SEPULCRE COVES JOSE;ALVARADO LOZANO TOMAS. Nombramientos. Consejero: GARCIA HITA JOSEANTONIO;RUBIO PEREZ DANIEL. Con.Delegado: SEPULCRE COVES JOSE. Datos registrales. T 2509 , F 166, S 8, H A 42149, I/A63 (20.12.11).
10 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMIREZ CASTRO JUAN CARLOS. Cons.Del.Man: RAMIREZ CASTRO JUAN CARLOS. Consejero:MARTINEZ MARTINEZ TERCERO PEDRO JOSE. Nombramientos. Consejero: ROCAMORA MATEO ANTONIO. Cons.Del.Man:ROCAMORA MATEO ANTONIO. Consejero: SEGURA RAMIREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2509 , F 166, S 8, H A 42149,I/A 62 (27.04.11).
18 de Abril de 2011Reelecciones. Auditor: SERRANO TORRES JUAN. Datos registrales. T 2509 , F 165, S 8, H A 42149, I/A 61 ( 6.04.11).
05 de Abril de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 14.000.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 22.064.496,00 Euros. Datos registrales. T 2509 , F 165,S 8, H A 42149, I/A 60 (24.03.11).
01 de Abril de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 10.461.599,50 Euros. Resultante Suscrito: 6.955.080,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Capital: 1.109.016,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.064.096,00 Euros. Datos registrales. T 2509 , F 151, S 8, H A 42149, I/A 59(22.03.11).
31 de Marzo de 2010Reelecciones. Auditor: SERRANO TORRES JUAN. Datos registrales. T 2509 , F 151, S 8, H A 42149, I/A 58 (18.03.10).
30 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MINAYA HORTELANO MARTIN;NAVARRO HIDALGO ANSELMO;SEGARRA ANIORTE RAMONJOSE;FUENTES NAVARRO DIEGO. Vicepresid.: FUENTES NAVARRO DIEGO. Cons.Del.Sol: SEPULCRE COVES JOSE.Nombramientos. Consejero: ALVARADO LOZANO TOMAS;SANCHEZ MATEOS FRANCISCO MANUEL;MARTINEZ MARTINEZTERCERO PEDRO JOSE. Cons.Del.Man: RAMIREZ CASTRO JUAN CARLOS;SEPULCRE COVES JOSE;ALVARADO LOZANOTOMAS. Reelecciones. Consejero: SEPULCRE COVES JOSE. Presidente: SEPULCRE COVES JOSE. Consejero: ROCAMORAMATEO MANUEL;ANTON MARTINEZ JOSE ANTONIO. Secretario: ROCAMORA MATEO MANUEL. Consejero: RAMIREZ CASTROJUAN CARLOS. Datos registrales. T 2509 , F 151, S 8, H A 42149, I/A 57 (17.03.10).
09 de Febrero de 2010Nombramientos. Consejero: RAMIREZ CASTRO JUAN CARLOS. Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.999.655,00 Euros. ResultanteSuscrito: 17.416.679,50 Euros. Datos registrales. T 2509 , F 150, S 8, H A 42149, I/A 56 (28.01.10).
08 de Febrero de 2010Reelecciones. Auditor: SERRANO TORRES JUAN. Datos registrales. T 2509 , F 150, S 8, H A 42149, I/A 55 (27.01.10).
21 de Enero de 2010Reelecciones. Auditor: SERRANO TORRES JUAN. Datos registrales. T 2509 , F 150, S 8, H A 42149, I/A 54 ( 8.01.10).
19 de Enero de 2010Ceses/Dimisiones. Secretario: SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE. Nombramientos. Secretario: ROCAMORA MATEO MANUEL.Datos registrales. T 2509 , F 150, S 8, H A 42149, I/A 53 ( 7.01.10).