Actos BORME de Electro Mercantil Holding Dam Sa
28 de Noviembre de 2022Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ANTO脩ANZAS MARIN JOSU. Nombramientos. Consejero:ANTO脩ANZAS MARIN JOSU. Reelecciones. Consejero: ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL;ABAD LOPEZ MIGUEL ANGEL.Presidente: ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 35048 , F 156, S 8, H M 630346, I/A 8 (21.11.22).
04 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN DE LA CRUZ LUIS CARLOS. Nombramientos. Consejero: RECONDO GARAYALDEFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 35048 , F 155, S 8, H M 630346, I/A 7 (26.04.22).
30 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: BURON CORRAL VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 35048 , F 155, S 8, H M 630346, I/A 5(23.07.21).
Nombramientos. Aud.C.Con.: CMA AUDIT & CONSULTING SLP. Datos registrales. T 35048 , F 155, S 8, H M 630346, I/A 6(23.07.21).
31 de Octubre de 2017Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 500.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo sextode los estatutos sociales.. Datos registrales. T 35048 , F 154, S 8, H M 630346, I/A 3 (23.10.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROZAS GUILLEN JUAN. Presidente: ROZAS GUILLEN JUAN. Secretario: MARTIN DE LA CRUZLUIS CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: BURON CORRAL VICTOR MANUEL. Consejero: ALVAREZ HERNANDEZ JOSEMANUEL;ABAD LOPEZ MIGUEL ANGEL. Presidente: ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:250.000,00 Euros. Desembolsado: 250.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.250.000,00 Euros. Resultante Desembolsado:1.250.000,00 Euros. Datos registrales. T 35048 , F 154, S 8, H M 630346, I/A 4 (24.10.17).
30 de Octubre de 2017Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 1陋 EL CAPITAL DESEMBOLSADO, SIENDO EL CORRECTO500.000E. Datos registrales. T 35048 , F 150, S 8, H M 630346, I/A 1 (27.09.16).
13 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN DE LA CRUZ LUIS CARLOS;ROZAS GUILLEN JUAN;ANTO脩ANZAS MARIN JOSU;ALVAREZHERNANDEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 35048 , F 153, S 8, H M 630346, I/A 2 ( 3.02.17).
05 de Octubre de 2016Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.09.16. Objeto social: 1.- La compraventa, almacenaje y distribuci贸n al por mayor y al pormenor de toda clase de material el茅ctrico, electr贸nico, dom贸tica, seguridad, electrodom茅sticos, telecomunicaci贸n, iluminaci贸n,conductor, industrial, fontaner铆a, calefacci贸n, climatizaci贸n y energ铆as renovables, accesorios de todo t. Domicilio: C/ RAMON Y CAJAL15, (LEGANES). Capital suscrito: 1.000.000,00 Euros. Desembolsado: 1.000.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: MARTIN DELA CRUZ LUIS CARLOS;ROZAS GUILLEN JUAN;ANTO脩ANZAS MARIN JOSU. Secretario: MARTIN DE LA CRUZ LUIS CARLOS.Presidente: ROZAS GUILLEN JUAN. Datos registrales. T 35048 , F 150, S 8, H M 630346, I/A 1 (27.09.16).