Buscador CIF Logo

Actos BORME Electromecanica Naval E Industrial Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Electromecanica Naval E Industrial Sa

Actos BORME Electromecanica Naval E Industrial Sa - A36623353

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Pontevedra para Electromecanica Naval E Industrial Sa con CIF A36623353

馃敊 Perfil de Electromecanica Naval E Industrial Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Pontevedra

Actos BORME de Electromecanica Naval E Industrial Sa

28 de Abril de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE. Presidente: GARCIA COSTAS JOSE. Consejero: PEREZ COSTASFERNANDO. Vicepresid.: PEREZ COSTAS FERNANDO. Consejero: PEREZ COSTAS MARIA DEL ROSARIO. Secretario: PEREZCOSTAS MARIA DEL ROSARIO. Consejero: PEREZ COSTAS MARINA. Cons.Del.Sol: GARCIA COSTAS JOSE;PEREZ COSTASFERNANDO. Nombramientos. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE. Presidente: GARCIA COSTAS JOSE. Cons.Del.Sol: GARCIACOSTAS JOSE. Consejero: PEREZ COSTAS FERNANDO. Vicepresid.: PEREZ COSTAS FERNANDO. Cons.Del.Sol: PEREZCOSTAS FERNANDO. Consejero: PEREZ COSTAS MARIA DEL ROSARIO. Secretario: PEREZ COSTAS MARIA DEL ROSARIO.Consejero: PEREZ COSTAS MARINA. Datos registrales. T 4202, L 4202, F 101, S 8, H PO 5851, I/A 27 (19.04.23).

09 de Agosto de 2022
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: EMENASA MONTAJES NAVALES SA. Datos registrales. T 4202, L 4202, F 99, S8, H PO 5851, I/A 26 ( 2.08.22).

16 de Marzo de 2022
Reelecciones. Auditor: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.C.Con.: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.Supl.:EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD. Aud.Su.C.Con: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORESSOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 4202, L 4202, F 99, S 8, H PO 5851, I/A 25 ( 7.03.22).

08 de Septiembre de 2021
Reelecciones. Auditor: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.C.Con.: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.Supl.:EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD. Aud.Su.C.Con: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORESSOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 4202, L 4202, F 99, S 8, H PO 5851, I/A 24 ( 1.09.21).

28 de Agosto de 2020
Reelecciones. Auditor: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.C.Con.: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.Supl.:EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD. Aud.Su.C.Con: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORESSOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 4202, L 4202, F 99, S 8, H PO 5851, I/A 23 (21.08.20).

18 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Auditor: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.Su.C.Con: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORESSOCIEDAD LIMITAD. Aud.C.Con.: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.Supl.: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORESSOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 4202, L 4202, F 99, S 8, H PO 5851, I/A 22 (12.09.19).

30 de Agosto de 2019
Nombramientos. Aud.Supl.: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD. Aud.C.Con.: DE LA CALLE AMAROMIGUEL RAMON. Aud.Su.C.Con: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD. Auditor: DE LA CALLE AMAROMIGUEL RAMON. Datos registrales. T 4202, L 4202, F 98, S 8, H PO 5851, I/A 21 (22.08.19).

10 de Diciembre de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.404,04 Euros. Resultante Suscrito: 87.747,46 Euros. Datos registrales. T 4202, L 4202,F 98, S 8, H PO 5851, I/A 20 ( 3.12.18).

01 de Septiembre de 2017
Reelecciones. Auditor: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.Supl.: GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL. Datosregistrales. T 4202, L 4202, F 98, S 8, H PO 5851, I/A 19 (24.08.17).

07 de Agosto de 2017
P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: http://www.emenasa.es/. Datos registrales. T 4202, L 4202, F98, S 8, H PO 5851, I/A 18 (28.07.17).

13 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE;PEREZ COSTAS FERNANDO. Vicepresid.: PEREZ COSTAS FERNANDO.Cons.Del.Sol: PEREZ COSTAS FERNANDO. Consejero: PEREZ COSTAS MARIA DEL ROSARIO. Secretario: PEREZ COSTASMARIA DEL ROSARIO. Cons.Del.Sol: PEREZ COSTAS MARIA DEL ROSARIO. Consejero: PEREZ COSTAS MARINA. Cons.Del.Sol:GARCIA COSTAS JOSE. Presidente: GARCIA COSTAS JOSE. Nombramientos. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE. Presidente:GARCIA COSTAS JOSE. Consejero: PEREZ COSTAS FERNANDO. Vicepresid.: PEREZ COSTAS FERNANDO. Consejero: PEREZCOSTAS MARIA DEL ROSARIO. Secretario: PEREZ COSTAS MARIA DEL ROSARIO. Consejero: PEREZ COSTAS MARINA.Cons.Del.Sol: GARCIA COSTAS JOSE;PEREZ COSTAS FERNANDO. Otros conceptos: Se REFUNDEN los ESTATUTOSSOCIALES. Datos registrales. T 1176, L 1176, F 165, S 8, H PO 5851, I/A 17 ( 5.07.17).

06 de Febrero de 2017
Nombramientos. Consejero: PEREZ COSTAS MARINA. Datos registrales. T 1176, L 1176, F 165, S 8, H PO 5851, I/A 16(30.01.17).

17 de Octubre de 2016
Cambio de domicilio social. AVDA BEIRAMAR 75 (VIGO). Datos registrales. T 1176, L 1176, F 165, S 8, H PO 5851, I/A 15 (6.10.16).

07 de Octubre de 2016
Nombramientos. Aud.C.Con.: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.Supl.C.C: GONZALEZ CRESPAN JUAN M. Datosregistrales. T 1176, L 1176, F 165, S 8, H PO 5851, I/A 14 (29.09.16).

18 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.Supl.: GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL. Datosregistrales. T 1176, L 1176, F 165, S 8, H PO 5851, I/A 13 (10.08.16).

12 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE;PEREZ COSTAS FERNANDO;PEREZ COSTAS MARIA DEL ROSARIO.Presidente: GARCIA COSTAS JOSE. Cons.Del.Sol: GARCIA COSTAS JOSE. Vicepresid.: PEREZ COSTAS FERNANDO.Cons.Del.Sol: PEREZ COSTAS FERNANDO. Secretario: PEREZ COSTAS MARIA DEL ROSARIO. Cons.Del.Sol: PEREZ COSTASMARIA DEL ROSARIO. Nombramientos. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE. Presidente: GARCIA COSTAS JOSE. Cons.Del.Sol:GARCIA COSTAS JOSE. Consejero: PEREZ COSTAS FERNANDO. Vicepresid.: PEREZ COSTAS FERNANDO. Cons.Del.Sol:PEREZ COSTAS FERNANDO. Consejero: PEREZ COSTAS MARIA DEL ROSARIO. Secretario: PEREZ COSTAS MARIA DELROSARIO. Cons.Del.Sol: PEREZ COSTAS MARIA DEL ROSARIO. Datos registrales. T 1176, L 1176, F 163, S 8, H PO 5851, I/A 12( 3.08.16).

07 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Auditor: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.Supl.: GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL. Datosregistrales. T 1176, L 1176, F 163, S 8, H PO 5851, I/A 11 (30.10.14).

01 de Octubre de 2010
Reelecciones. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE;PEREZ COSTAS FERNANDO;PEREZ COSTAS MARIA DEL ROSARIO.Presidente: GARCIA COSTAS JOSE. Vicepresid.: PEREZ COSTAS FERNANDO. Secretario: PEREZ COSTAS MARIA DELROSARIO. Cons.Del.Sol: PEREZ COSTAS FERNANDO;PEREZ COSTAS MARIA DEL ROSARIO;GARCIA COSTAS JOSE. Otrosconceptos: Se modifica el art铆culo 21潞 de los Estatutos Sociales, quedando establecida la duraci贸n del cargo de administrador en seisa帽os. Datos registrales. T 1176, L 1176, F 162, S 8, H PO 5851, I/A 10 (21.09.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n