Buscador CIF Logo

Actos BORME Electromedical Sociedad Limitada

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Electromedical Sociedad Limitada

Actos BORME Electromedical Sociedad Limitada - B46563219

Tenemos registrados 27 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Electromedical Sociedad Limitada con CIF B46563219

🔙 Perfil de Electromedical Sociedad Limitada
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Electromedical Sociedad Limitada

28 de Julio de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LANDRE JULIEN NICOLAS. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA DOLORES;CORCOLES GARCIAJOSE LUIS. Datos registrales. T 10999, L 8277, F 171, S 8, H V 16752, I/A 34 (21.07.21).

Nombramientos. Apoderado: GUERRERO FERNANDEZ MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 10999, L 8277, F 171, S 8, H V16752, I/A 35 (21.07.21).

16 de Julio de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA DOLORES;DE LAROSA COZAR MARIA DOLORES. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 196, S 8, H V 16752, I/A 33 ( 9.07.20).

22 de Mayo de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ MARTOS PEDRO. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA DOLORES;DE LA ROSACOZAR MARIA DOLORES. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 194, S 8, H V 16752, I/A 30 (13.05.20).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIEZ DE PABLOS JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA DOLORES;DE LAROSA COZAR MARIA DOLORES. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 195, S 8, H V 16752, I/A 31 (13.05.20).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ REAL ROBERTO. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA DOLORES;DE LA ROSA COZARMARIA DOLORES. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 195, S 8, H V 16752, I/A 32 (13.05.20).

07 de Junio de 2019
Fe de erratas: El consejero correcto es D. Jose Manuel Martínez García no D. Jose Manuel García Martínez como por error sepublicó en el Boletín 44 de fecha 05/03/19 y referencia 01029852019. El consejero delegado correcto es D. Jose Manuel MartínezGarcía no D. Jose Manuel García Martínez como por error se publicó en el Boletín 44 de fecha 05/03/19 y referencia 01029852019.Datos registrales. T 3921, L 1233, F 191, S 8, H V 16752, I/A 26 (26.02.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: LANDRE JULIEN NICOLAS. Secretario: LANDRE JULIEN NICOLAS. Nombramientos. Secretario:DE LA ROSA COZAR MARIA DOLORES. Reelecciones. Presidente: DUPLAN LUDOVIC MICHEL ALAIN. Datos registrales. T3921, L 1233, F 193, S 8, H V 16752, I/A 29 (31.05.19).

26 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LANDRE JULIEN NICOLAS;MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL;LASHERAS LOPEZ MARIADOLORES. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 192, S 8, H V 16752, I/A 27 (17.04.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LANDRE JULIEN NICOLAS. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA DOLORES;CORCOLESGARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 193, S 8, H V 16752, I/A 28 (17.04.19).

05 de Marzo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMOS PUIG FRANCISCO;RAMOS VAYA FRANCESC XAVIER;RAMOS VAYA MARIAMONICA;CASTELLANOS ALONSO JAIME;OLTRA CANET DIEGO. Presidente: RAMOS PUIG FRANCISCO. Secretario: RAMOSVAYA FRANCESC XAVIER. Con.Delegado: RAMOS VAYA MARIA MONICA. Revocaciones. Apoderado: RAMOS VAYA MONICA.Nombramientos. Consejero: DUPLAN LUDOVIC MICHEL ALAIN;GARCIA MARTINEZ JOSE MANUEL;LANDRE JULIENNICOLAS;LASHERAS LOPEZ MARIA DOLORES. Presidente: DUPLAN LUDOVIC MICHEL ALAIN. Secretario: LANDRE JULIENNICOLAS. Con.Delegado: GARCIA MARTINEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 191, S 8, H V 16752, I/A 26(26.02.19).

28 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL;LANDRE JULIEN NICOLAS;LASHERAS LOPEZ MARIADOLORES. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 186, S 8, H V 16752, I/A 20 (20.12.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LANDRE JULIEN NICOLAS;MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL;LASHERAS LOPEZ MARIADOLORES. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 188, S 8, H V 16752, I/A 21 (20.12.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ REAL ROBERTO. Apo.Manc.: LOPEZ REAL ROBERTO;LANDRE JULIEN NICOLAS;LASHERASLOPEZ MARIA DOLORES;CORCOLES GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 189, S 8, H V 16752, I/A 22(20.12.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: DIEZ DE PABLOS JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: DIEZ DE PABLOS JOSE ANTONIO;LANDRE JULIENNICOLAS;LASHERAS LOPEZ MARIA DOLORES;CORCOLES GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 190, S 8,H V 16752, I/A 23 (20.12.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ MARTOS PEDRO. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTOS PEDRO;LANDRE JULIENNICOLAS;LASHERAS LOPEZ MARIA DOLORES;CORCOLES GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 191, S 8,H V 16752, I/A 24 (20.12.18).

Declaración de unipersonalidad. Socio único: EIFFAGE ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3921, L 1233, F191, S 8, H V 16752, I/A 25 (20.12.18).

01 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: RAMOS VAYA FRANCESC XAVIER. Nombramientos. Con.Delegado: RAMOS VAYA MARIAMONICA. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 186, S 8, H V 16752, I/A 19 (24.11.16).

04 de Enero de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDEZ PEREZ JOSE;MANSANET RIPOLL RAFAEL. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 186, S 8,H V 16752, I/A 18 (24.12.15).

20 de Agosto de 2014
Cambio de domicilio social. C/ CENTRAL 7 - POLIGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL (RIBA-ROJA DE TURIA). Datos registrales.T 3921, L 1233, F 186, S 8, H V 16752, I/A 17 (12.08.14).

23 de Julio de 2014
Modificaciones estatutarias. Modifcación del art. 7 de los Estatutos Sociales.. Modificación del art. 8 de los Estatutos Sociales..Datos registrales. T 3921, L 1233, F 185, S 8, H V 16752, I/A 16 (16.07.14).

14 de Abril de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: OLTRA ABOGADOS & ASESORES TRIBUTARIOS SOCIEDAD LIM. Nombramientos. Consejero:RAMOS PUIG FRANCISCO;RAMOS VAYA FRANCESC XAVIER;RAMOS VAYA MARIA MONICA;CASTELLANOS ALONSOJAIME;OLTRA CANET DIEGO. Presidente: RAMOS PUIG FRANCISCO. Secretario: RAMOS VAYA FRANCESC XAVIER.Con.Delegado: RAMOS VAYA FRANCESC XAVIER. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración:Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 185, S 8, H V 16752, I/A 15 ( 7.04.14).

10 de Abril de 2013
Nombramientos. Auditor: GONZALEZ MADROÑO GUZMAN JOAQUIN. Aud.Supl.: FORCADA DAVALOS JOSE LUIS. Datosregistrales. T 3921, L 1233, F 184, S 8, H V 16752, I/A 14 ( 3.04.13).

18 de Mayo de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RAMOS VAYA FRANCESC XAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: OLTRA ABOGADOS &ASESORES TRIBUTARIOS SOCIEDAD LIM. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 14º. - REQUISITOS DE LAS

08 de Julio de 2011
Nombramientos. Apoderado: RAMOS VAYA MONICA. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 184, S 8, H V 16752, I/A 12 (29.06.11).

05 de Marzo de 2010
Nombramientos. Auditor: GAGO GAGO PABLO. Aud.Supl.: FORCADA DAVALOS JOSE LUIS. Datos registrales. T 3921, L 1233, F184, S 8, H V 16752, I/A 11 (24.02.10).

28 de Julio de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: RAMOS VAYA MONICA;MANSANET ENGUIX RAFAEL. Nombramientos. Adm. Unico:RAMOS VAYA FRANCESC XAVIER. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradoresmancomunados a Administrador único. Datos registrales. T 3921, L 1233, F 182, S 8, H V 16752, I/A 10 (17.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información