Buscador CIF Logo

Actos BORME Electroquimica Del Noroeste Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Electroquimica Del Noroeste Sa

Actos BORME Electroquimica Del Noroeste Sa - A36002541

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Pontevedra para Electroquimica Del Noroeste Sa con CIF A36002541

馃敊 Perfil de Electroquimica Del Noroeste Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Pontevedra

Actos BORME de Electroquimica Del Noroeste Sa

20 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4364, L 4364, F 61, S 8, H PO 4369, I/A 162 (13.12.23).

05 de Septiembre de 2022
Reelecciones. Consejero: MESQUITA DOS SANTOS SOUSA ANTONIO;AZEREDO AMORIM GONCALO NUNO;ALVES DELGADOLUIS HENRIQUE MARCELINO. Presidente: ALVES DELGADO LUIS HENRIQUE MARCELINO. Datos registrales. T 4364, L 4364, F61, S 8, H PO 4369, I/A 161 (24.08.22).

08 de Abril de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROSALES CARBALLA JUAN. Apo.Manc.: ROSALES CARBALLA JUAN;ROSALES CARBALLA JUAN.Datos registrales. T 4364, L 4364, F 60, S 8, H PO 4369, I/A 160 (31.03.22).

14 de Julio de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: NESBIT REBELO DA SILVA LUIS AUGUSTO;PEREIRA BARROS QUINTA SARA ALEXANDRA.Datos registrales. T 4364, L 4364, F 60, S 8, H PO 4369, I/A 159 ( 5.07.21).

28 de Mayo de 2021
Cambio de domicilio social. C/ MICHELENA 1, - PLANTA SEGUNDA, OFICINA LETRA G/ (PONTEVEDRA). Datos registrales. T4253, L 4253, F 99, S 8, H PO 4369, I/A 158 (21.05.21).

10 de Marzo de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4253, L 4253, F 99, S 8, H PO 4369, I/A 157 ( 1.03.21).

17 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ OLIVEIRA JOSE MANUEL;IRIBARNEGARAY FERNANDEZ JUAN CARLOS. Apo.Sol.:GONZALEZ OLIVEIRA JOSE MANUEL. Apo.Man.Soli: MESQUITA DOS SANTOS SOUSA ANTONIO;AZEREDO AMORIN GONCALONUNO;NESBIT REBELO DA SILVA LUIS AUGUSTO. Datos registrales. T 4253, L 4253, F 98, S 8, H PO 4369, I/A 156 ( 5.02.21).

28 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: AZEREDO AMORIN GONCALO NUNO. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero:GONCALVES FERNANDES FUGAS JOAO JORGE. Presidente: GONCALVES FERNANDES FUGAS JOAO JORGE. Revocaciones.Apo.Manc.: GONCALVES FERNANDES FUGAS JOAO JORGE. Nombramientos. Apo.Manc.: ALVES DELGADO LUIS HENRIQUEMAERCELINO. Consejero: ALVES DELGADO LUIS HENRIQUE MARCELINO;AZEREDO AMORIN GONCALO NUNO. Presidente:ALVES DELGADO LUIS HENRIQUE MARCELINO. Reelecciones. Consejero: MESQUITA DOS SANTOS SOUSA ANTONIO. Datosregistrales. T 4253, L 4253, F 97, S 8, H PO 4369, I/A 155 (19.10.20).

17 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: VALE CARDOSO VICENTE PEDRO MANUEL. Nombramientos. Consejero: AZEREDO AMORINGONCALO NUNO. Apo.Manc.: MESQUITA DOS SANTOS SOUSA ANTONIO;ROSALES CARBALLA JUAN;AZEREDO AMORINGONCALO NUNO;IRIBARNEGARAY FERNANDEZ JUAN CARLOS. Otros conceptos: En el Consejo de Administraci贸n de fecha01/10/2019 se deja constancia de que seg煤n la inscripci贸n 27陋 del Registro Mercantil de Estarreja, Portugal, han variado los datossocietarios del Accionista Unico de la Sociedad, concretamente su nombre, que ha cambiado a BONDALTI CHEMICALS, S.A. Datosregistrales. T 4253, L 4253, F 96, S 8, H PO 4369, I/A 154 ( 5.12.19).

14 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4253, L 4253, F 96, S 8, H PO 4369, I/A 153 ( 3.10.19).

19 de Agosto de 2019
Otros conceptos: Se modifican los ARTICULOS 7 y 10 de los Estatutos Sociales relativosa los derechos y obligaciones de losaccionistas y la indivisibilidad de las acciones. Datos registrales. T 4253, L 4253, F 95, S 8, H PO 4369, I/A 152 ( 8.08.19).

14 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ECHEVARRIA MORENO AMAYA ASUNCION. Apo.Sol.: ECHEVARRIA MORENO AMAYAASUNCION. Datos registrales. T 4253, L 4253, F 95, S 8, H PO 4369, I/A 149 ( 6.05.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: PAZOS REISSMANN DAVID PABLO. Datos registrales. T 4253, L 4253, F 95, S 8, H PO 4369, I/A 150 (6.05.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: SERUMANO SL. Datos registrales. T 4253, L 4253, F 95, S 8, H PO 4369, I/A 151 ( 6.05.19).

19 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4253, L 4253, F 95, S 8, H PO 4369, I/A 148 ( 9.11.18).

11 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEIXOTO SALINAS DE MOURA PEDRO MANUEL. Vicesecret.: TELLECHEA MORA I脩IGO.Nombramientos. Consejero: VALE CARDOSO VICENTE PEDRO MANUEL. Reelecciones. Consejero: GONCALVESFERNANDES FUGAS JOAO JORGE;MESQUITA DOS SANTOS SOUSA ANTONIO. Presidente: GONCALVES FERNANDES FUGASJOAO JORGE. Datos registrales. T 2371, L 2371, F 218, S 8, H PO 4369, I/A 147 ( 3.10.18).

06 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2371, L 2371, F 218, S 8, H PO 4369, I/A 146 (25.10.17).

02 de Junio de 2016
Reelecciones. Presidente: GONCALVES FERNANDES FUGAS JOAO JORGE. Consejero: GONCALVES FERNANDES FUGASJOAO JORGE;MESQUITA DOS SANTOS SOUSA ANTONIO;PEIXOTO SALINAS DE MOURA PEDRO MANUEL. Datos registrales.T 2371, L 2371, F 218, S 8, H PO 4369, I/A 145 (25.05.16).

18 de Agosto de 2014
Reelecciones. Consejero: GONCALVES FERNANDES FUGAS JOAO JORGE;MESQUITA DOS SANTOS SOUSAANTONIO;PEIXOTO SALINAS DE MOURA PEDRO MANUEL. Presidente: GONCALVES FERNANDES FUGAS JOAO JORGE.Datos registrales. T 2371, L 2371, F 217, S 8, H PO 4369, I/A 143 ( 6.08.14).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2371, L 2371, F 218, S 8, H PO 4369, I/A 144 ( 8.08.14).

27 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: ESCAT CORTES FRANCISCO. Nombramientos. Apo.Sol.: ECHEVARRIA MORENO AMAYAASUNCION. SecreNoConsj: DIEZ VERGARA MAITANE. VsecrNoConsj: MAFUZ GUMIEL ROSA-MARIA. Reelecciones. Consejero:GONCALVES FERNANDES FUGAS JOAO JORGE;MESQUITA DOS SANTOS SOUSA ANTONIO;PEIXOTO SALINAS DE MOURAPEDRO MANUEL. Presidente: GONCALVES FERNANDES FUGAS JOAO JORGE. Datos registrales. T 2371, L 2371, F 217, S 8, HPO 4369, I/A 142 (19.03.13).

20 de Octubre de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2371, L 2371, F 216, S 8, H PO 4369, I/A 141 ( 4.10.11).

18 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: PIRES MESQUITA PIRES JOSE IGNACIO. Nombramientos. Consejero: PEIXOTO SALINAS DEMOURA PEDRO MANUEL. Reelecciones. Presidente: GONCALVES FERNANDES FUGAS JOAO JORGE. Consejero:GONCALVES FERNANDES FUGAS JOAO JORGE;MESQUITA DOS SANTOS SOUSA ANTONIO. Datos registrales. T 2371, L2371, F 216, S 8, H PO 4369, I/A 140 ( 5.08.10).

10 de Junio de 2009
Reelecciones. Consejero: GONCALVES FERNANDES FUGAS JOAO JORGE. Presidente: GONCALVES FERNANDES FUGASJOAO JORGE. Consejero: MESQUITA DOS SANTOS SOUSA ANTONIO;PIRES MESQUITA PIRES JOSE IGNACIO. Datosregistrales. T 2371, L 2371, F 216, S 8, H PO 4369, I/A 139 (28.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n