Buscador CIF Logo

Actos BORME Elice Entrepot Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Elice Entrepot Sa

Actos BORME Elice Entrepot Sa - A36661098

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Pontevedra para Elice Entrepot Sa con CIF A36661098

馃敊 Perfil de Elice Entrepot Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Pontevedra

Actos BORME de Elice Entrepot Sa

20 de Septiembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ GARCIA HUGO CRISANTO;ROMON OLEA JORGE;TOUZA TOUZA FRANCISCOJAVIER;ULLOA ALONSO EDELMIRO. Secretario: GONZALEZ GARCIA HUGO CRISANTO. Presidente: TOUZA TOUZA FRANCISCOJAVIER. Revocaciones. Apo.Manc.: TOUZA TOUZA FRANCISCO-JAVIER;GONZALEZ GARCIA HUGO CRISANTO;ULLOAALONSO EDELMIRO;ROMON OLEA JORGE. Apo.Sol.: AGRAFOJO COSTAS HERMINIO. Nombramientos. Adm. Unico:COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA DEL PUERTO DE VI. Otros conceptos: Refundici贸n de los estatutos sociales en unnuevo texto. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 2608, L2608, F 205, S 8, H PO 5169, I/A 35 ( 8.09.21).

Nombramientos. Apo.Manc.: AGRAFOJO COSTAS HERMINIO;CASTRO GORDEJUELA DANIEL;GONZALEZ GARCIA HUGOCRISANTO.Apo.Sol.: AGRAFOJO COSTAS HERMINIO. Datos registrales. T 2608, L 2608, F 208, S 8, H PO 5169, I/A 36 ( 8.09.21).

07 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: SUAREZ-LLANOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO. Vicepresid.: SUAREZ-LLANOS RODRIGUEZJOSE ANTONIO. Revocaciones. Apo.Manc.: GUISANDE COSTAS JAIME. Apo.Sol.: GUISANDE COSTAS JAIME.Nombramientos. Apo.Manc.: TOUZA TOUZA FRANCISCO-JAVIER;GONZALEZ GARCIA HUGO CRISANTO;ULLOA ALONSOEDELMIRO;ROMON OLEA JORGE. Apo.Sol.: AGRAFOJO COSTAS HERMINIO. Otros conceptos: El socio 煤nico acuerda lamoficaci贸n del art铆culo 14潞 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 2608, L 2608, F 203, S 8, H PO 5169, I/A 34 (30.09.20).

24 de Enero de 2019
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA DEL PUERTO DE VI. Datosregistrales. T 2608, L 2608, F 203, S 8, H PO 5169, I/A 33 (15.01.19).

22 de Enero de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 73.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 153.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 147.000,00 Euros. Desembolsado: 147.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.000,00 Euros. Resultante Desembolsado:300.000,00 Euros. Datos registrales. T 2608, L 2608, F 202, S 8, H PO 5169, I/A 32 (14.01.19).

09 de Julio de 2018
Nombramientos. Auditor: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 2608, L 2608, F202, S 8, H PO 5169, I/A 31 ( 2.07.18).

15 de Marzo de 2018
Reelecciones. Consejero: GONZALEZ GARCIA HUGO CRISANTO. Secretario: GONZALEZ GARCIA HUGO CRISANTO. Datosregistrales. T 2608, L 2608, F 202, S 8, H PO 5169, I/A 30 ( 7.03.18).

27 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ DE LA TORRE ALFONSO;AGRAFOJO COSTAS HERMINIO;VIDAL COMESA脩A ANTONIO.Datos registrales. T 2608, L 2608, F 201, S 8, H PO 5169, I/A 29 (17.10.17).

24 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: GUISANDE COSTAS JAIME. Apo.Manc.: GUISANDE COSTAS JAIME. Nombramientos. Apo.Manc.:GUISANDE COSTAS JAIME. Apo.Sol.: GUISANDE COSTAS JAIME. Datos registrales. T 2608, L 2608, F 200, S 8, H PO 5169, I/A28 (17.10.17).

28 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO MANUEL;ROTEA ARAUJO MARIA DEL PILAR. Secretario:VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO MANUEL. Nombramientos. Consejero: ULLOA ALONSO EDELMIRO;ROMON OLEA JORGE.Datos registrales. T 2608, L 2608, F 200, S 8, H PO 5169, I/A 26 (20.07.17).

Nombramientos. Secretario: GONZALEZ GARCIA HUGO CRISANTO. Datos registrales. T 2608, L 2608, F 200, S 8, H PO 5169,I/A 27 (20.07.17).

18 de Noviembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: FUERTES GAMUNDI JOSE RAMON. Vicepresid.: FUERTES GAMUNDI JOSE RAMON.Nombramientos. Consejero: SUAREZ-LLANOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO. Vicepresid.: SUAREZ-LLANOS RODRIGUEZ JOSEANTONIO. Reelecciones. Consejero: TOUZA TOUZA FRANCISCO JAVIER;ROTEA ARAUJO MARIA DEL PILAR. Presidente:TOUZA TOUZA FRANCISCO JAVIER. Modificaci贸n de poderes. Apo.Manc.: GUISANDE COSTAS JAIME. Datos registrales. T2608, L 2608, F 199, S 8, H PO 5169, I/A 25 (10.11.16).

17 de Febrero de 2016
Modificaci贸n de poderes. Apo.Manc.: GUISANDE COSTAS JAIME. Datos registrales. T 2608, L 2608, F 198, S 8, H PO 5169, I/A24 ( 8.02.16).

07 de Octubre de 2015
Revocaciones. Gerente: SAN PEDRO AINSE LUIS. Datos registrales. T 2608, L 2608, F 198, S 8, H PO 5169, I/A 23 (30.09.15).

04 de Septiembre de 2015
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO MANUEL. Consejero: MARTINEZ LLANOS JOSE CARLOS.Nombramientos. Consejero: VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO MANUEL. Secretario: VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSOMANUEL. Datos registrales. T 2608, L 2608, F 197, S 8, H PO 5169, I/A 22 (27.08.15).

23 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: IGLESIAS PRIETO REINALDO. Nombramientos. Consejero: GUISANDE COSTAS JAIME.Modificaci贸n de poderes. Apo.Manc.: GUISANDE COSTAS JAIME. Datos registrales. T 2608, L 2608, F 196, S 8, H PO 5169, I/A21 (15.04.13).

10 de Noviembre de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 73.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 226.500,00 Euros. Datos registrales. T 2608, L2608, F 196, S 8, H PO 5169, I/A 20 (26.10.11).

16 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: FUERTES GAMUNDI JOSE RAMON;IGLESIAS PRIETO REINALDO;MARTINEZ LLANOS JOSECARLOS;ROTEA ARAUJO MARIA DEL PILAR. Presidente: FUERTES GAMUNDI JOSE RAMON. Consejero: TOUZA TOUZAFRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: TOUZA TOUZA FRANCISCO JAVIER. Presidente: TOUZA TOUZA FRANCISCOJAVIER. Consejero: FUERTES GAMUNDI JOSE RAMON. Vicepresid.: FUERTES GAMUNDI JOSE RAMON. Consejero: IGLESIASPRIETO REINALDO;ROTEA ARAUJO MARIA DEL PILAR;MARTINEZ LLANOS JOSE CARLOS. Reelecciones. SecreNoConsj:VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO MANUEL. Datos registrales. T 2608, L 2608, F 195, S 8, H PO 5169, I/A 18 ( 5.09.11).

Revocaciones. Apo.Manc.: GUISANDE COSTAS JAIME. Apo.Sol.: GUISANDE COSTAS JAIME. Nombramientos. Apo.Manc.:GUISANDE COSTAS JAIME. Apo.Sol.: GUISANDE COSTAS JAIME. Datos registrales. T 2608, L 2608, F 195, S 8, H PO 5169, I/A19 ( 5.09.11).

20 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: CENICEROS GALLEGO TEOFILO ANGEL;SILVA PEREZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 2608, L2608, F 195, S 8, H PO 5169, I/A 17 (10.05.10).

09 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GORDEJUELA AGUILAR RAMIRO. Nombramientos. Consejero: TOUZA TOUZA FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 663, L 663, F 210, S 8, H PO 5169, I/A 16 (25.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n