Buscador CIF Logo

Actos BORME Elix Rehabilitacion Y Construccion Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Elix Rehabilitacion Y Construccion Sl

Actos BORME Elix Rehabilitacion Y Construccion Sl - B65272924

Tenemos registrados 28 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Elix Rehabilitacion Y Construccion Sl con CIF B65272924

🔙 Perfil de Elix Rehabilitacion Y Construccion Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Elix Rehabilitacion Y Construccion Sl

13 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apoderado: MURTRA FERRER-DALMAU GABRIELA. Datos registrales. T 40691 , F 98, S 8, H M 722053, I/A 8 (5.10.22).

20 de Diciembre de 2021
Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 51 4º D (MADRID). Datos registrales. T 40691 , F 98, S 8, H M 722053, I/A 7(13.12.21).

25 de Octubre de 2021
Revocaciones. Apoderado: GARCIA AGUSTIN JUAN ANDRES. Otros conceptos: Revocado el poder conferido a Don Fernandode Diego García, mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Pablo Ramallo Taboada, bajo en número 912/2020Revocado el poder conferido a Doña Marta Gomez Gil , otorgado mediante escritura autorizada ante el Notario de Madrid, Don PabloRamallo Taboada, bajo el número 911/2020. Datos registrales. T 40691 , F 98, S 8, H M 722053, I/A 6 (18.10.21).

20 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apoderado: VILLA MARTINEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 40691 , F 95, S 8, H M 722053, I/A 4 (13.10.21).

Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ MARIN ISABEL. Datos registrales. T 40691 , F 97, S 8, H M 722053, I/A 5 (13.10.21).

23 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apoderado: MARZO PELIGERO MARIA TERESA. Datos registrales. T 40691 , F 93, S 8, H M 722053, I/A 3(16.08.21).

15 de Diciembre de 2020
Cambio de domicilio social. C/ MONTESA 35 - ESCALERA DERECHA, 4º DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 40691 , F93, S 8, H M 722053, I/A 2 ( 9.12.20).

15 de Junio de 2020
Nombramientos. APODERAD.SOL: DE DIEGO GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 46890 , F 193, S 8, H B 394820, I/A 21 (5.06.20).

Nombramientos. APODERAD.SOL: MURTRA FERRER DALMAU GABRIELA;GOMEZ GIL MARTA. Datos registrales. T 46890 , F193, S 8, H B 394820, I/A 20 ( 5.06.20).

Revocaciones. APODERAD.SOL: INFANTES GARCA CARLOS LUIS;GINE GRAS NEUS. Datos registrales. T 46890 , F 192, S 8,H B 394820, I/A 18 ( 5.06.20).

Nombramientos. APODERAD.SOL: GARCIA AGUSTIN JUAN ANDRES. Datos registrales. T 46890 , F 192, S 8, H B 394820, I/A19 ( 5.06.20).

11 de Marzo de 2020
Revocaciones. APODERAD.SOL: JARIA PANTANO ABEL. Datos registrales. T 46890 , F 192, S 8, H B 394820, I/A 17 ( 3.03.20).

18 de Junio de 2019
Nombramientos. APODERAD.SOL: JARIA PANTANO ABEL. Datos registrales. T 46890 , F 192, S 8, H B 394820, I/A 16 ( 6.06.19).

03 de Junio de 2019
Nombramientos. APODERAD.SOL: INFANTES GARCA CARLOS LUIS. Datos registrales. T 41730 , F 184, S 8, H B 394820, I/A 12(24.05.19).

Nombramientos. APODERAD.SOL: REQUENA ROMERO LAURA. Datos registrales. T 41730 , F 185, S 8, H B 394820, I/A 13

Nombramientos. APODERAD.SOL: GINE GRAS NEUS. Datos registrales. T 46890 , F 191, S 8, H B 394820, I/A 14 (24.05.19).

Revocaciones. APODERADO: GARCIA LOPEZ JOAQUIN. APODERAD.SOL: REQUENA ROMERO LAURA. Datos registrales. T46890 , F 191, S 8, H B 394820, I/A 15 (24.05.19).

05 de Marzo de 2019
Revocaciones. APODERAD.SOL: OJESTO VALLINA PEDRO PASCUAL. Datos registrales. T 41730 , F 184, S 8, H B 394820, I/A11 (25.02.19).

19 de Febrero de 2019
Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO: ELIX VENTURES SL. Datos registrales. T 41730 , F 184, S 8, H B394820, I/A 10 (11.02.19).

27 de Octubre de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: REQUENA ROMERO LAURA. Datos registrales. T 41730 , F 182, S 8, H B 394820, I/A 7(19.10.17).

Nombramientos. APODERAD.SOL: GUILLEN DOMINGUEZ DAVID;ESCOFET PUY DANIEL. Datos registrales. T 41730 , F 182, S8, H B 394820, I/A 8 (19.10.17).

Nombramientos. APODERAD.SOL: OJESTO VALLINA PEDRO PASCUAL. Datos registrales. T 41730 , F 184, S 8, H B 394820,I/A 9 (19.10.17).

25 de Febrero de 2015
Cambio de domicilio social. PJ PERMANYER Num.19 (BARCELONA). Datos registrales. T 41730 , F 181, S 8, H B 394820, I/A 6(18.02.15).

31 de Agosto de 2011
Revocaciones. ADM.UNICO: ELIX CADIZ SERVICIOS INMOBILIARIOS SL. REPR.143 RRM: BENJUMEDA PEÑAFIEL JORGE.Nombramientos. ADM.UNICO: ELIX SERVICIOS INMOBILIARIOS SL. REPR.143 RRM: BENJUMEDA PEÑAFIEL JORGE. Datosregistrales. T 41730 , F 181, S 8, H B 394820, I/A 5 (17.08.11).

12 de Enero de 2011
Otros conceptos: SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "ELIX SERVICIOS INMOBILIARIOS SL". Datos registrales. T41730 , F 181, S 8, H B 394820, I/A 4 (29.12.10).

16 de Marzo de 2010
Nombramientos. APODERADO: GARCIA LOPEZ JOAQUIN. Datos registrales. T 41730 , F 179, S 8, H B 394820, I/A 2 ( 3.03.10).

Nombramientos. APODERADO: LACASA GONZALEZ JAIME. Datos registrales. T 41730 , F 180, S 8, H B 394820, I/A 3 ( 3.03.10).

10 de Marzo de 2010
Constitución. Comienzo de operaciones: 15.01.10. Objeto social: LACONSTRUCCION,REHABILITACION,ADMINISTRACION,DECORACION Y EXPLOTACION DE INMUEBLES Y SU POSTERIORVENTA EN BLOQUE O POR DEPARTAMENTOS Y/O PARTICIPACIONES INDIVISAS,SU ARRENDAMIENTO ACTIVO NOFINANCIERO,ETC. Domicilio: CL BALMES Num.167 P.2 PTA.2 (BARCELONA). Capital: 3.010,00 Euros. Nombramientos.ADM.UNICO: ELIX CADIZ SERVICIOS INMOBILIARIOS SL. REPR.143 RRM: BENJUMEDA PEÑAFIEL JORGE. Otros conceptos:DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO ELIX CADIZ SERVICIOS INMOBILIARIOS SL. Datosregistrales. T 41730 , F 176, S 8, H B 394820, I/A 1 (25.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información