Actos BORME de Elmya Sa
07 de Febrero de 2023Otros conceptos: REVOCADOS los poderes NO INSCRITOS conferidos a favor de doña Rosario del Rocío Pérez García y doñaMaría del Rocío Morales Gómez mediante escritura otorgada en Sevilla, ante su notario don Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi, el día 29de marzo de 2021, número 1.854 de su protocolo.- Datos registrales. T 5020 , F 79, S 8, H SE 4480, I/A 42 (31.01.23).
Nombramientos. Apoderado: OLLERO ROSETY MACARENA. Datos registrales. T 7336 , F 34, S 8, H SE 4480, I/A 43 (31.01.23).
30 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 5020 , F 79, S 8, H SE 4480, I/A 41 (18.01.23).
24 de Enero de 2023Reducción de capital. Importe reducción: 12.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 108.200,00 Euros. Reducción de capital. Importereducción: 11.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 96.400,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capitalsocial.-. Escisión parcial. Sociedades beneficiarias de la escisión: ELMYA HOLDCO SOCIEDAD LIMITADA. ELMYA IBERIAINDUSTRIAL SERVICES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5020 , F 72, S 8, H SE 4480, I/A 40 (18.01.23).
17 de Mayo de 2022Declaración de unipersonalidad. Socio único: ELMYA HOLDCO SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5020 , F 72, S 8, HSE 4480, I/A 39 ( 6.05.22).
11 de Marzo de 2022Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 5020 , F 72, S 8, H SE 4480, I/A 38 ( 2.03.22).
04 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMOS GARRIDO DANIEL. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO.Modificaciones estatutarias. 20. Retribucion. Datos registrales. T 5485 , F 45, S 8, H SE 4480, I/A 37 (27.01.22).
17 de Agosto de 2021Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 3º. Cambio de domicilio social. C/ AVIACION 14 - EDIFICIOMORERA II, PLANTA BAJA (SEVILLA). Datos registrales. T 5485 , F 45, S 8, H SE 4480, I/A 36 (10.08.21).
09 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. D. Gerente: RAMOS GARRIDO ALBERTO. Revocaciones. Apoderado: MONTES FERNANDEZ JUANENRIQUE;SANCHEZ MANCHEÑO ANDRES. Apo.Sol.: PIÑAR CELESTINO JOSE MARIA;RAMOS GARRIDO ALBERTO. Apoderado:PIÑAR CELESTINO JOSE MARIA. Apo.Sol.: PIÑAR CELESTINO JOSE MARIA;RAMOS GARRIDO ALBERTO. Apoderado: RAMOSGARRIDO ALBERTO. Apo.Sol.: RAMOS GARRIDO DANIEL;PIÑAR CELESTINO CARLOS. Apoderado: RAMOS GARRIDOALBERTO. Datos registrales. T 5485 , F 43, S 8, H SE 4480, I/A 34 (27.11.20).
Nombramientos. Apo.D.Gral.: PIÑAR CELESTINO CARLOS. Dir. General: PIÑAR CELESTINO CARLOS. Datos registrales. T 5485, F 44, S 8, H SE 4480, I/A 35 (27.11.20).
30 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMOS GARRIDO ALBERTO. Secretario: RAMOS GARRIDO ALBERTO. Nombramientos.Secretario: PIÑAR CELESTINO CARLOS. Reelecciones. Presidente: PIÑAR CELESTINO JOSE MARIA. Datos registrales. T 5485, F 43, S 8, H SE 4480, I/A 33 (21.10.20).
10 de Agosto de 2020Nombramientos. Con.Delegado: PIÑAR CELESTINO JOSE MARIA. Datos registrales. T 5485 , F 43, S 8, H SE 4480, I/A 32(29.07.20).
25 de Marzo de 2020Reelecciones. Consejero: PIÑAR CELESTINO JOSE MARIA;RAMOS GARRIDO DANIEL;PIÑAR CELESTINO CARLOS;RAMOSGARRIDO ALBERTO. Presidente: PIÑAR CELESTINO JOSE MARIA. Secretario: RAMOS GARRIDO ALBERTO. Datos registrales. T5485 , F 42, S 8, H SE 4480, I/A 30 (16.03.20).
Nombramientos. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 5485 , F 42, S 8, H SE 4480, I/A 31 (16.03.20).
03 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apoderado: RAMOS GARRIDO ALBERTO. Datos registrales. T 5485 , F 42, S 8, H SE 4480, I/A 29 (27.08.19).
04 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 5485 , F 41, S 8, H SE 4480, I/A 28 (26.12.18).
26 de Noviembre de 2015Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 5485 , F 41, S 8, H SE 4480, I/A 27 (17.11.15).
01 de Julio de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: RAMOS GARRIDO DANIEL;PIÑAR CELESTINO CARLOS. Datos registrales. T 5485 , F 40, S 8, H SE4480, I/A 26 (24.06.15).
22 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: PIÑAR PARIAS JOSE MARIA;RAMOS RODRIGUEZ RAFAEL;RAMOS GARRIDO DANIEL;PIÑARCELESTINO JOSE MARIA. Presidente: PIÑAR PARIAS JOSE MARIA. Secretario: RAMOS RODRIGUEZ RAFAEL. Cons.Del.Sol:PIÑAR PARIAS JOSE MARIA;RAMOS RODRIGUEZ RAFAEL. Nombramientos. Consejero: PIÑAR CELESTINO JOSEMARIA;RAMOS GARRIDO DANIEL;PIÑAR CELESTINO CARLOS;RAMOS GARRIDO ALBERTO. Presidente: PIÑAR CELESTINOJOSE MARIA. Secretario: RAMOS GARRIDO ALBERTO. Con.Delegado: PIÑAR CELESTINO JOSE MARIA. Modificacionesestatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-. MODIFICA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS SOCIALES PARA ADECUARLOS ALA LEGISLACION VIGENTE.-. Ampliacion del objeto social. Ampliado a la proyección y ejecución de obra civil, así como laactividad de implantación de sistemas de gestión energética y ejecución de dichos proyectos, las auditorías energéticas, y estudios deeficiencia y optimización energética.- Datos registrales. T 5485 , F 38, S 8, H SE 4480, I/A 24 (13.05.15).
Nombramientos. Apoderado: RAMOS GARRIDO ALBERTO. D. Gerente: RAMOS GARRIDO ALBERTO. Datos registrales. T 5485, F 40, S 8, H SE 4480, I/A 25 (13.05.15).
10 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: PIÑAR PARIAS JOSE MARIA;RAMOS RODRIGUEZ RAFAEL. Nombramientos. Cons.Del.Sol:PIÑAR PARIAS JOSE MARIA;RAMOS RODRIGUEZ RAFAEL. Reelecciones. Consejero: PIÑAR PARIAS JOSE MARIA;RAMOSRODRIGUEZ RAFAEL;RAMOS GARRIDO DANIEL;PIÑAR CELESTINO JOSE MARIA. Presidente: PIÑAR PARIAS JOSE MARIA.Secretario: RAMOS RODRIGUEZ RAFAEL. Datos registrales. T 5485 , F 37, S 8, H SE 4480, I/A 23 (29.08.14).
05 de Noviembre de 2012Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 5485 , F 36, S 8, H SE 4480, I/A 22 (23.10.12).
28 de Febrero de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: PIÑAR CELESTINO JOSE MARIA;RAMOS GARRIDO ALBERTO. Datos registrales. T 1429, L 1, F 134,S 8, H SE 4480, I/A 21 (16.02.12).
06 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: PIÑAR CELESTINO JOSE MARIA. Datos registrales. T 1429, L 1, F 134, S 8, H SE 4480, I/A 20(23.05.11).
16 de Abril de 2010Modificaciones estatutarias. 1. Denominación.-MODIFICACION TOTAL ESTATUTOS. Datos registrales. T 1429, L 1, F 131, S 8,H SE 4480, I/A 19 ( 6.04.10).
22 de Febrero de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: PIÑAR CELESTINO JOSE MARIA;RAMOS GARRIDO ALBERTO. Datos registrales. T 1429, L 1, F 130,S 8, H SE 4480, I/A 18 ( 9.02.10).
11 de Enero de 2010Otros conceptos: CONSTANCIA DE LA EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO FAMILIAR en la Sociedad "ELMYA,S.A." Datosregistrales. T 1429, L 1, F 130, S 8, H SE 4480, I/A 17 b (23.12.09).
29 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: PIÑAR PARIAS JOSE MARIA. Presidente: PIÑAR PARIAS JOSE MARIA. Consejero: RAMOSRODRIGUEZ RAFAEL. Secretario: RAMOS RODRIGUEZ RAFAEL. Consejero: RAMOS GARRIDO DANIEL;PIÑAR CELESTINOJOSE MARIA. Cons.Del.Sol: RAMOS RODRIGUEZ RAFAEL;PIÑAR PARIAS JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: PIÑARPARIAS JOSE MARIA;RAMOS RODRIGUEZ RAFAEL;RAMOS GARRIDO DANIEL;PIÑAR CELESTINO JOSE MARIA. Presidente:PIÑAR PARIAS JOSE MARIA. Secretario: RAMOS RODRIGUEZ RAFAEL. Cons.Del.Sol: PIÑAR PARIAS JOSE MARIA;RAMOSRODRIGUEZ RAFAEL. Datos registrales. T 1429, L 1, F 130, S 8, H SE 4480, I/A 17 (14.10.09).