Actos BORME de Ematra Sl
20 de Agosto de 2021Revocaciones. Apoderado: HIDALGO YAMUZA RICARDO. Datos registrales. T 2369 , F 45, S 8, H CA 6155, I/A 33 (12.08.21).
26 de Marzo de 2021Nombramientos. Auditor: EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE ANDALUCIA. Datos registrales. T 2369 , F 45, S8, H CA 6155, I/A 32 (12.03.21).
26 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apoderado: ZAPATA MINGORANCE FRANCISCO IGNACIO;ZAPATA MINGORANCE FRANCISCO IGNACIO.Datos registrales. T 2121 , F 117, S 8, H CA 6155, I/A 30 (13.11.20).
Nombramientos. Apoderado: HIDALGO YAMUZA RICARDO. Datos registrales. T 2369 , F 44, S 8, H CA 6155, I/A 31 (13.11.20).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: ZAPATA MINGORANCE FRANCISCO IGNACIO. Datos registrales. T 2121 , F 117, S 8, H CA 6155,I/A 29 (20.03.19).
23 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: ZAPATA MINGORANCE FRANCISCO IGNACIO. Datos registrales. T 2121 , F 116, S 8, H CA 6155,I/A 28 (15.01.19).
20 de Diciembre de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 101,21 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:26.068,00 Euros. Resultante Suscrito: 86.068,00 Euros. Otros conceptos: Reducir el valor nominal de las participaciones de 60euros a 1 euro, con consiguiente multiplicaci贸n de su n煤mero de 100 a 60.000 participaciones. Datos registrales. T 2121 , F 116, S 8,H CA 6155, I/A 27 (11.12.18).
12 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ REAL INES CRISTINA. Nombramientos. Adm. Unico: REAL GOMEZ CRISTINA.Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 15潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 2121 , F115, S 8, H CA 6155, I/A 25 ( 4.12.18).
Revocaciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Nombramientos. Auditor: ARNAUDIT SLP. Datos registrales. T 2121 , F115, S 8, H CA 6155, I/A 26 ( 4.12.18).
05 de Julio de 2018Revocaciones. Auditor: AVANTER AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales.T 2121 , F 115, S 8, H CA 6155, I/A 24 (28.06.18).
04 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: HIDALGO YAMUZA RICARDO;REAL GOMEZ CRISTINA. Datos registrales. T 2121 , F 114, S 8, HCA 6155, I/A 23 (24.04.18).
28 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: MARTIN RIAZA JUAN ANTONIO;MARTIN TOLEDO MARIA DEL CARMEN;MARTIN TOLEDO MARIAJESUS. Apoderado: FUENTES RIQUELME LUIS ENRIQUE;FUENTES RIQUELME LUIS ENRIQUE;FUENTES RIQUELME LUISENRIQUE. Datos registrales. T 2121 , F 113, S 8, H CA 6155, I/A 21 (21.02.18).
Nombramientos. Apoderado: REAL GOMEZ CRISTINA. Datos registrales. T 2121 , F 114, S 8, H CA 6155, I/A 22 (21.02.18).
27 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ GUILLEN JULIO JOSE. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ REAL INESCRISTINA. Datos registrales. T 2121 , F 113, S 8, H CA 6155, I/A 20 (18.12.17).
24 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ GUILLEN JULIO;MARTIN RIAZA JUAN ANTONIO;CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO.Secretario: MARTIN RIAZA JUAN ANTONIO. Presidente: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Revocaciones. Apoderado: CAMPOSMARTINEZ SANTIAGO. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ GUILLEN JULIO JOSE. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 2121 , F 113, S 8, H CA 6155, I/A19 (16.11.16).
20 de Abril de 2016Modificaciones estatutarias. ARTICULO 15. RESUMEN. Datos registrales. T 2121 , F 112, S 8, H CA 6155, I/A 18 (11.04.16).
04 de Abril de 2016Nombramientos. Auditor: AVANTER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2121 , F 112, S 8, H CA 6155, I/A 17 (23.03.16).
17 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apoderado: FUENTES RIQUELME LUIS ENRIQUE. Datos registrales. T 2121 , F 112, S 8, H CA 6155, I/A 16 (6.11.14).
09 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ SANCHEZ MANUEL. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ GUILLENJULIO;MARTIN RIAZA JUAN ANTONIO;CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Presidente: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Secretario:MARTIN RIAZA JUAN ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aConsejo de administraci贸n. Datos registrales. T 2121 , F 111, S 8, H CA 6155, I/A 15 ( 1.10.14).
26 de Junio de 2014Nombramientos. Apoderado: FUENTES RIQUELME LUIS ENRIQUE. Datos registrales. T 938 , F 46, S 8, H CA 6155, I/A 14(17.06.14).
16 de Junio de 2014Nombramientos. Apoderado: FUENTES RIQUELME LUIS ENRIQUE. Datos registrales. T 938 , F 45, S 8, H CA 6155, I/A 13 (9.06.14).
24 de Febrero de 2014Revocaciones. Apoderado: MORAL CABEZA VICENTE. Datos registrales. T 938 , F 44, S 8, H CA 6155, I/A 11 (13.02.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN RIAZA JUAN ANTONIO;MARTIN TOLEDO MARIA DEL CARMEN;MARTIN TOLEDO MARIAJESUS. Datos registrales. T 938 , F 44, S 8, H CA 6155, I/A 12 (13.02.14).
24 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Datos registrales. T 938 , F 43, S 8, H CA 6155, I/A 10 (16.12.13).
22 de Mayo de 2013Modificaciones estatutarias. ARTICULO 15潞.- RESUMEN. Datos registrales. T 938 , F 43, S 8, H CA 6155, I/A 9 (14.05.13).