Actos BORME de Embalajes Vicarton Sl
21 de Marzo de 2022Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1066/205. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 25/02/2022. Auto de aprobaci贸n del plande liquidaci贸n. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS.Resoluciones: Se aprueba el plan de liquidaci贸n presentado por la administraci贸n concursal. Situaci贸n concursal. Procedimientoconcursal 1066/205. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 25/02/2022. Auto de formaci贸n de la secci贸n de calificaci贸n. Juzgado: num. 0JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS. Resoluciones: Formacion de laseccion sexta de calificacion. Datos registrales. T 26932 , F 50, S 8, H M 485324, I/A A (14.03.22).
07 de Abril de 2016Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1066/205. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 4/02/2016. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 1066/205. Fecha de resoluci贸n 4/02/2016. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Administrador Concursal. Fecha 4/02/2016, NIF/CIF03856529G. ALVAREZ GARCIA MARCOS. Datos registrales. T 26932 , F 50, S 8, H M 485324, I/A 8 (29.03.16).
11 de Junio de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 151.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Datos registrales. T 26932 , F 49,S 8, H M 485324, I/A 7 ( 3.06.15).
12 de Septiembre de 2014Nombramientos. Adm. Solid.: GARCIA PRIETO LUIS JAVIER. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 40.000,00 Euros.Resultante Suscrito: 154.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T26932 , F 49, S 8, H M 485324, I/A 6 ( 2.09.14).
15 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: OLIER BELLON MANUEL. Datos registrales. T 26932 , F 49, S 8, H M 485324, I/A 5 ( 7.07.14).
24 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GARCIA PULMARI脩O AUGUSTO. Consejero: GARCIA PULMARI脩O AUGUSTO;GUTIERREZJUSTINIANO REINA MARIA;OLIER BELLON MANUEL. Presidente: OLIER BELLON MANUEL. Secretario: GUTIERREZ JUSTINIANOREINA MARIA. Nombramientos. Adm. Solid.: GARCIA PULMARI脩O AUGUSTO;OLIER BELLON MANUEL. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T26932 , F 48, S 8, H M 485324, I/A 4 (10.11.10).
17 de Noviembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 122.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 194.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales. T 26932 , F 48, S 8, H M 485324, I/A 3 ( 3.11.10).
02 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MO脩INO NOVILLO PABLO. Consejero: MO脩INO NOVILLO PABLO. Nombramientos.Con.Delegado: GARCIA PULMARI脩O AUGUSTO. Reelecciones. Consejero: GARCIA PULMARI脩O AUGUSTO;GUTIERREZJUSTINIANO REINA MARIA;OLIER BELLON MANUEL. Presidente: OLIER BELLON MANUEL. Secretario: GUTIERREZ JUSTINIANOREINA MARIA. Datos registrales. T 26932 , F 48, S 8, H M 485324, I/A 2 (23.09.09).
18 de Agosto de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 9.07.09. Objeto social: 1.- MANUFACTURA, ELABORACION Y COMERCIALIZACION DEEMBALAJES Y PIEZAS DE CARTON Y PAPEL. 2.- COMPRA-VENTA E INTERMEDIACION DE PRODUCTOS DE CARTON YOTROS MATERIALES RELACIONADOS CON EL EMBALAJE Y LA ESTUCHERIA. Domicilio: C/ PUERTO DE GUADARRAMA 16-18(MOSTOLES). Capital: 72.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: GARCIA PULMARI脩O AUGUSTO;GUTIERREZ JUSTINIANOREINA MARIA;OLIER BELLON MANUEL;MO脩INO NOVILLO PABLO. Presidente: OLIER BELLON MANUEL. Secretario: GUTIERREZJUSTINIANO REINA MARIA. Con.Delegado: MO脩INO NOVILLO PABLO. Datos registrales. T 26932 , F 46, S 8, H M 485324, I/A 1 (7.08.09).